202. $ 108,200.00 § W I- T
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
January 4, 1965. 1-65 Minures Approved Proceedings of a Regular
LUCERNE January 4, 1965. Proceedings of a regular meeting of the Munici- pality of Lucerne, held on January 4, 1965 at the hour of 8:00 p.m., the following being present: His Worship Mayor Gaston Isabelle, M.D., Councillors J.M. McLean, P.L.^ Michel, C.B. Watt, E.J. Sivyer and A.R. Bailey. 1-65 The Minutes of the meeting of December 7, 1964 were unani- MINUrES Approved mously approved by Council on motion MOVED by Councillor C.B. Watt, SECONDED by Councillor P.L. Michel. Builiing Permits Councillor E.J. Sivyer gave a report on the Building Permits Report from December 1963 to December 1, 1964. There were 230 permits issued for a total value of $4,106,967.00. Of the 230 permits granted, 100 were for single dwellings, 67 for multiple dwellings for a total of 307 family units; 55 for additions and other construction and 8 for commercial buildings. 2-65 Accounts, totalling $20,998.78, were unanimously approved by Accounts apprv'd. Council, on motion MOVED by Councillor P.L. Michel, SECONDED by Coun- cillor A.R. Bailey. 3-65 The following Tax Collections and Business Licences write- Tax Collections offs were unanimously approved by Council, on motion MOVED by Councilloi & Business Lie- C.B. Watt, SECONDED by Councillor E.J. Sivyer: «i a3 ences Write-offs e TAX COLLECTIONS WRITE-OFFS h| PS g 1963 PENALTY - CHARGED IN ERROR - Write-off overlooked at end of 1963. G. Archambault $ 3.58 Y. Quesnel .05 g< s§s s „ A. Quintal 6.12 $ 9.75 1963 BUILDING TO BE TAXED FOR PART YEAR BEAUCHEMIN, G. -
Rspi Ä Ex LIBRIS UNIVERSITATIS ALBERTENSIS
rSPi AAAA Ex LIBRIS UNIVERSITATIS Ä ALBERTENSIS u r n m FOR LIBRARY USE FtP O N LY.-' p1l 'S 4 i m i : é i6 comptes publics de la province de québec pour l’année financière terminée le 31 mars 1975 : I public accounts of the province of quebec for the fiscal year ended March 31, 1975 volume 2 détail des dépenses details of expenditures préparés sous l’autorité du ministre des finances prepared under the authority of the minister of finance Blibliothèque nationale du Québec. UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF AI TABLE DES MATIÈRES TABLE OF CONTENTS SECTION SECTION LISTE DES FOURNISSEURS ET BÉNÉFICIAIRES 1 LIST OF SUPPLIERS AND BENEFICIARIES 1 LISTE DES BIENS EN CAPITAL 2 LIST OF CAPITAL ASSETS 2 SECTION LISTE DES FOURNISSEURS LIST OF SUPPLIERS ET BÉNÉFICIAIRES AND BENEFICIARIES La liste des fournisseurs et bénéficiaires pour chaque catégorie The list of suppliers and beneficiaries is published grouped by de dépenses est publiée au niveau du ministère et selon les category of expenditure for each department, according to the modalités suivantes: following criteria: a) Traitements et salaires — ministres, sous-ministres et haut- (a) Salaries and wages — Ministers, Deputy Ministers and fonctionnaires de rang équivalent: tout montant; autres fonc Public Officers of equal rank: complete listing; other employees tionnaires: $22 000 et plus. Toute allocation: $5 000 et plus; $22 000 and over. Any allowance: $5 000 and over, b) Services de transport et de communication: (b) Transportation and communications services: Frais de déplacement: $2 500 -
Ex LIBRIS UNIVERSITATIS ALBERTENSIS I ¿ T O F Pe, P*J P7l 1777- 7^ Gouvernement Du Québec Public Accounts for the Fiscal Year Ended March 31, 1978
Ex LIBRIS UNIVERSITATIS ALBERTENSIS I ¿ t o f Pe, P*J P7l 1777- 7^ gouvernement du Québec public accounts for the fiscal year ended March 31, 1978 volume 2 details of expenditure Published in accordance with the provisions of section 71 of the Loi de l’administration financière (Financial Administration Act) (1970 Statutes, Chapter 17) Received MAÏ 2? 1575 RECTOR 4 Gouvernement ELLOR du Québec Ministère des Finances ISSN 0706-2850 ISBN 0-7754-3205-9 Legal deposit, 1s' quarter, 1979 Bibliothèque nationale du Québec UNIVERSITY LIERARY UNIVERSITY OF Al BFRTA TABLE OF CONTENTS SECTION LIST OF SUPPLIERS AND BENEFICIARIES 1 LIST OF CAPITAL ASSETS 2 1-1 SECTION LIST OF SUPPLIERS AND BENEFICIARIES For each category of expenditure, except for "Transfer expen With regard to the category "Transfer expenses", the list of ses", the list of suppliers or beneficiaries is issued by department beneficiaries is published, in certain cases, grouped by program according to the following publishing limits and criteria: or by element of program and, in other cases, grouped by department, and this, according to the following limits and crite a) Salaries, wages, allowances and other remuneration: ria: — Ministers, Deputy Ministers and Public Officers of equiva — By electoral district: complete listing; lent rank: complete listing; — By electoral district and beneficiary: complete listing; — Managerial Staff (managers, assistant managers and civil servants of equivalent rank): complete listing; — By beneficiary only: $8 000 and over. — Any allowance: $8 000 -
Comptes Publics De La Province De Québec
QUEBEC comptes publics de la province de québec public accounts of the province of québec = for the fiscal year ended March 31, 1974 un ” volume 2 + ; I F5 Al détail des dépenses I C6/ 1 9 7 3 -7 4 details of expenditures 9 . 2 MF L Tj. «■ comptes publics de la province de québec pour l’année financière terminée le 31 mars 1974 « . i h a o UO*T QUÉBEC ♦ public accounts of the province of québec for the fiscal year ended March 31, 1974 volume 2 détail des dépenses details of expenditures préparés sous l’autorité du ministre des finances prepared under the authority of the minister of finance TAOU oedèuO L-be u pèiiais < 5 r f t 0 0 C 3 r ' u s o q » ecéSioO ub .!ucd sbenuO ,0buàuD yny c i v i j ; TABLE DES MATIÈRES TABLE OF CONTENTS Section Section Liste des fournisseurs et bénéficiaires................. 1 List of Suppliers and Benefïciaries....................... 1 Liste des biens en capital....................................... 2 List of Capital Assets.............................................. 2 SECTIO N 1 Liste des fournisseurs et bénéficiaires List of Suppliers and Beneficiaries La liste des fournisseurs et bénéficiaires pour chaque The list of suppliers and beneficiaries is published catégorie de dépenses est publiée au niveau du minis grouped by category of expenditure for each départ - tère et selon les modalités suivantes: ment, according to the following criteria: à) Traitements et salaires — ministres, sous-ministres (a) Salaries and wages — Ministère, Deputy Ministère et haut-fonctionnaires: tout montant; autres fonc and Public Officers: complété listing; other em tionnaires: $19,000 et plus. -
The Rotting Heart of Gatineau Park: How and Why the Kingsmere-Meech Lake Privatopia Prevented a National Park Near Canada's Ca
The rotting heart of Gatineau Park: How and why the Kingsmere-Meech Lake privatopia prevented a national park near Canada’s capital by Michael Christopher Lait A thesis submitted to the Faculty of Graduate and Postdoctoral Affairs in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Sociology in Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Arts and Social Sciences Carleton University Ottawa, Ontario © 2017 Michael Christopher Lait Lait (draft do not cite) I Abstract First proposed in 1913, Gatineau Park could have been the first national park east of the Rocky Mountains, the first in Quebec, and the first near-urban national park in Canada. Ultimately, the Quebec government proved unwilling to cede territory to the federal government, and the park proposal was shelved. In 1938, the Mackenzie King government responded to a public campaign organized by local cottagers and the Ottawa Ski Club by establishing the “Gatineau Park.” Newspapers announced the creation of a national park, and the first expropriations were carried out under this pretense. Gatineau Park is a failed national park. This study shows that federal authorities not only proceeded to establish a park without the consent of the Quebec government, they also failed to consolidate territorial control. My analysis addresses the question of how and why this national park failed, and documents the influence of the Meech Lake Association (MLA) and Kingsmere Property Owners’ Association (KPOA) on the park’s creation, development, and management. I argue that the park’s status as a “mixed- use/ownership area” represents a provisional achievement of these property owners’ associations. -
9 Juin Au 19 Décembre 1970
JOURNAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC DU 9 JUIN 1970 AU 19 DÉCEMBRE 1970 DANS LA DIX-NEUVIÈME ANNÉE DU RÈGNE DE SA MAJESTÉ ELIZABETH DEUX ÉTANT LA PREMIÈRE SESSION DE LA VINGT-NEUVIÈNE LÉGISLATURE DE LA PROVINCE DE QUÉBEC Président L'HONORABLE JEAN-NOËL LAVOIE SESSION 1970 Imprimé par ordre de l'Assemblée notionale QUÉBEC 1970 TABLE DES MATIÈRES PAGE Proclamation: Dissolution de la 28e législature V Proclamation: Élections générales, 29 avril 1970 VII Proclamation: Convocation de la 29e législature, 20 mai 1970 IX Proclamation: Convocation de la 29e législature, 9 juin 1970 XI Liste des députés élus aux élections générales du 29 avril 1970 XIII État des travaux de la session XVII Journaux de l'Assemblée nationale 2 Précis des décisions rendues par le président de l'Assemblée nationale 370 Membres du Conseil exécutif et Adjoints parlementaires 372 Haut personnel de l'Assemblée nationale 375 Cadres supérieurs de l'Assemblée nationale 375 Liste alphabétique des districts électoraux et de leurs représentants 377 Liste alphabétique des membres, repartie par district électoral 381 Liste des bills sanctionnés 387 Chapitres des Lois de 1970 394 Index détaillé des bills 395 Index 385 PROCLAMATION Canada, Province de HUGUES LAPOINTE Québec. [L. S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi. À nos très aimés et fidèles conseillers les membres de l'Assemblée nationale du Québec, ainsi qu'à tous ceux que les présentes peuvent concerner, SALUT. PROCLAMATION ATTENDU que sur l'avis du Conseil exécutif de la province de Québec, Nous avons jugé à propos de dissoudre la pré- sente législature de ladite Province; À CES CAUSES, Nous dissolvons par les présentes ladite législature de la province de Québec. -
Roy Ainsi Que Le Secrétaire- Trésorier Cilles A, Dupont
Levée 860-71 Sur propositi on de Monsieur le conseiller Marcel Roy, appuyé par Monsieur le conseiller Raymond Lamoureux il a éb é résolu à l'unanimité que cette assemblée soit et est levée, ADOPTE Gilles A, Dupont Secrétaire-Trésorier 3 Janvier 1972 Premiere séance de l'assemblje régulière du Conseil Municipal tenue en la salle municipale le Sème Jour du mois de Janvier 1972 sous la présidence de Son Honneur Monsieur le Maire Kenneth Lloyd; étaient aussi présents MM les Conseillers Norman Forgie, Raymond Roy, Viateur Houle, Raymond Lamoureux, Marcel Roy ainsi que le Secrétaire- Trésorier Cilles A, Dupont. Etait absente Madame Jeannine Poulin. La prière d'usage fut récitée. Adoption des 1-72 Minutes Sur proposition de Monsieur le conseiller Marcel Roy, appuyé par Monsieur le conseiller Raymond Lamoureux il a été résolu a 1 unanimité que les minutes des assemblées du mois de Décembre soient et sont approuvées telles que rédigées, ADOPTE Eatatxams 2-72 Su\ propositi ori\îe Monsieur conseiller Marcel R</^^appuyê par\Monsieur ^ consei ller^ymond Lamoùreux il a été r\solu^'a\3rhinani- mité^que les mt-nutes des assemblées du ^ ^ - Mutât ions 2-72 Sur proposition de Monsieur le conseiller Marcel Roy, appuyé par Monsieur le conseiller Viateur Houle il a été résolu à l'unanimité que les mutations du mois d'Octobre 1971 soient et sont approuvées tellm que présentées par le Bureau d 'Enregistrement de Maniwaki, Division du Comté de Gatineau. ADOPTE Comptes 3-72 Payables Sur pr opositi on de Monsieur le conseiller Marcel Roy, appuyé Voir comptes par Monsieur le conseiller Viateur Houle que les comptes payables payables après suivants soient et sont approuvés pour paiement et que le Secrétaire- rêsolution Trésorier est autorisé d en émettre les chèques d mesuremesui que les fonds 5-72 sont disponibles, ADOPTE Paiement - 4-72 Ligue de Sacs Sur proposition de Monsieur le conseiller Marcel Roy, avpuyé de Sable Jr. -
Public Acoount for the Fiscal Year Ended March 31 1982
CFF FSA 1 r; / I9SI gouvernement du Québec public accounts for the year ended March 31, 1982 1981 -1982 volume 2 details of expenditure Québec gouvernement du Québec public accounts for the year ended March 31, 1982 volume 2 details of expenditure Published in accordance with the provisions of Section 71 of the Financial Administration Act (R.S.Q., c. A-6 and amendments) Gouvernement du Québec Ministère des Finances ISSN 0706-2869 OFF ISBN 2-551-05223-8 (Complété Edition) ISBN 2-551-05225-4 (Volume 2) F5/I I Legal Deposit — 4th Quarter 1982 cfo/iqsi Bibliothèque nationale du Québec A TABLE OF CONTENTS SECTION LIST OF SUPPLIERS AND BENEFICIARIES 1 LIST OF CAPITAL ASSETS 2 1-1 SECTION LIST OF SUPPLIERS AND BENEFICIARIES For each category of expenditure, except for "Transfer ex- With regard to the category "Transfer expenses", the list of benefi- penses", the list of suppliers or beneficiaries is issued by depart- ciaries is published, in certain cases, grouped by program or by ment according to the following publishing limits and criteria. element of program and, in other cases, grouped by department, and this, according to the following limits and criteria. (a) Salaries, wages, allowances and other rémunération: — By électoral district: complété listing — Mmisters, deputy ministers and public officers of équiva¬ lent rank: complété listing. — By électoral district and beneficiary complété listing — Managerial staff (managers, assistant managers and civil — By beneficiary only: 8 000 $ and over servants of équivalent rank): complété listing NOTES — Any allowance: 8 000 $ and over — Employées contributions: 16 000 $ and over. -
Comptes Publics De La Province De Québec Public Accounts of The
comptes publics de la province de québec de l’année financière terminée le 31 mars 1976 public accounts of the province of quebec for the fiscal year ended March 31, 1976 volume 2 détail des dépenses details of expenditure Publiés conformément aux dispositions de l’article 71 de la — -7 Loi de l’administration financière (chapitre 17 des lois de 1970)' /y/‘ ' h i< A R Published in accordance with the provisions of Secti0rr7l of the Financial Administration Act (1970 Statutes, Chapter^ 17) TABLE DES MATIÈRES TABLE OF CONTENTS SECTION SECTION LISTE DES FOURNISSEURS ET BÉNÉFICIAIRES 1 LIST OF SUPPLIERS AND BENEFICIARIES 1 LISTE DES BIENS EN CAPITAL 2 LIST OF CAPITAL ASSETS 2 ISSN 0382-3091 ISBN 0-7754-2590-7 Dépôt légal, 4e trimestre 1976 Bibliothèque nationale du Québec 1 -1 SECTION LISTE DES FOURNISSEURS LIST OF SUPPLIERS ET BÉNÉFICIAIRES AND BENEFICIARIES Pour chaque catégorie de dépenses, sauf « Dépenses de For each category of expenditure, except “Transfer expenses", transfert », la liste des fournisseurs ou bénéficiaires est émise au the list of suppliers or beneficiaries is issued by department niveau du ministère selon les normes de publication suivantes: according to the following publishing standards: a) Traitements et salaires — ministres, sous-ministres et haut (a) Salaries and wages — Ministers, Deputy Ministers and fonctionnaires de rang équivalent: tout montant; autres fonc Public Officers of equal rank: complete listing: other em tionnaires: $26 000 et plus. Toute allocation: $7 000 et plus; ployees: $26 000 and over. Any allowance: $7 000 and over; b) Services de transport et de communication: (b) Transportation and communications services: Frais de déplacement: $3 500 et plus. -
* Cor Ex LIBRIS UNIVERSITATIS ALBERTENSIS
■* cor AAAA Ex LIBRIS UNIVERSITATIS M èòmóóP'' ALBERTENSIS \°m- ~üôn7\mâ= -r ■ ■ comptes publics de la province de québec pour l’année financière terminée le 31 mars 1974 QUÉBEC♦ public accounts of the province of quebec for the fiscal year ended March 31, 1974 volume 2 détail des dépenses details of expenditures préparés sous l’autorité du ministre des finances prepared under the authority of the minister of finance UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF Al BFRTA TABLE DES MATIERES TABLE OF CONTENTS Section Section Liste des fournisseurs et bénéficiaires............... 1 List of Suppliers and Beneficiaries..................... 1 Liste des biens en capital........ .......................... 2 List of Capital Assets.......................................... 2 1-3 S E C TIO N 1 TABLE DES MATIÈRES TABLE OF CONTENTS Liste des fournisseurs et bénéficiaires List of Suppliers and Beneficiaries Page Page Enumeration and definitions of categories of Liste et définitions des catégories de dépenses. 1-4 expenditures...................................................... 1-4 Sommaire des dépenses par ministère et par Summary of expenditure by department and by catégorie............................................................ 1-6 category............................................................. 1-6 Détail des dépenses par ministère et par caté- Details of expenditure by department and by gorie categories Affaires culturelles........................................... 1-10 Cultural Affairs................................................. 1-10 Affaires