Vol. 134, No. 18 Vol. 134, no 18 Gazette Gazette du Canada Part I Partie I

OTTAWA, SATURDAY, APRIL 29, 2000 OTTAWA, LE SAMEDI 29 AVRIL 2000

NOTICE TO READERS AVIS AU LECTEUR The Canada Gazette is published under authority of the La Gazette du Canada est publiée conformément aux Statutory Instruments Act. It consists of three parts as described dispositions de la Loi sur les textes réglementaires. Elle est below: composée des trois parties suivantes : Part I Material required by federal statute or regulation to Partie I Textes devant être publiésdanslaGazette du be published in the Canada Gazette other than items Canada conformément aux exigences d’une loi identified for Parts II and III below — Published fédérale ou d’un règlement fédéral et qui ne satisfont every Saturday pas aux critères des Parties II et III — Publiée le samedi Part II Statutory Instruments (Regulations) and other classes Partie II Textes réglementaires (Règlements) et autres catégories of statutory instruments and documents — Published de textes réglementaires et de documents — Publiée le January 5, 2000, and at least every second 5 janvier 2000 et au moins tous les deux mercredis par la Wednesday thereafter suite Part III Public Acts of Parliament and their enactment Partie III Lois d’intérêt public du Parlement et les proclamations proclamations — Published as soon as is reasonably énonçant leur entrée en vigueur — Publiée aussitôt que practicable after Royal Assent possible après la sanction royale The Canada Gazette is available in most public libraries for On peut consulter la Gazette du Canada dans la plupart des consultation. bibliothèques publiques. To subscribe to, or obtain copies of, the Canada Gazette, On peut s’abonner à la Gazette du Canada ou en obtenir des contact bookstores selling Government publications as listed exemplaires en s’adressant aux agents libraires associés énumérés in the telephone directory or write to: Canadian Government dans l’annuaire téléphonique ou en s’adressant à : Les Éditions Publishing, Public Works and Government Services Canada, du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services Ottawa, Canada K1A 0S9. gouvernementaux Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9.

Canada Gazette Part I Part II Part III Gazette du Canada Partie I Partie II Partie III Yearly subscription Abonnement annuel Canada $135.00 $67.50 $28.50 Canada 135,00 $ 67,50 $ 28,50 $ Outside Canada US$135.00 US$67.50 US$28.50 Extérieur du Canada 135,00 $US 67,50 $US 28,50 $US Per copy Exemplaire Canada $2.95 $3.50 $4.50 Canada 2,95 $ 3,50 $ 4,50 $ Outside Canada US$2.95 US$3.50 US$4.50 Extérieur du Canada 2,95 $US 3,50 $US 4,50 $US REQUESTS FOR INSERTION DEMANDES D’INSERTION Requests for insertion should be directed to the Canada Les demandes d’insertion doivent être envoyées à la Gazette Directorate, Public Works and Government Services Direction de la Gazette du Canada, Travaux publics et Services Canada, 350 Albert Street, 5th Floor, Ottawa, Ontario K1A 0S5, gouvernementaux Canada, 350, rue Albert, 5e étage, Ottawa (613) 991-1351 (Telephone), (613) 991-3540 (Facsimile). (Ontario) K1A 0S5, (613) 991-1351 (téléphone), (613) 991-3540 (télécopieur). Bilingual texts received as late as six working days before the Un texte bilingue reçuauplus tard six jours ouvrables avant la desired Saturday’s date of publication will, if time and other date de parution demandée paraîtra, le temps et autres ressources resources permit, be scheduled for publication that date. le permettant, le samedi visé. Each client will receive a free copy of the Canada Gazette for Pour chaque semaine de parution d’un avis, le client recevra un every week during which a notice is published. exemplaire gratuit de la Gazette du Canada.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, represented by the © Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le Minister of Public Works and Government Services, 2000 ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, 2000 Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2000 Le 29 avril 2000 Gazette du Canada Partie I 1333

TABLE OF CONTENTS TABLE DES MATIÈRES No. 18 — April 29, 2000 No 18 — Le 29 avril 2000

Government House* ...... 1334 Résidence du Gouverneur général* ...... 1334 (orders, decorations and medals) (ordres, décorations et médailles)

Government Notices* ...... 1335 Avis du Gouvernement* ...... 1335

Parliament Parlement House of Commons ...... 1339 Chambre des communes ...... 1339 Bills assented to ...... 1339 Projets de loi sanctionnés...... 1339

Commissions* ...... 1340 Commissions* ...... 1340 (agencies, boards and commissions) (organismes, conseils et commissions)

Miscellaneous Notices* ...... 1348 Avis divers* ...... 1348 (banks; mortgage, loan, investment, insurance and (banques; sociétés de prêts, de fiducie et railway companies; other private sector agents) d’investissements; compagnies d’assurances et de chemins de fer; autres agents du secteur privé)

Proposed Regulations* ...... 1359 Règlements projetés* ...... 1359 (including amendments to existing regulations) (y compris les modifications aux règlements existants)

Index ...... 1361 Index ...... 1362

Supplements Suppléments

Office of the Superintendent of Financial Institutions Bureau du surintendant des institutions financières

______* Notices are listed alphabetically in the Index. * Les avis sont énumérés alphabétiquement dans l’index. 1334 Canada Gazette Part I April 29, 2000

GOVERNMENT HOUSE RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

AWARDS TO CANADIANS DÉCORATIONS À DES CANADIENS The Chancellery of Honours has announced that the Canadian La Chancellerie des distinctions honorifiques annonce que le Government has approved the following awards to Canadians: Gouvernement du Canada a approuvé l’octroi des distinctions honorifiques suivantes à des Canadiens : From the Government of Austria Du Gouvernement de l’Autriche Cross of Honour for Science and Arts la Croix d’honneur de la Science et des Arts to Professor Frederick C. Engelmann au professeur Frederick C. Engelmann From the Government of Germany Du Gouvernement de l’Allemagne Officer’s Cross of the Order of Merit la Croix d’Officier de l’Ordre du Mérite to Professor Peter Conrad Werner Hoffmann au professeur Peter Conrad Werner Hoffmann From the Government of Great Britain Du Gouvernement de la Grande-Bretagne Officer of the Order of the British Empire Officier de l’Ordre de l’Empire britannique to Mrs. Susan Anne Scott Parker Leigh àMme Susan Anne Scott Parker Leigh From the Government of Hungary Du Gouvernement de la Hongrie Small Cross of the Order of Merit la petite Croix de l’Ordre du Mérite to Rev. Dr. Jozsef Pungur au révérend docteur Jozsef Pungur From the Government of Norway Du Gouvernement de la Norvège Norwegian Participation Medal la Médaille norvégienne de Participation to Mr. Ivan Joseph Chiasson àM.IvanJoseph Chiasson Mr. Harry Ray Putney M. Harry Ray Putney From the Government of Poland Du Gouvernement de la Pologne Commander’s Cross of the Order of Merit la Croix de Commandeur de l’Ordre du Mérite to Mr. Jan Zurakowski à M. Jan Zurakowski Knight’s Cross of the Order of Merit la Croix de chevalier de l’Ordre du Mérite to MGen Hugh Cameron Ross, O.M.M., C.D. au Mgén Hugh Cameron Ross, O.M.M., C.D. Mr. Marian Wojdan à M. Marian Wojdan Gold Cross of the Order of Merit la Croix d’or de l’Ordre du Mérite to Mr. Henryk Antonowicz àM.Henryk Antonowicz Mr. Jan Zygmunt Armata M. Jan Zygmunt Armata Ms. Maria Halas Mme Maria Halas From the Government of Sweden Du Gouvernement de la Suède Royal Order of the Polar Star l’Ordre royal de l’Étoile polaire to Mr. Ronald E. Shirkey à M. Ronald E. Shirkey From the Government of the U.S.A. Du Gouvernement des É.-U.A. Soldier’s Medal la Médaille du Soldat to CWO Joseph D. Vienneau, C.D. àl’Adjuc Joseph D. Vienneau, C.D. Meritorious Service Medal la Médaille du Service méritoire to Capt Jerome E. Carell aux Capt Jerome E. Carell LCol John Dick, C.D. Lcol John Dick, C.D. Maj John D. Graham, C.D. Maj John D. Graham, C.D. Cdr Laurence M. Hickey,C.D. Cdr Laurence M. Hickey,C.D. LCol David D. Peart, C.D. Lcol David D. Peart, C.D. LGEN (Ret’d) JAMES C. GERVAIS, C.M.M., C.D. Le sous-secrétaire Deputy Secretary LGÉN (retraité) JAMES C. GERVAIS, C.M.M., C.D. [18-1-o] [18-1-o] Le 29 avril 2000 Gazette du Canada Partie I 1335

GOVERNMENT NOTICES AVIS DU GOUVERNEMENT

DEPARTMENT OF HEALTH MINISTÈRE DE LA SANTÉ FOOD AND DRUGS ACT LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES Food and Drug Regulations — Amendment Règlement sur les aliments et drogues — Modification Interim Marketing Authorization Autorisation de mise en marché provisoire Provision currently exists in the Food and Drug Regulations Il existe actuellement une disposition dans le Règlement sur les for the use of the alpha-amylase enzyme produced by Bacillus aliments et drogues qui autorise l’utilisation de l’enzyme alpha- licheniformis and different genetically modified strains of Bacil- amylase obtenue à partir de Bacillus licheniformis et de diffé- lus licheniformis at levels of use consistent with good manufac- rentes souches génétiquement modifiées de Bacillus licheniformis turingpractice in the production of brewers’ mash, distillers’ à une concentration conforme aux bonnes pratiques industrielles mashandonstarchusedintheproduction of dextrins, maltose, dans la production de moût de bière, de moût de distillerie et dans dextrose, glucose and glucose solids. Health Canada has received l’amidon entrant dans la production des dextrines, du maltose, du a submission to permit the use of the alpha-amylase enzyme pro- dextrose, du glucose et des solides de glucose. Santé Canada a duced by Bacillus licheniformis genetically modified to contain reçu une demande visant l’utilisation de l’alpha-amylase obtenue multiple copies of its natural alpha-amylase gene in the produc- à partir de Bacillus licheniformis modifié génétiquement de ma- tion of the above products. Evaluation of available data supports nière à contenir des copies multiples de son gène naturel de l’en- the safety and effectiveness of this use of the alpha-amylase en- zyme alpha-amylase dans la production des produits susmention- zyme produced by Bacillus licheniformis genetically modified to nés. L’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité et contain multiple copies of its natural alpha-amylase gene. l’efficacité de cette utilisation de l’enzyme alpha-amylase obtenue à partir de Bacillus licheniformis modifié génétiquement de ma- nière à contenir des copies multiples de son gène naturel pour l’enzyme alpha-amylase. The use of this alpha-amylase enzyme, as indicated above, will L’utilisation de cette alpha-amylase, comme il est mentionné benefit the industry byproviding an alternative and more efficient ci-dessus, sera avantageuse pour l’industrie en permettant l’accès method for the production of brewers’ mash, distillers’ mash, à une méthode différente et plus efficace pour la production de dextrins, maltose, dextrose, glucose (glucose syrup)andglucose moût de bière, de moût de distillerie, des dextrines, du maltose, solids (dried glucose syrup), thus improvingyield and du dextrose, du glucose (sirop de glucose) et des solides de glu- productivity. cose (sirop de glucose déshydraté), améliorant ainsi le rendement et la productivité. Therefore, it is the intention of Health Canada to amend the Santé Canada se propose donc de modifier le Règlement sur les Food and Drug Regulations to permit the use of the alpha- aliments et drogues afin d’y autoriser l’utilisation de l’alpha- amylase enzyme produced by Bacillus licheniformis genetically amylase obtenue à partir de Bacillus licheniformis modifié géné- modified to contain multiple copies of its natural alpha-amylase tiquement de manière à contenir des copies multiples de son gène gene for the purposes outlined above at a maximum level of use naturel pour l’enzyme alpha-amylase, aux fins décrites ci-dessus, consistent with good manufacturingpractice. selon une limite de tolérance conforme aux bonnes pratiques industrielles. As a means to improve the responsiveness of the regulatory Dans le but d’améliorer la souplesse du systèmederéglemen- system, an Interim Marketing Authorization (IMA) is being is- tation, Santé Canada émet une autorisation de mise en marché sued to permit the immediate use of this alpha-amylase enzyme as provisoire (AMP) autorisant l’utilisation immédiate de cette indicated above while the regulatoryprocess to amend the Regu- alpha-amylase, conformément aux indications ci-dessus, pendant lations formally is undertaken. que le processus officiel de modification du Règlement suit son cours. April 14, 2000 Le 14 avril 2000 DIANE C. GORMAN La sous-ministre adjointe intérimaire Acting Assistant Deputy Minister Direction générale de la protection de la santé Health Protection Branch DIANE C. GORMAN

[18-1-o] [18-1-o]

DEPARTMENT OF HEALTH MINISTÈRE DE LA SANTÉ FOOD AND DRUGS ACT LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES Food and Drug Regulations — Amendment Règlement sur les aliments et drogues — Modification Interim Marketing Authorization Autorisation de mise en marché provisoire Provision currently exists in the Food and Drug Regulations Le Règlement sur les aliments et drogues autorise actuellement for the use of glucose isomerase enzyme produced by Strepto- l’utilisation de l’enzyme glucose-isomérase provenant de Strep- myces rubiginosus ATCC No. 21,175 at levels consistent with tomyces rubiginosus ATCC no 21,175 à une concentration con- good manufacturingpractice in the production of glucose forme aux bonnes pratiques industrielles dans la production de 1336 Canada Gazette Part I April 29, 2000

(glucose syrup)tobepartially or completely isomerized to fruc- glucose (sirop de glucose) à être partiellement ou complètement tose. Health Canada has received a submission to permit the use transformé en fructose par isomérisation. Santé Canada a reçu of the glucose isomerase (wild type) enzyme produced by Strep- une demande pour que soit autorisée l’utilisation de l’enzyme tomyces rubiginosus genetically modified to contain multiple glucose-isomérase (typesauvage) provenant de Streptomyces copies of glucose isomerase gene in the production of highfruc- rubiginosus modifié génétiquement de manière à contenir des tose corn syrups. Evaluation of available data supports the safety copies multiples du gène pour la glucose-isomérase dans la pro- and effectiveness of this use of the glucose isomerase enzyme duction de sirop de maïs à haute teneur en fructose. L’évaluation produced by Streptomyces rubiginosus genetically modified to des données disponibles confirme l’innocuité et l’efficacité de contain multiple copies of the glucose isomerase gene from cette application de l’enzyme glucose-isomérase provenant de Streptomyces rubiginosus. Streptomyces rubiginosus modifié génétiquement de manière à contenir des copies multiples du gène pour la glucose-isomérase. The use of this glucose isomerase enzyme will benefit industry L’industrie bénéficiera de l’utilisation de cette glucose- byproviding an alternative source of this food enzyme in the isomérase, en ayant accès à une source alternative de cette en- production of the above-mentioned product. zyme alimentaire pour la production de sirop de maïs à haute teneur en fructose. Therefore, it is the intention of Health Canada to amend the Santé Canada se propose donc de modifier le Règlement sur Food and Drug Regulations to permit the use of the glucose les aliments et drogues afin d’autoriser l’utilisation de l’enzyme isomerase enzyme produced by Streptomyces rubiginosus geneti- glucose-isomérase provenant de Streptomyces rubiginosus modi- cally modified to contain multiple copies of the glucose fié génétiquement de manière à contenir des copies multiples du isomerase gene from Streptomyces rubiginosus in the production gène pour la glucose-isomérase dans la production de sirop de of high fructose corn syrups at a level consistent with good manu- maïs à haute teneur en fructose selon une limite de tolérance con- facturingpractice. forme aux bonnes pratiques industrielles. As a means to improve the responsiveness of the regulatory Dans le but d’améliorer la souplesse du systèmederéglemen- system, an Interim Marketing Authorization (IMA) is being is- tation, Santé Canada émet une autorisation de mise en marché sued to permit the immediate use of this glucose isomerase en- provisoire (AMP) autorisant l’utilisation immédiate de cette zyme as indicated above while the regulatoryprocess to amend glucose-isomérase, conformément aux indications ci-dessus, pen- the Regulations formally is undertaken. dant que le processus officiel de modification du Règlement suit son cours. April 14, 2000 Le 14 avril 2000 DIANE C. GORMAN La sous-ministre adjointe intérimaire Acting Assistant Deputy Minister Direction générale de la protection de la santé Health Protection Branch DIANE C. GORMAN [18-1-o] [18-1-o]

DEPARTMENT OF HEALTH MINISTÈRE DE LA SANTÉ FOOD AND DRUGS ACT LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES Food and Drug Regulations — Amendment Règlement sur les aliments et drogues — Modification Interim Marketing Authorization Autorisation de mise en marché provisoire Provision currently exists in the Food and Drug Regulations Le Règlement sur les aliments et drogues autorise actuellement for the use of the enzyme pullulanase produced by Bacillus aci- l’utilisation de l’enzyme pullulanase provenant de Bacillus aci- dopullulyticus NCIB 11647 and by Bacillus licheniformis SE2- dopullulyticus NCIB 11647 et de Bacillus licheniformis SE2-Pul- Pul-int211 (pUBCDEBRA11DNSI) at levels consistent with int211 (pUBCDEBRA11DNSI) à des concentrations conformes good manufacturingpractice in the production of starch-derived avec les bonnes pratiques industrielles dans la production d’édul- sweeteners and a variety of bakeryproducts. Health Canada has corants dérivés de l’amidon et d’une variété de produits de bou- received a submission to permit the use of the pullulanase enzyme langerie. Santé Canada a reçu une demande visant l’utilisation de produced by a Bacillus licheniformis organism genetically modi- la pullulanase obtenue à partir d’un microorganisme de l’espèce fied to contain the pullulanase gene from Bacillus deramificans in Bacillus licheniformis modifié génétiquement de manière à con- the production of brewer’s mash, bread, flour, whole wheat flour, tenir le gène pour la pullulanase du Bacillus deramificans dans la unstandardized bakeryproducts and on starch used in the pro- production de moût de bière, de pain, de farine, de farine de blé duction of dextrins, maltose, dextrose, glucose, glucose solids or entier, de produits de boulangerie non normalisés et dans l’ami- fructose syrups and solids. Evaluation of available data supports don entrant dans la production des dextrines, du maltose, du dex- the effectiveness and safety of these uses of the pullulanase trose, du glucose, de solides de glucose ou de sirops et solides de enzyme produced by a Bacillus licheniformis organism geneti- fructose. L’évaluation des données disponibles confirme l’inno- cally modified to contain the pullulanase gene from Bacillus cuité et l’efficacité de ces utilisations de l’enzyme pullulanase deramificans. obtenue à partir d’un microorganisme de l’espèce Bacillus li- cheniformis modifié génétiquement de manière à contenir le gène pour la pullulanase du Bacillus deramificans. The use of this pullulanase enzyme will benefit industry by L’utilisation de cette enzyme pullulanase sera avantageuse pour providing an alternative source of this food enzyme in the pro- l’industrie puisqu’elle permettra l’accès à une source différente duction of the above-mentioned products. de cette enzyme alimentaire dans la production des produits susmentionnés. Le 29 avril 2000 Gazette du Canada Partie I 1337

Therefore, it is the intention of Health Canada to amend the Santé Canada se propose donc de modifier le Règlement sur les Food and Drug Regulations to permit the use of the pullulanase aliments et drogues afin d’autoriser l’utilisation de l’enzyme enzyme produced by Bacillus licheniformis genetically modified pullulanase provenant de l’espèce Bacillus licheniformis généti- to contain the pullulanase gene from Bacillus deramificans in the quement modifié de manière à contenir le gène pour la pullula- production of brewer’s mash, bread, flour, whole wheat flour, nase du Bacillus deramificans dans la production de moût de unstandardized bakeryproducts and on starch used in the pro- bière, de pain, de farine, de farine de blé entier, de produits de duction of dextrins, maltose, dextrose, glucose, glucose solids or boulangerie non normalisés et dans l’amidon entrant dans la pro- fructose syrups and solids at a level consistent with good manu- duction des dextrines, du maltose, du dextrose, du glucose, de facturingpractice. solides de glucose ou de sirops et solides de fructose à une con- centration compatible avec les bonnes pratiques industrielles. As a means to improve the responsiveness of the regulatory Dans le but d’améliorer la souplesse du systèmederéglemen- system, an Interim Marketing Authorization (IMA) is being is- tation, Santé Canada émet une autorisation de mise en marché sued to permit the immediate use of this pullulanase enzyme as provisoire (AMP) autorisant l’utilisation immédiate de cette pul- indicated above while the regulatoryprocess to amend the Regu- lulanase, conformément aux indications ci-dessus, pendant que le lations formally is undertaken. processus de modification du Règlement suit son cours. April 14, 2000 Le 14 avril 2000 DIANE C. GORMAN La sous-ministre adjointe intérimaire Acting Assistant Deputy Minister Direction générale de la protection de la santé Health Protection Branch DIANE C. GORMAN [18-1-o] [18-1-o]

DEPARTMENT OF HEALTH MINISTÈRE DE LA SANTÉ FOOD AND DRUGS ACT LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES Food and Drug Regulations — Amendment Règlement sur les aliments et drogues — Modification Interim Marketing Authorization Autorisation de mise en marché provisoire Provision currently exists in the Food and Drug Regulations Le Règlement sur les aliments et drogues autorise actuellement for the use of the pullulanase enzyme produced by Bacillus aci- l’utilisation de l’enzyme pullulanase provenant de Bacillus aci- dopullulyticus NCIB 11647 and by Bacillus licheniformis SE2- dopullulyticus NCIB 11647 et de Bacillus licheniformis SE2-Pul- Pul-int211 (pUBCDEBRA11DNSI) at levels consistent with int211 (pUBCDEBRA11DNSI) à des concentrations conformes good manufacturingpractice in the production of starch-derived avec les bonnes pratiques industrielles dans la production d’édul- sweeteners and a variety of bakeryproducts. Health Canada has corants dérivés de l’amidon et d’une variété de produits de bou- received a submission to permit the use of pullulanase produced langerie. Santé Canada a reçu une demande visant l’utilisation de by a Bacillus subtilis organism genetically modified to contain the la pullulanase obtenue à partir d’un microorganisme de l’espèce pullulanase gene from Bacillus naganoensis in the production of Bacillus subtilis modifié génétiquement de manière à contenir le brewer’s mash, distillers’ mash, bread, flour, whole wheat flour, gène pour la pullulanase du Bacillus naganoensis dans la pro- unstandardized bakeryproducts and on starch used in the pro- duction de moût de bière, de moût de distillerie, de pain, de fa- duction of dextrins, maltose, dextrose, glucose and glucose solids rine, de farine de blé entier, de produits de boulangerie non nor- at a level consistent with good manufacturingpractice. Evaluation malisés et dans l’amidon entrant dans la production des dextrines, of available data supports the effectiveness and safety of these du maltose, du dextrose, du glucose et de solides de glucose à des uses of pullulanase produced by a Bacillus subtilis organism concentrations conformes aux bonnes pratiques industrielles. genetically engineered to contain the pullulanase gene from L’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité et Bacillus naganoensis. l’efficacité de ces utilisations de l’enzyme pullulanase obtenue à partir d’un microorganisme de l’espèce Bacillus subtilis modifié génétiquement de manière à contenir le gène pour la pullulanase du Bacillus naganoensis. The use of this pullulanase enzyme will benefit industry by L’utilisation de cette enzyme pullulanase sera avantageuse pour providing an alternative source of this food enzyme in the pro- l’industrie puisqu’elle permettra l’accès à une source différente duction of the above-mentioned products. de cette enzyme alimentaire dans la production des produits susmentionnés. Therefore, it is the intention of Health Canada to amend the Santé Canada se propose donc de modifier le Règlement sur les Food and Drug Regulations to permit the use of the pullulanase aliments et drogues afin d’autoriser l’utilisation de l’enzyme enzyme produced by a Bacillus subtilis organism genetically pullulanase provenant d’un microorganisme de l’espèce Bacillus modified to contain the pullulanase gene from Bacillus na- subtilis génétiquement modifié de manière à contenir le gène pour ganoensis in the production of brewer’s mash, distillers’ mash, la pullulanase de Bacillus naganoensis dans la production de bread, flour, whole wheat flour, unstandardized bakeryproducts moût de bière, de moût de distillerie, de pain, de farine, de farine andonstarchusedintheproduction of dextrins, maltose, dex- de blé entier, de produits de boulangerie non normalisés et dans trose, glucose and glucose solids at a level consistent with good l’amidon entrant dans la production des dextrines, du maltose, du manufacturingpractice. dextrose, du glucose et de solides de glucose à une concentration compatible avec les bonnes pratiques industrielles. As a means to improve the responsiveness of the regulatory Dans le but d’améliorer la souplesse du systèmederéglemen- system, an Interim Marketing Authorization (IMA) is being tation, Santé Canada émet une autorisation de mise en marché 1338 Canada Gazette Part I April 29, 2000 issued to permit the immediate use of this pullulanase enzyme as provisoire (AMP) autorisant l’utilisation immédiate de cette pul- indicated above while the regulatoryprocess to amend the Regu- lulanase, conformément aux indications ci-dessus, pendant que le lations formally is undertaken. processus de modification du Règlement suit son cours. April 14, 2000 Le 14 avril 2000 DIANE C. GORMAN La sous-ministre adjointe intérimaire Acting Assistant Deputy Minister Direction générale de la protection de la santé Health Protection Branch DIANE C. GORMAN [18-1-o] [18-1-o]

OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF FINANCIAL BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS INSTITUTIONS FINANCIÈRES BANK ACT LOI SUR LES BANQUES Habib Canadian Bank Banque Habib Canadienne Notice is herebygiven of the issuance on April 5, 2000, pursu- Avis est par les présentes donné de l’émission en date du anttosection22oftheBank Act, of letters patent incorporating 5 avril 2000, conformément à l’article 22 de la Loi sur les ban- Habib Canadian Bank. ques, de lettres patentes constituant la Banque Habib Canadienne. April 18, 2000 Le 18 avril 2000 JOHN PALMER Le surintendant des institutions financières Superintendent of Financial Institutions JOHN PALMER [18-1-o] [18-1-o] Le 29 avril 2000 Gazette du Canada Partie I 1339

PARLIAMENT PARLEMENT HOUSE OF COMMONS CHAMBRE DES COMMUNES Second Session, Thirty-Sixth Parliament Deuxième session, trente-sixième législature PRIVATE BILLS PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ Standing Order 130 respecting notices of intended applications L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de for private bills was published in the Canada Gazette,PartI,on projets de loi d’intérêt privéaétépublié dans la Partie I de la October 16, 1999. Gazette du Canada du 16 octobre 1999. For further information, contact the Private Members’ Business Pour obtenir d’autres renseignements, prièredecommuniquer Office, House of Commons, Centre Block, Room 134-C, Ottawa, avec le Bureau des affaires émanant des députés, Chambre des Ontario K1A 0A6, (613) 992-6443. communes, Édifice du Centre, Pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, (613) 992-6443. ROBERT MARLEAU Le greffier de la Chambre des communes Clerk of the House of Commons ROBERT MARLEAU

ROYAL ASSENT SANCTION ROYALE Thursday, April 13, 2000 Le jeudi 13 avril 2000 This day at 6 p.m., Her Excellency the Governor General, pro- Aujourd’hui à 18 h, Son Excellence la Gouverneure générale, ceeded to the Chamber of the Senate, in the Parliament Buildings, est venue à la Chambre du Sénat, en l’Hôtel du Parlement et a and took her seat at the foot of the Throne. The Members of the pris place au pied du Trône. Les membres du Sénat étant assem- Senate being assembled, Her Excellency the Governor General blés, il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale d’ordon- was pleased to command the attendance of the House of Com- ner à la Chambre des communes d’être présente, et, cette Cham- mons, and that House beingpresent, the following Bills were bre étant présente, Son Excellence la Gouverneure générale, au assented to in Her Majesty’s name by Her Excellency the Gover- nom de Sa Majesté, a sanctionné les projets de loi suivants : nor General: An Act to support and promote electronic commerce bypro- Loi visant à faciliter et à promouvoir le commerce électronique tectingpersonal information that is collected, used or dis- en protégeant les renseignements personnels recueillis, utili- closed in certain circumstances, byproviding for the use of sés ou communiqués dans certaines circonstances, en pré- electronic means to communicate or record information or voyant l’utilisation de moyens électroniques pour commu- transactions and by amending theCanadaEvidenceAct,the niquer ou enregistrer de l’information et des transactions et Statutory Instruments Act and the Statute Revision Act en modifiant la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur les (Bill C-6, Chapter 05/2000) textes réglementaires et la Loi sur la révision des lois (Projet de loi C-6, Chapitre 05/2000) An Act to establish the Canadian Institutes of Health Research, Loi portant création des Instituts de recherche en santé du Ca- to repeal the Medical Research Council Act and to make nada, abrogeant la Loi sur le Conseil de recherches médi- consequential amendments to other Acts cales et modifiant d’autres lois en conséquence (Bill C-13, Chapter 06/2000) (Projet de loi C-13, Chapitre 06/2000) An Act to give effect to the Nisga’a Final Agreement Loi portant mise en vigueur de l’Accord définitif nisga’a (Bill C-9, Chapter 07/2000) (Projet de loi C-9, Chapitre 07/2000) PAUL C. BÉLISLE Le greffier du Sénat et Clerk of the Senate and greffier des Parlements Clerk of the Parliaments PAUL C. BÉLISLE [18-1-o] [18-1-o] 1340 Canada Gazette Part I April 29, 2000

COMMISSIONS COMMISSIONS

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TELECOMMUNICATIONS COMMISSION TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES NOTICE TO INTERESTED PARTIES AVIS AUX INTÉRESSÉS The following notices are abridged versions of the Commis- Les avis qui suivent sont des versions abrégéesdesavisorigi- sion’s original notices bearing the same number. The original naux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux notices contain a more detailed outline of the applications, contiennent une description plus détaillée de chacune des including additional locations and addresses where the complete demandes, y compris les lieux et adresses où l’on peut consulter files may be examined. The relevant material, including the no- les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les tices and applications, is available for viewing during normal avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les business hours at the following offices of the Commission: heures normales d’affaires aux bureaux suivants du Conseil : — Central Building, Les Terrasses de la Chaudière, 1 Promenade — Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Ground Floor, Hull, K1A 0N2, (819) du Portage, Rez-de-chaussée, Hull (Québec) K1A 0N2, (819) 997-2429 (Telephone), 994-0423 (TDD), (819) 994-0218 997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), (819) 994-0218 (Facsimile); (télécopieur); — Bank of Commerce Building, Suite 1007, 1809 Barrington — Édifice de la Banque de Commerce, Pièce 1007, 1809, rue Street, Halifax, Nova Scotia B3J 3K8, (902) 426-7997 Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8, (902) (Telephone), 426-6997 (TDD), (902) 426-2721 (Facsimile); 426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), (902) 426-2721 —Kensington Building, Suite 1810, 275 Portage Avenue, Win- (télécopieur); nipeg, Manitoba R3B 2B3, (204) 983-6306 (Telephone), — Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winni- 983-8274 (TDD), (204) 983-6317 (Facsimile); peg (Manitoba) R3B 2B3, (204) 983-6306 (téléphone), — 530–580 Hornby Street, Vancouver, British Columbia V6C 983-8274 (ATS), (204) 983-6317 (télécopieur); 3B6, (604) 666-2111 (Telephone), 666-0778 (TDD), (604) — 530-580, rue Hornby, Vancouver (Colombie-Britannique) 666-8322 (Facsimile); V6C 3B6, (604) 666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), — C.R.T.C. Documentation Centre, 405 De Maisonneuve (604) 666-8322 (télécopieur); Boulevard E, 2nd Floor, Suite B2300, Montréal, Quebec, H2L — Centre de documentation du C.R.T.C., 405, boulevard de 4J5, (514) 283-6607 (Telephone), 283-8316 (TDD), (514) Maisonneuve Est, 2e étage, Bureau B2300, Montréal (Québec) 283-3689 (Facsimile); H2L 4J5, (514) 283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), (514) — C.R.T.C. Documentation Centre, 55 St. Clair Avenue E, 283-3689 (télécopieur); Suite 624, , Ontario M4T 1M2, (416) 952-9096 — Centre de documentation du C.R.T.C., 55, avenue St. Clair (Telephone), (416) 954-6343 (Facsimile); Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, (416) 952- — C.R.T.C. Documentation Centre, Cornwall Professional 9096 (téléphone), (416) 954-6343 (télécopieur); Building, Room 103, 2125 11th Avenue, Regina, Saskatche- — Centre de documentation du C.R.T.C., Édifice Cornwall Pro- wan S4P 3X3, (306) 780-3422 (Telephone), (306) 780-3319 fessional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatche- (Facsimile); wan) S4P 3X3, (306) 780-3422 (téléphone), (306) 780-3319 — C.R.T.C. Documentation Centre, Scotia Place Tower Two, (télécopieur); 19th Floor, Suite 1909, 10060 Jasper Avenue, Edmonton, Al- — Centre de documentation du C.R.T.C., Scotia Place Tower berta T5J 3R8, (780) 495-3224 (Telephone), (780) 495-3214 Two, 19e étage, Bureau 1909, 10060, avenue Jasper, Edmon- (Facsimile). ton (Alberta) T5J 3R8, (780) 495-3224 (téléphone), (780) 495-3214 (télécopieur). Interventions must be filed with the Secretary General, Cana- Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Con- dian Radio-television and Telecommunications Commission, seil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa, Ontario K1A 0N2, together with proofthatatruecopy of Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu’une copie conforme the intervention has been served upon the applicant, on or before aétéenvoyéeàlarequérante, avant la date limite d’intervention the deadline given in the notice. mentionnée dans l’avis. Secretary General Secrétaire général

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TELECOMMUNICATIONS COMMISSION TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES DECISIONS DÉCISIONS The complete texts of the decisions summarized below are On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci- available from the offices of the CRTC. après en s’adressant au CRTC.

2000-102 April 17, 2000 2000-102 Le 17 avril 2000 Eternacom Inc. Eternacom Inc. Sudbury,Ontario Sudbury (Ontario) Approved — Broadcasting licence for a low-power English- Approuvé — Licence de radiodiffusion visant l’exploitation, à languageFMradioprogramming undertaking at Sudbury,expir- Sudbury, d’une entreprise de programmation de radio FM de fai- ing on August 31, 2006. ble puissance de langue anglaise, expirant le 31 août 2006. Le 29 avril 2000 Gazette du Canada Partie I 1341

2000-103 April 17, 2000 2000-103 Le 17 avril 2000 Roger de Brabant, on behalf of a company to be Roger de Brabant, au nom d’une compagnie devant être incorporated incorporée Timmins, Ontario Timmins (Ontario) Approved — Broadcasting licence for a low-power English- Approuvé — Licence de radiodiffusion visant l’exploitation, à languageFMradioprogramming undertaking at Timmins, expir- Timmins, d’une entreprise de programmation de radio FM de ing August 31, 2006. faible puissance de langue anglaise, expirant le 31 août 2006.

2000-104 April 17, 2000 2000-104 Le 17 avril 2000 CIRC Radio Inc. CIRC Radio Inc. Toronto, Ontario Toronto (Ontario) Approved — Increase in the effective radiated power for CIRV- Approuvé — Augmentation de la puissance apparente rayonnée FM Toronto from 1 000 watts to 1 800 watts. de CIRV-FM Toronto, de 1 000 watts à 1 800 watts. [18-1-o] [18-1-o]

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TELECOMMUNICATIONS COMMISSION TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES PUBLIC HEARING 2000-3 AUDIENCE PUBLIQUE 2000-3 The Commission will hold a public hearing commencing on Le Conseil tiendra une audience publique à partir du 27 juin June 27, 2000, at 9 a.m. (Issue No. 1), at the Holiday Inn Select, 2000, à 9 h (Première partie), au Holiday Inn Select, 99, avenue 99 Viger Avenue W, Montréal, Quebec, to consider the Viger Ouest, Montréal (Québec), afin d’étudier ce qui suit : following: 1. Across Canada 1. L’ensemble du Canada Astral Television Networks Inc. Astral Télé Réseaux inc. Acquisition of the assets of the programming undertaking En vue d’acquérir l’actif de l’entreprise de programmation (pay television) Super Écran currently held by Les Chaînes (télévision payante) Super Écran présentement détenu par Les Télé Astral inc. The applicant is also requesting a broadcast- Chaînes Télé Astral inc. Elle demande également une licence ing licence to continue the operation of this undertaking. de radiodiffusion lui permettant de poursuivre l’exploitation de cette entreprise. 2. Across Canada 2. L’ensemble du Canada Canadian Broadcasting Corporation, Télé-Québec, BCE Société Radio-Canada, Télé-Québec, BCE Média inc., La Média inc., La SeptArteandL’équipeSpectra SeptArteetL’équipeSpectra Broadcasting licence to carry on a French-language national En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’ex- programming undertaking (television specialty service) to be ploitation d’une entreprise nationale de programmation distributed via satellite to broadcasting distribution undertak- (service spécialisé de télévision) de langue française distribué ings. The service would provide programming devoted to the par satellite aux entreprises de distribution de radiodiffusion. artsandtocultureandwouldbeknownas“Télédesarts.” Le service offrirait une programmation consacrée aux arts et à la culture et serait connu sous le nom « Télé des arts ». 3. Across Canada 3. L’ensemble du Canada CHUM Limited and Astral Média inc. CHUM Limitée et Astral Média inc. Broadcasting licence to carry on a French-language national En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’ex- programming undertaking (television specialty service) to be ploitation d’une entreprise nationale de programmation distributed via satellite to broadcasting distribution undertak- (service spécialisé de télévision) de langue française distribué ings. The service would provide programming devoted to the par satellite aux entreprises de distribution de radiodiffusion. arts and to culture and would be known as “Rendez-vous des Le service offrirait une programmation consacrée aux arts et artistes.” à la culture et serait connu sous le nom « Rendez-vous des artistes ». Atlantic and Quebec Region Région de l’Atlantique et du Québec 4. Halifax Regional Municipality (Halifax, Dartmouth, Bedford 4. Municipalité régionale de Halifax (Halifax, Dartmouth, and Sackville), Nova Scotia Bedford et Sackville) [Nouvelle-Écosse] Maritime TEL & TEL Limited (MTT) Maritime TEL & TEL Limited (MTT) Broadcasting licence for a cable distribution undertaking Demande une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une in the Halifax regional municipality (Halifax, Dartmouth, entreprise de distribution par câble dans la municipalité Bedford and Sackville). régionale de Halifax (Halifax, Dartmouth, Bedford et Sackville). 5. Kennetcook, Nova Scotia 5. Kennetcook (Nouvelle-Écosse) Dewis Cable Incorporated Dewis Cable Incorporated 1342 Canada Gazette Part I April 29, 2000

Acquisition of the assets of the radiocommunication distri- La requérante désire acquérir l’actif de l’entreprise de distri- bution undertaking (subscription television) currently held by bution de radiocommunication (télévision par abonnement) Kennetcook CableVision Limited. The applicant is also re- présentement détenu par Kennetcook CableVision Limited. questing a broadcasting licence to continue the operation of Elle demande également une licence de radiodiffusion lui this undertaking. permettant de poursuivre l’exploitation de cette entreprise. 6. Fredericton, New Brunswick 6. Fredericton (Nouveau-Brunswick) Joy FM Network Inc. Joy FM Network Inc. Broadcasting licence to carry on an English-languageFM En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’ex- radio programming undertaking at Fredericton. The new ploitation d’une entreprise de programmation de radio FM de stationwouldoperate on frequency 104.5 MHz (chan- langue anglaise à Fredericton. La nouvelle station serait ex- nel 283LP) with an effective radiated power of 50 watts. ploitée à la fréquence 104,5 MHz (canal 283FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts. 7. Chicoutimi, Quebec 7. Chicoutimi (Québec) Radiomutuel inc. Radiomutuel inc. To renew the broadcasting licence of the radio programming De renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de undertaking CKRS Chicoutimi expiring August 31, 2000; programmation de radio CKRS Chicoutimi qui expire le andtoreplace the condition of licence concerning the indus- 31 août 2000; de remplacer la condition relative au code de try’s code on gender portrayal by asuspensive condition, l’industrie sur la représentation non sexiste des personnes par meaning that the application of the condition would be sus- une condition suspensive, c’est-à-dire que la condition ne pended, so long as the licensee remains a member in good s’appliquerait pas tant et aussi longtemps que la titulaire est standing of the Canadian Broadcast Standards Council. The membre en règle du Conseil canadien des normes de la radio- licensee also requests the removal of the condition of licence télévision. La titulaire demande également le retrait de la presently in effect requiring the licensee to abide by the condition de licence présentement en vigueur qui exige que la “Radiomutuel Policy on Content”; and of the Commission’s titulaire respecte la « Politique de Radiomutuel en matière de expectation that Radiomutuel inform it as soon as possible of contenu » et de l’attente du Conseil que Radiomutuel any legal action againstCKRSoranyjudgment or out-of- l’informe dans les plus brefs délais de toute poursuite contre court settlement resulting from legal action againstCKRSor CKRS, ou tout jugement ou règlement hors cours résultant CKRS program hosts relating to on-air comments and that d’une poursuite contre CKRS ou les animateurs de CKRS Radiomutuel provideacopy of the Radiomutuel Policy to the portant sur des propos tenus en ondes et que Radiomutuel CKRS programhostsandtoanyperson who requests it. remette une copie de la politique de Radiomutuel aux anima- teurs de CKRS et à toute personne qui en fait la demande. 8. Grand-Remous and Quyon, Quebec 8. Grand-Remous et Quyon (Québec) Télécâble Blouin inc. Télécâble Blouin inc. The applicant wishes to acquire the assets of the cable distri- En vue d’acquérir les actifs des entreprises de distribution par bution undertakingsserving the above-mentioned localities. câble desservant les localités susmentionnées. 9. Katinniq (Raglan Mine), Quebec 9. Katinniq (Mine Raglan) [Québec] Maryann Van Walleghem Maryann Van Walleghem For a broadcasting licence to carry on a radiocommunication En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’ex- distribution undertaking at Katinniq (Raglan Mine), to dis- ploitation d’une entrepise de distribution de radiocommuni- tribute in non-encrypted mode, using one radio transmitter cation à Katinniq (Mine Raglan), afin de distribuer, sous operating on frequency 88.5 MHz (channel 203) with an ef- forme non codée, en utilisant un émetteur radiophoniqueàla fective radiated power of 100 watts, the programming of fréquence 88,5 MHz (canal 203) avec une puissance appa- CITE-FM Montréal, Quebec. rente rayonnée de 100 watts, le service de programmation de CITE-FM Montréal (Québec). 10. La Pocatière and vicinity, Quebec 10. La Pocatière et les environs (Québec) Vidéotron (RDL) ltée Vidéotron (RDL) ltée To exclude from the authorized service area the areas of Afin d’exclure de la zone de desserte autorisée les secteurs de Sainte-Perpétue/Tourville, Saint-Damase-de-l’Islet and Saint- Sainte-Perpétue/Tourville, Saint-Damase-de-l’Islet et Saint- Cyrille-de-l’Islet. Cyrille-de-l’Islet. 11. Montréal, Rimouski and Québec, Quebec 11. Montréal, Rimouski, et Québec (Québec) TQS inc. TQS inc. To renew the broadcasting licences of the television pro- Afin de renouveler les licences de radiodiffusion des entre- gramming undertakings CFJP-TV Montréal and its transmit- prises de programmation de télévision CFJP-TV Montréal et ter CJPC-TV Rimouski, CFAP-TV Québec, as well as the son émetteur CJPC-TV Rimouski, CFAP-TV Québec, ainsi licence for the French-language television network expiring que celle du réseau de télévision de langue française qui ex- on August 31, 2001; to delete the condition of licence related pirent le 31 août 2001; de supprimer la condition de licence to independent production expenditures, imposed in 1997, at reliée aux dépenses à la production indépendante, imposée en the time of the transfer of TQS to Quebecor; to amend its 1997, au moment du transfert de TQS à Quebecor; de modi- commitment, taken at the time of the transfer, to alwaysmake fier son engagement, pris au moment du transfert, visant à significant use of the independent production sector to be toujours utiliser la production indépendante de façon notable; relieved of the requirement of the policy on closed captioning d’être relevée de l’exigence de la politique sur le sous-titrage requiring that all local news and at least 90 percent of the exigeant que toutes les nouvelles locales et au moins Le 29 avril 2000 Gazette du Canada Partie I 1343

programming during a broadcasting day be closed captioned. 90 p. 100 des émissions au cours de la journée de radiodif- The applicant proposes a level of closed captioning of fusion soient sous-titrées. La requérante propose un niveau 30 percent the first year, with an increase to 75 percent the de sous-titragede30p. 100 la première année, jusqu’à seventh year upon the development of the technology which 75 p. 100 la septième année à condition que la technologie allows such a level and that it is financially viable. soit développée pour respecter ce niveau d’une façon finan- cièrement abordable. 12. Saint-Cyrille-de-l’Islet, Quebec 12. Saint-Cyrille-de-l’Islet (Québec) Vidéotron (RDL) ltée Vidéotron (RDL) ltée Broadcasting licence for a cable distribution undertaking in Demande une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une Saint-Cyrille-de-l’Islet. entreprise de distribution par câble à Saint-Cyrille-de-l’Islet. 13. Saint-Damase-de-l’Islet, Quebec 13. Saint-Damase-de-l’Islet (Québec) Vidéotron (RDL) ltée Vidéotron (RDL) ltée Broadcasting licence for a cable distribution undertaking in Demande une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une Saint-Damase-de-l’Islet. entreprise de distribution par câble à Saint-Damase-de-l’Islet. 14. Sainte-Perpétue/Tourville, Quebec 14. Sainte-Perpétue/Tourville (Québec) Vidéotron (RDL) ltée Vidéotron (RDL) ltée Broadcasting licence for a cable distribution undertaking in Demande une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une Sainte-Perpétue/Tourville. entreprise de distribution par câble à Sainte-Perpétue/ Tourville. 15. Sainte-Marie-de-Beauce, Quebec 15. Sainte-Marie-de-Beauce (Québec) 9079-3670 Québec inc. 9079-3670 Québec inc. Acquisition of the assets of the radio programming undertak- En vue d’acquérir l’actif de l’entreprise de programmation de ing CHEQ-FM Sainte-Marie-de-Beauce. The applicant is also radio CHEQ-FM Sainte-Marie-de-Beauce. Elle demande requesting a broadcasting licence to continue the operation of également une licence de radiodiffusion lui permettant de this undertaking,upon surrender of the current licence issued poursuivre l’exploitation de cette entreprise, à la rétrocession to Gestion Overtime inc., under the same terms and condi- de la licence actuelle émise à Gestion Overtime inc., selon les tions as the current licence. mêmes conditions que celles de la licence actuelle. 16. Windsor, Quebec 16. Windsor (Québec) Carrefour jeunesse emploi comté Johnson Carrefour jeunesse emploi comté Johnson For a broadcasting licence to carry on a French-language En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’ex- FM (type B) community radio programming undertaking ploitation d’une entreprise de programmation de radio com- at Windsor. The new station would operate on frequency munautaire FM (typeB)delangue française à Windsor. La 92.9 MHz (channel 225LP) with an effective radiated power nouvelle station serait exploitée à la fréquence 92,9 MHz of 35 watts. (canal 225FP) avec une puissance apparente rayonnée de 35 watts. Western Canada and Territories Region Région de l’Ouest du Canada et Territoires 17. Cypress Hills Provincial Park, Saskatchewan 17. Parc provincial Cypress Hills (Saskatchewan) Brad Mason, Saskatchewan Environment and Resource Brad Masson, Saskatchewan Environment and Resource Management Management To carry on an English-languagelow-power FM radio pro- En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’ex- gramming undertaking at Cypress Hills Provincial Park. The ploitation d’une entreprise de programmation de radio FM de new station would operate on frequency 103.7 MHz (chan- faible puissance de langue anglaise au parc provincial Cy- nel 279LP) with an effective radiated power of 47 watts. press Hills. La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 103,7 MHz (canal 279FP) avec une puissance apparente rayonnée de 47 watts. 18. Junction of the Trans-Canada Highway and Highway 21, 18. Jonction de la route transcanadienne et de la route 21 Saskatchewan (Saskatchewan) Brad Mason, Saskatchewan Environment and Resource Brad Mason, Saskatchewan Environment and Resource Management Management For a broadcasting licence to carry on an English-language En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’ex- low-power FM radio programming undertaking at the junc- ploitation d’une entreprise de programmation de radio FM de tion of the Trans-Canada Highway and Highway 21. The faible puissance de langue anglaise à la jonction de la route new station would operate on frequency 103.5 MHz (chan- transcanadienne et de la route 21. La nouvelle station serait nel 278 LP) with an effective radiated power of 39 watts. exploitée à la fréquence 103,5 MHz (canal 278FP) avec une puissance apparente rayonnée de 39 watts. 19. Nelson, British Columbia 19. Nelson (Colombie-Britannique) Kootenay Co-Operative Radio Kootenay Co-Operative Radio For a broadcasting licence to carry on an English-language En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’ex- FM community,typeBradioprogramming undertaking at ploitation d’une entreprise de programmation de radio FM Nelson. The new station would operate on frequency communautaire de typeB,delangue anglaise à Nelson. La 1344 Canada Gazette Part I April 29, 2000

93.5 MHz (channel 228A1) with an effective radiated power nouvelle station serait exploitée à la fréquence 93,5 MHz of 70 watts. (canal 228A1) avec une puissance apparente rayonnée de 70 watts. Deadline for intervention: June 5, 2000 Date limite d’intervention : le 5 juin 2000 April 19, 2000 Le 19 avril 2000 [18-1-o] [18-1-o]

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TELECOMMUNICATIONS COMMISSION TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES PUBLIC HEARING 2000-4 AUDIENCE PUBLIQUE 2000-4 The Commission will hold a public hearing commencing on Le Conseil tiendra une audience publique à partir du 27 juin June 27, 2000, at 9 a.m. (Issue No. 1), at the Conference Centre, 2000, à 9 h (Première partie), au Centre de conférence, Por- Portage IV, 140 Promenade du Portage, Hull, Quebec, to consider tage IV, 140, promenade du Portage, Hull (Québec), afin d’étu- the following: dier ce qui suit : Ontario Region Région de l’Ontario 1. Big Trout Lake, Ontario 1. Big Trout Lake (Ontario) Petaykawin Development Corporation Petaykawin Development Corporation For a broadcasting licence for a cable distribution undertaking Licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de at Big Trout Lake. distribution par câble à Big Trout Lake. 2. Kaministiquia, Ontario 2. Kaministiquia (Ontario) Joel Virtanen, on behalf of Northwest Broadcasting, Joel Virtanen, représentant Northwest Broadcasting, acompany to be incorporated une société devant être constituée For a broadcasting licence to carry on an English-language En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’ex- low-power FM radio programming undertaking at Kaminis- ploitation d’une entreprise de programmation de radio FM tiquia. The new station would operate on frequency de faible puissance de langue anglaise à Kaministiquia. La 104.5 MHz (channel 283LP) with an effective radiated power nouvelle station serait exploitée à la fréquence 104,5 MHz of 50 watts. (canal 283FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts. 3. Kapuskasing,Ontario 3. Kapuskasing (Ontario) Angela Demers, on behalf of AD Communications, a company Angela Demers, représentant AD Communications, to be incorporated une société devant être constituée For a broadcasting licence to carry on an English-language En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’ex- low-power FM radio programming undertaking at Kapuska- ploitation d’une entreprise de programmation de radio FM sing. The new station would operate on frequency 94.1 MHz de faible puissance de langue anglaise à Kapuskasing.La (channel 231LP) with an effective radiated power of 50 watts. nouvelle station serait exploitée à la fréquence 94,1 MHz (canal 231FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts. 4. London, Ottawa and Toronto, Ontario 4. London, Ottawa et Toronto (Ontario) Rogers Broadcasting Limited (“RBL”) Rogers Broadcasting Limited (« RBL ») To renew the broadcasting licence of the television program- En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’en- ming undertaking CFMT-TV Toronto and its transmitters treprise de programmation de télévision CFMT-TV Toronto et CFMT-TV-1 London and CFMT-TV-2 Ottawa expiring ses émetteurs CFMT-TV-1 London et CFMT-TV-2 Ottawa qui August 31, 2000; and to amend the broadcasting licence as expire le 31 août 2000; et de modifier la licence de radio- mentioned in the notice of public hearing. diffusion, tel qu’il est mentionné dans l’avis d’audience publique. 5. Parry Sound, Ontario 5. Parry Sound (Ontario) Playland Broadcasting Limited Playland Broadcasting Limited To renew the broadcasting licence for the radio programming En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’en- undertaking CKLP-FM Parry Sound expiring August 31, 2000. treprise de programmation de radio CKLP-FM Parry Sound, qui expire le 31 août 2000. 6. Red Lake, Ontario 6. Red Lake (Ontario) JR Radio JR Radio For a broadcasting licence to carry on an English-languageFM En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’ex- radio programming undertaking at Red Lake. The new station ploitation d’une entreprise de programmation de radio FM de would operate on frequency 95.1 MHz (channel 236LP) with langue anglaise à Red Lake. La nouvelle station serait exploi- an effective radiated power of 50 watts. tée à la fréquence 95,1 MHz (canal 236FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts. Le 29 avril 2000 Gazette du Canada Partie I 1345

7. Timmins, Ontario 7. Timmins (Ontario) Angela Demers, on behalf of AD Communications, a company Angela Demers, représentant AD Communications, to be incorporated une société devant être constituée For a broadcasting licence to carry on an English-language En vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’ex- low-power FM radio programming undertaking at Timmins. ploitation d’une entreprise de programmation de radio FM de Thenewstationwouldoperate on frequency 95.1 MHz faible puissance de langue anglaise à Timmins. La nouvelle (channel 236LP) with an effective radiated power of 32 watts. station serait exploitée à la fréquence 95,1 MHz (canal 236FP) avec une puissance apparente rayonnée de 32 watts. Deadline for intervention: June 5, 2000 Date limite d’intervention : le 5 juin 2000 April 19, 2000 Le 19 avril 2000 [18-1-o] [18-1-o]

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TELECOMMUNICATIONS COMMISSION TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES PUBLIC NOTICE 2000-55 AVIS PUBLIC 2000-55 Affinity Radio Group Inc. on behalf of Blackburn Group Affinity Radio Group Inc. au nom de Blackburn Group Incorporated Incorporated Leamington, Sarnia, Wingham and Centreville, Ontario Leamington, Sarnia, Wingham et Centreville (Ontario) Change to the effective control of Blackburn Radio Inc. and Changement du contrôle effectif de Blackburn Radio Inc. et Sarnia Broadcasters (1993) Ltd., through the transfer of all of the Sarnia Broadcasters (1993) Ltd., par le transfert de toutes les ac- issued and outstanding shares held by Blackburn Group Incor- tions émises et en circulation détenues par Blackburn Group In- porated, a wholly-owned subsidiary of Blackburn Radio Inc. and corporated, une filiale à part entière de Blackburn Radio Inc. et Sarnia Broadcasters (1993) Ltd. being transferred to Radiont Sarnia Broadcasters (1993) Ltd., à Radiont Inc. Affinity Radio Inc. Affinity Radio Group Inc. is a wholly-owned subsidiary of Group Inc. est une filiale à part entière de Radiont Inc. La société Radiont Inc. The said Radiont Inc. will also, indirectly,acquire Radiont Inc. acquerra aussi, indirectement, la part de 23,08 p. 100 the 23.08 percent interest that Blackburn Radio Inc. holds in Bea- que détient Blackburn Radio Inc. dans Bea-Ver Communications Ver Communications Inc. The affected radio stations are CHYR- Inc. Les stations de radio touchées sont CHYR-FM à Leamington, FM in Leamington, CFGX-FM, CHKS-FM and CHOK in Sarnia, CFGX-FM, CHKS-FM et CHOK à Sarnia, ainsi que CKNX et as well as CKNX and CKNX-FM in Wingham and the transmitter CKNX-FM à Wingham et l’émetteur CKNX-FM-2 à Centreville. CKNX-FM-2 in Centreville. April 17, 2000 Le 17 avril 2000 [18-1-o] [18-1-o]

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TELECOMMUNICATIONS COMMISSION TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES PUBLIC NOTICE 2000-56 AVIS PUBLIC 2000-56 Atlantic and Quebec Region Région de l’Atlantique et du Québec 1. Frederiction, New Brunswick 1. Fredericton (Nouveau-Brunswick) Telemedia Radio Atlantic Inc. Telemedia Radio Atlantic Inc. To amend the broadcasting licence of radio station CKHJ- En vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station FM Fredericton, by decreasing the effective radiated power de radio CKHJ-FM Fredericton, de manière à diminuer la from 100 000 to 78 000 watts. puissance apparente rayonnée de 100 000 à 78 000 watts. 2. Grand Falls, New Brunswick 2. Grand-Sault (Nouveau-Brunswick) Telemedia Radio Atlantic Inc. Telemedia Radio Atlantic Inc. To add a transmitter at Plaster Rock by using the presently En vue d’ajouter un émetteur à Plaster Rock, en utilisant les approved facilities of its CJCJ Woodstock transmitter CJCJ- installations approuvées pour l’émetteur de CJCJ Woods- 2. Telemedia has filed a separate application to delete CJCJ- tock, CJCJ-2. Telemedia a déposé une demande distincte 2 from the Woodstock station’s licence. afin de supprimer CJCJ-2 de la licence de la station de Woodstock. 3. Woodstock, New Brunswick 3. Woodstock (Nouveau-Brunswick) Telemedia Radio Atlantic Inc. Telemedia Radio Atlantic Inc. To cease broadcasting the signal of CJCJ from the transmit- Envuedecesserdedistribuerlesignal de CJCJ à partir des ters CJCJ-1 Perth/Andover and CJCJ-2 Plaster Rock. The li- émetteurs CJCJ-1 Perth/Andover et CJCJ-2 Plaster Rock. censee has stated that Perth/Andover is served by CIKX-FM, La titulaire a indiqué que Perth/Andover est desservie a Telemedia station in Grand Falls. Telemedia has also filed par CIKX-FM, une station de Telemedia à Grand-Sault. 1346 Canada Gazette Part I April 29, 2000

an application to use the facilities at Plaster Rock to re- Telemediaaégalement déposé une demande afin d’utiliser broadcast the signal of CIKX-FM in the Plaster Rock area. les installations à Plaster Rock afin de retransmettre le signal de CIKX-FM dans la région de Plaster Rock. Ontario Region Région de l’Ontario 4. Hamilton, Ontario 4. Hamilton (Ontario) CFMU Radio Incorporated CFMU Radio Incorporated To amend the broadcasting licence of radio station CFMU- En vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station FM Hamilton, by decreasing the effective radiated power CFMU-FM Hamilton, de manière à diminuer la puissance from 250 to 166 watts. apparente rayonnée de 250 à 166 watts. 5. North Bay,Ontario 5. North Bay (Ontario) 1158556 Ontario Ltd. 1158556 Ontario Ltd. To add a low power FM radio transmitter at North Bay to of- En vue d’ajouter un émetteur de radio FM de faible puis- fer the programming of CHIM-FM Timmins, a Christian sance à North Bay afin d’offrir les émissions de CHIM-FM music service. Timmins, un service de musique chrétienne. Western Canada and Territories Region Région de l’Ouest du Canada et Territoires 6. Edmonton (part of) and area, Alberta 6. Edmonton (secteur de) et la région (Alberta) Shaw Cablesystems Company Shaw Cablesystems Company To temporarily amend the broadcasting licence of the cable Envuedemodifiertemporairement la licence de radiodiffu- distribution undertaking servingpart of Edmonton and area, sion de l’entreprise de distribution par câble desservant un during the Children’s Miracle Network Telethon. secteur d’Edmonton et la région, pendant le Children’s Mi- racle Network Telethon. 7. Edmonton (part of) and area, Alberta 7. Edmonton (secteur de) et la région (Alberta) Videon Cablesystems Alberta Inc. Videon Cablesystems Alberta Inc. To temporarily amend the broadcasting licence of the cable Envuedemodifiertemporairement la licence de radiodiffu- distribution undertaking servingpart of Edmonton and area, sion de l’entreprise de distribution par câble desservant un during the Children’s Miracle Network Telethon. secteur d’Edmonton et la région, pendant le Children’s Mi- racle Network Telethon. 8. Red Deer, Alberta 8. Red Deer (Alberta) 1158556 Ontario Ltd. 1158556 Ontario Ltd. To add a low power FM radio transmitter at Red Deer to of- En vue d’ajouter un émetteur de radio FM de faible puis- fer the programming of CHIM-FM Timmins, Ontario, a sance à Red Deer afin d’offrir les émissions de CHIM-FM Christian music service. Timmins (Ontario), un service de musique chrétienne. 9. Red Deer, Alberta 9. Red Deer (Alberta) Shaw Cablesystems Company Shaw Cablesystems Company To temporarily amend the broadcasting licence of the cable Envuedemodifiertemporairement la licence de radiodiffu- distribution undertaking serving Red Deer, during the Chil- sion de l’entreprise de distribution par câble desservant Red dren’s Miracle Network Telethon. Deer, pendant le Children’s Miracle Network Telethon. 10. Whistler, British Columbia 10. Whistler (Colombie-Britannique) WIC Radio Ltd. WIC Radio Ltd. To add a low power FM transmitter at Whistler, to offer the En vue d’ajouter un émetteur de radio FM de faible puis- programming of CFMI-FM Vancouver. sance à Whistler, afin d’offrir les émissions de CFMI-FM Vancouver. Deadline for intervention: May 23, 2000 Date limite d’intervention : le 23 mai 2000 April 18, 2000 Le 18 avril 2000 [18-1-o] [18-1-o]

NAFTA SECRETARIAT SECRÉTARIAT DE L’ALÉNA DECISION DÉCISION Solder Joint Pressure Pipe Fittings and Solder Joint Drainage, Raccords de tuyauterie à souder de types à pression et à Waste and Vent Pipe Fittings drainage, renvoi et évent Notice is herebygiven, pursuant to rule 70 of the NAFTA Arti- Avis est donné par les présentes, conformément au paragra- cle 1904 Panel Rules, that the panel established to review the phe 70 des Règles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉ- final determination made by the Canadian International Trade NA), que le groupespécial chargé de réviser la décision définitive Tribunal, respecting certain solder joint pressure pipe fittingsand du Tribunal canadien du commerce extérieur, au sujet de certains solder joint drainage, waste and vent pipe fittings, made of cast raccords de tuyauterie à souder, de types à pression et à drainage, Le 29 avril 2000 Gazette du Canada Partie I 1347 copper alloy,wrought copper alloy or wrought copper, originat- renvoi et évent, faits en alliages de cuivre coulé, en alliages de ing in or exported from the United States of America and pro- cuivre ouvré ou en cuivre ouvré, originaires ou exportés des duced by or on behalf of Elkhart Products Corporation, Elkhart, États-Unis d’Amérique et produits par les sociétés Elkhart Prod- Indiana, Nibco Inc., Elkhart, Indiana, and Mueller Industries, Inc., ucts Corporation, d’Elkhart (Indiana), Nibco Inc., d’Elkhart Wichita, Kansas, their successors and assigns, issued its decision (Indiana), et Mueller Industries, Inc., de Wichita (Kansas), leurs on April 3, 2000 (Secretariat File No. CDA-USA-98-1904-03). successeurs et ayants droit, ou en leur nom, a rendu sa décision le 3 avril 2000 (dossier du Secrétariat no CDA-USA-98-1904-03). In the April 3, 2000 decision, the binational panel affirmed the Dans la décision du 3 avril 2000, le groupespécial binational a investigating authority’s determination respecting certain solder confirmé la décision de l’autorité chargée de l’enquête dans cer- joint pressure pipe fittingsandsolderjoint drainage, waste and tains raccords de tuyauterie à souder, de types à pression et à vent pipe fittings, made of cast copper alloy,wrought copper drainage, renvoi et évent, faits en alliages de cuivre coulé, en alloy or wrought copper, originating in or exported from the alliages de cuivre ouvré ou en cuivre ouvré, originaires ou expor- United States of America and produced by or on behalf of Elkhart tés des États-Unis d’Amérique et produits par les sociétés Elkhart Products Corporation, Elkhart, Indiana, Nibco Inc., Elkhart, Indi- Products Corporation, d’Elkhart (Indiana), Nibco Inc., d’Elkhart ana, and Mueller Industries, Inc., Wichita, Kansas, their succes- (Indiana), et Mueller Industries, Inc., de Wichita (Kansas), leurs sors and assigns. successeurs et ayants droit, ou en leur nom. Copies of the complete decision may be obtained from Cana- On peut se procurer des copies de la version intégrale de la dian Government Publishing, Public Works and Government décision en s’adressant aux Éditions du gouvernement du Cana- Services Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9, (819) 956-4802 da, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Otta- (Telephone), (819) 994-1498 (Facsimile). wa, Canada K1A 0S9, (819) 956-4802 (téléphone), (819) 994- 1498 (télécopieur). Explanatory Note Note explicative Chapter 19 of the North American Free Trade Agreement es- Le chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain tablishes a procedure for replacing domestic judicial review of substitue à l’examen judiciaire national des décisions rendues en determinations in anti-dumping and countervailing duty cases matière de droits antidumping et compensateurs touchant les pro- involving imports from a NAFTA country with review by bina- duits importés du territoire d’un paysdel’ALÉNA, une procédure tional panels. de révision par des groupes spéciaux binationaux. These panels are established, when a Request for Panel Review De tels groupes spéciaux sont formés lorsqu’une demande de is received by the NAFTA Secretariat, to act in place of national révision par un groupespécial est reçue au Secrétariat de courts to expeditiously review final determinations to determine l’ALÉNA. Ils tiennent lieu d’un tribunal national et examinent, whether they are in accordance with the anti-dumping or counter- dans les meilleurs délais, la décision définitive afin de déterminer vailing duty law of the country that made the determination. si elle est conforme à la législation sur les droits antidumping ou compensateurs du pays où elle a été rendue. Under Article 1904 of the North American Free Trade Agree- Conformément à l’article 1904 de l’Accord de libre-échange ment which came into force on January 1, 1994, the Government nord-américain entré en vigueur le 1er janvier 1994, le gouverne- of Canada, the Government of the United States and the Govern- ment du Canada, le gouvernement des États-Unis et le gouverne- ment of Mexico established the Rules of Procedure for Article ment du Mexique ont établi les Règles de procédure des groupes 1904 Binational Panel Reviews.TheseRuleswerepublished in spéciaux binationaux formés en vertu de l’article 1904.Cesrè- the Canada Gazette,PartI,onJanuary 1, 1994. gles ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada,le 1er janvier 1994. Requests for information concerning the present notice, or Toutes demandes de renseignements, concernant le présent avis concerning the NAFTA Article 1904 Panel Rules, should be ad- ou les Règles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA), dressed to the Canadian Secretary, NAFTA Secretariat, Canadian doivent être adressées au Secrétaire canadien, Secrétariat de Section, North American Free Trade Agreement, 90 Sparks l’ALÉNA, Section canadienne, Accord de libre-échange nord- Street, Suite 705, Ottawa, Ontario K1P 5B4, (613) 992-9388. américain, 90, rue Sparks, Pièce 705, Ottawa (Ontario) K1P 5B4, (613) 992-9388. FRANÇOY RAYNAULD Le secrétaire canadien Canadian Secretary FRANÇOY RAYNAULD [18-1-o] [18-1-o] 1348 Canada Gazette Part I April 29, 2000

MISCELLANEOUS NOTICES AVIS DIVERS

ASSOCIATES FINANCIAL LIFE INSURANCE COMPANY ASSOCIATES FINANCIAL LIFE INSURANCE COMPANY APPLICATION FOR AN ORDER DEMANDE D’ORDONNANCE Notice is herebygiven, pursuant to the provisions of sec- Avis est par les présentes donné, en vertu des dispositions de tion 580 of the Insurance Companies Act, S.C., 1991, c. 47, that l’article 580 de la Loi sur les sociétés d’assurances, L.C. (1991), Associates Financial Life Insurance Company (“Associates”), a ch. 47, que la Associates Financial Life Insurance Company company with its head office in Irving, Texas, intends to make an (la « Associates »), une compagnie dont le siège social est situé à application to the Superintendent of Financial Institutions for an Irving, au Texas, a l’intention de présenter une demande d’ordon- order approving the insuring in Canada of life risks. nance au surintendant des institutions financières l’autorisant à offrir de l’assurance-vie au Canada. April 15, 2000 Le 15 avril 2000 ANTHONY MILES L’agent principal Chief Agent ANTHONY MILES [16-4-o] [16-4]

BRIAN KILLINS AND ELAINE KILLINS BRIAN KILLINS ET ELAINE KILLINS PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS Brian Killins and Elaine Killins herebygive notice that an ap- Brian Killins et Elaine Killins donnent avis, par les présentes, plication has been made to the Minister of Fisheries and Oceans qu’une demande a été déposée auprès du ministre des Pêches et under the Navigable Waters Protection Act for approval of the des Océans en vertu de la Loi sur la protection des eaux naviga- plans and site of the work described herein. Under section 9 of bles, pour l’approbation des plans et de l’emplacement de l’ou- the said Act, Brian Killins and Elaine Killins have deposited with vrage décrit ci-après. Brian Killins et Elaine Killins ont, en vertu the Minister of Fisheries and Oceans, at Vancouver, British Co- de l’article 9 de ladite loi, déposé auprès du ministre des Pêches lumbia, and in the office of the District Registrar of the Land et des Océans, à Vancouver (Colombie-Britannique), et au bureau Registry District of Victoria, at 850 Burdett Avenue, Victoria, de la publicité des droits du district d’enregistrement de Victoria, British Columbia, under deposit number EP020077, a description situé au 850, avenue Burdett, Victoria (Colombie-Britannique), of the site and plans of the proposed expansion of the existing sous le numéro de dépôt EP020077, une description de oyster lease in the Lemmens Inlet fronting an unsurveyed fore- l’emplacement et les plans de l’agrandissement d’un bail huîtrier shore, 2 300 m east of District Lot 925, Clayoquot District, at actuellement dans le bras de mer Lemmens, en face d’un estran approximately 8 km north of Tofino. non levé, à 2 300 m à l’est du lot de district 925, district de Clayoquot, à environ 8 km au nord de Tofino. And take notice that the project is presently being screened Le projet fait présentement l’objet d’un examen préalable en con- pursuant to the Canadian Environmental Assessment Act. formité avec la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Written objections based on the effect of the work on marine Toute objection aux répercussions que les travaux pourraient navigation should be directed, not later than one month from avoir sur la navigation doit être adressée par écrit, dans un délai thedateofpublication of this notice, to the Regional Director, d’un mois suivant la date de publication du présent avis, au Direc- Navigable Waters Protection Division, Operational Programs, teur régional, Division de la protection des eaux navigables, Pro- Canadian Coast Guard, Department of Fisheries and Oceans, grammes opérationnels, Garde côtière canadienne, Ministère des 350–555 West Hastings Street, Vancouver, British Columbia Pêches et des Océans, 555, rue Hastings Ouest, Bureau 350, Van- V6B 5G3. couver (Colombie-Britannique) V6B 5G3. Tofino, April 16, 2000 Tofino, le 16 avril 2000 BRIAN KILLINS AND ELAINE KILLINS BRIAN KILLINS AND ELAINE KILLINS [18-1-o] [18-1-o]

CITY OF LONDON CITY OF LONDON PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS The City of London herebygives notice that an application has La City of London donne avis, par les présentes, qu’une de- been made to the Minister of Fisheries and Oceans under the mande a été déposée auprès du ministre des Pêches et des Océans Navigable Waters Protection Act for approval of the plans and en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables, pour site of the work described herein. Under section 9 of the said Act, l’approbation des plans et de l’emplacement de l’ouvrage décrit the City of London has deposited with the Minister of Fisheries ci-après. La City of London a, en vertu de l’article 9 de ladite loi, and Oceans, and in the office of the District Registrar of the Land déposé auprès du ministre des Pêches et des Océans, et au bureau Registry District of Middlesex No. 33, at 80 Dundas Street, de la publicité des droits du district d’enregistrement de Middle- Ground Floor, Unit J, London, Ontario N6A 6A7, under deposit sex no 33, situé au 80, rue Dundas, Rez-de-chaussée, Pièce J, number 950713, a description of the site and plans of the London (Ontario) N6A 6A7, sous le numéro de dépôt 950713, Le 29 avril 2000 Gazette du Canada Partie I 1349

Springbank Park footbridge over the Thames River, in the City of une description de l’emplacement et les plans de la passerelle London, Ontario. Springbank Park au-dessus de la rivière Thames, dans la ville de London (Ontario). And take notice that the project will be screened pursuant to Le projet fera l’objet d’un examen préalable en conformité the Canadian Environmental Assessment Act. avec la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Written objections based on the effect of the work on marine Toute objection aux répercussions que les travaux pourraient navigation and on the environment should be directed, not later avoir sur la navigation maritime et sur l’environnement doit être than one month from the date of publication of this notice, to the adressée par écrit, dans un délai d’un mois suivant la date de Regional Director, Canadian Coast Guard, Department of Fisher- publication du présent avis, au Directeur régional, Garde côtière ies and Oceans, 201 Front Street N, Suite 703, Sarnia, Ontario canadienne, Ministère des Pêches et des Océans, 201, rue Front N7T 8B1. Nord, Bureau 703, Sarnia (Ontario) N7T 8B1. London, April 17, 2000 London, le 17 avril 2000 J. W. JARDINE Le commissaire aux services de l’environnement Commissioner of Environmental Services et l’ingénieur municipal and City Engineer J. W. JARDINE [18-1-o] [18-1]

CLARENCE MICHAEL WOODS AND PATRICK CLARENCE MICHAEL WOODS ET PATRICK DONALD DONALD KORESKI KORESKI PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS Clarence Michael Woods and Patrick Donald Koreski hereby Clarence Michael Woods et Patrick Donald Koreski donnent give notice that an application has been made to the Minister of avis, par les présentes, qu’une demande a été déposée auprès du Fisheries and Oceans under the Navigable Waters Protection Act ministre des Pêches et des Océans en vertu de la Loi sur la pro- for approval of the plans and site of the work described herein. tection des eaux navigables, pour l’approbation des plans et de Under section 9 of the said Act, Clarence Michael Woods and l’emplacement de l’ouvrage décrit ci-après. Clarence Michael Patrick Donald Koreski have deposited with the Minister of Fish- Woods et Patrick Donald Koreski ont, en vertu de l’article 9 de eries and Oceans, at Vancouver, British Columbia, and in the ladite loi, déposé auprès du ministre des Pêches et des Océans, à office of the District Registrar of the Land Registry District of Vancouver (Colombie-Britannique), et au bureau de la publicité Clayoquot, at Victoria, British Columbia, under deposit num- des droits du district d’enregistrement de Clayoquot, à Victoria ber EP024624, a description of the site and plans of expansion of (Colombie-Britannique), sous le numéro de dépôt EP024624, une an oyster farm on the north side of a small cove located on the description de l’emplacement et les plans d’agrandissement d’un west side of Lemmens Inlet, on unsurveyed Crown land, 7 km parc à huîtres installé du côté nord d’une petite anse, côté ouest north of Tofino. du bras de mer Lemmens, sur des terres publiques non cadastrées, à 7 km au nord de Tofino. And take notice that the project is presently being screened Le projet fait présentement l’objet d’un examen préalable en con- pursuant to the Canadian Environmental Assessment Act. formité avec la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Written objections based on the effect of the work on marine Toute objection aux répercussions que les travaux pourraient navigation should be directed, not later than one month from the avoir sur la navigation maritime doit être adressée par écrit, dans date of publication of this notice, to the Regional Director, un délai d’un mois suivant la date de publication du présent avis, Canadian Coast Guard, Department of Fisheries and Oceans, au Directeur régional, Garde côtière canadienne, Ministère des 350–555 West Hastings Street, Vancouver, British Columbia Pêches et des Océans, 555, rue Hastings Ouest, Bureau 350, Van- V6B 5G3. couver (Colombie-Britannique) V6B 5G3. Tofino, April 17, 2000 Tofino, le 17 avril 2000 CLARENCE MICHAEL WOODS AND CLARENCE MICHAEL WOODS ET PATRICK DONALD KORESKI PATRICK DONALD KORESKI [18-1-o] [18-1]

COMMERCIAL TRAVELERS MUTUAL INSURANCE COMPAGNIE MUTUELLE D’ASSURANCES COMPANY COMMERCIAL TRAVELERS RELEASE OF ASSETS LIBÉRATION D’ACTIF Notice is herebygiven, pursuant to sections 651 and 652 of the Avis est par les présentes donné, conformément aux arti- Insurance Companies Act, that Commercial Travelers Mutual cles 651 et 652 de la Loi sur les sociétés d’assurances, que la Insurance Company,having ceased to carry on business in Can- Compagnie Mutuelle D’Assurances Commercial Travelers, ayant ada, and having transferred all of its insurance policies issued in cessé d’exercer ses activités commerciales au Canada, et ayant Canada to Toronto Mutual Life Insurance Company, will apply to transféré toutes ses polices d’assurance émises au Canada à la the Superintendent of Financial Institutions on or after June 12, Toronto Mutual Life Insurance Company, demandera au surin- 2000, for the release of its assets in Canada. tendant des institutions financières, le 12 juin 2000 ou après cette date, la libération de son actif au Canada. 1350 Canada Gazette Part I April 29, 2000

Anypolicyholders in Canada opposing such release should file Tout titulaire de police au Canada s’opposant à ce transfert doit their opposition with the Superintendent of Financial Institutions, déposer son opposition auprès du Surintendant des institutions 255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, on or before financières, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, au plus June 12, 2000. tard le 12 juin 2000. April 29, 2000 Le 29 avril 2000 WILLIAM JORGENS L’agent principal au Canada Chief Agent in Canada WILLIAM JORGENS [18-4-o] [18-4-o]

CORNER BROOK PULP AND PAPER LIMITED CORNER BROOK PULP AND PAPER LIMITED PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS Corner Brook Pulp and Paper Limited herebygives notice that La société Corner Brook Pulp and Paper Limited donne avis, an application has been made to the Minister of Fisheries and par les présentes, qu’une demande a été déposée auprès du minis- Oceans under the Navigable Waters Protection Act for approval tre des Pêches et des Océans en vertu de la Loi sur la protection of the plans and site of the work described herein. Under sec- des eaux navigables, pour l’approbation des plans et de l’em- tion 9 of the said Act, Corner Brook Pulp and Paper Limited has placement de l’ouvrage décrit ci-après. La Corner Brook Pulp and deposited with the Minister of Fisheries and Oceans and in the Paper Limited a, en vertu de l’article 9 de ladite loi, déposé au- Government Service Centre of the Electoral District of Humber près du ministre des Pêches et des Océans, au Centre des services —St. Barbe at Corner Brook, Newfoundland, and also in the De- gouvernementaux de la circonscription électorale de Humber— velopment Office of the Electoral District of Humber—St. Barbe St. Barbe à Corner Brook (Terre-Neuve), et au Bureau du déve- at Pollards Point, Newfoundland, a description of the site and loppement de la circonscription électorale de Humber—St. Barbe plans of the existing bridge over the Main River, northwest of the à Pollards Point (Terre-Neuve), une description de l’emplacement community of Sop’s Arm, Newfoundland, located at latitude et les plans du pont actuellement au-dessus de la rivière Main, au 49°47′50″ and longitude 57°04′45″. nord-ouest de la communauté de Sop’s Arm (Terre-Neuve), situé à49°47′50″ de latitude et 57°04′45″ de longitude. And take notice that the project is presently being screened Le projet fait présentement l’objet d’un examen préalable en con- pursuant to the Canadian Environmental Assessment Act. formité avec la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Written objections based on the effect of the work on marine Toute objection aux répercussions que les travaux pourraient navigation and on the environment as it relates to areas of federal avoir sur la navigation maritime et sur l’environnement en ce qui responsibility should be directed, not later than one month from atraitauxcompétences fédérales doit être adressée par écrit, dans thedateofpublication of this notice, to the Regional Director, un délai d’un mois suivant la date de publication du présent avis, Canadian Coast Guard, Department of Fisheries and Oceans, P.O. au Directeur régional, Garde côtière canadienne, Ministère des Box 5667, St. John’s, Newfoundland A1C 5X1. Pêches et des Océans, Case postale 5667, St. John’s (Terre- Neuve) A1C 5X1. Corner Brook, April 18, 2000 Corner Brook, le 18 avril 2000 BARRY ELKINS Le technicien des routes Roads Technician BARRY ELKINS [18-1-o] [18-1-o]

CORTES ISLAND SHELLFISH GROWERS CORTES ISLAND SHELLFISH GROWERS CO-OPERATIVE CO-OPERATIVE PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS Cortes Island Shellfish Growers Co-operative herebygives no- La société Cortes Island Shellfish Growers Co-operative donne tice that an application has been made to the Minister of Fisheries avis, par les présentes, qu’une demande a été déposée auprès du and Oceans under the Navigable Waters Protection Act for ap- ministre des Pêches et des Océans en vertu de la Loi sur la pro- proval of the plans and site of the work described herein. Under tection des eaux navigables, pour l’approbation des plans et de section 9 of the said Act, Cortes Island Shellfish Growers Co- l’emplacement de l’ouvrage décrit ci-après. La Cortes Island operative has deposited with the Minister of Fisheries and Shellfish Growers Co-operative a, en vertu de l’article 9 de ladite Oceans, at Vancouver, British Columbia, and in the office of the loi, déposé auprès du ministre des Pêches et des Océans, à District Registrar of the Land Registry District of Victoria, at Vancouver (Colombie-Britannique), et au bureau de la publicité Victoria, British Columbia, under deposit number EP026249, a des droits du district d’enregistrement de Victoria, à Victoria description of the site and plans of an off-bottom oyster culture in (Colombie-Britannique), sous le numéro de dépôt EP026249, une Talbot Cove, at Teakerne Arm, West Redonda Island, File description de l’emplacement et les plans d’une ostréiculture en No. 2406810. suspension dans l’anse Talbot, dans la baie Teakerne, à l’île West Redonda, numéro de dossier 2406810. And take notice that the project is presently being screened Le projet fait présentement l’objet d’un examen préalable en con- pursuant to the Canadian Environmental Assessment Act. formité avec la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Le 29 avril 2000 Gazette du Canada Partie I 1351

Written objections based on the effect of the work on marine Toute objection aux répercussions que les travaux pourraient navigation should be directed, not later than one month from avoir sur la navigation maritime doit être adressée par écrit, dans thedateofpublication of this notice, to the Regional Director, un délai d’un mois suivant la date de publication du présent avis, Navigable Waters Protection Division, Operational Programs, au Directeur régional, Division de la protection des eaux navi- Canadian Coast Guard, Department of Fisheries and Oceans, gables, Programmes opérationnels, Garde côtière canadienne, 350–555 West Hastings Street, Vancouver, British Columbia Ministère des Pêches et des Océans, 555, rue HastingsOuest, V6B 5G3. Bureau 350, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3. West Redonda Island, April 17, 2000 Île West Redonda, le 17 avril 2000 DELIA BECKER La directrice Director DELIA BECKER [18-1-o] [18-1-o]

DJJ LEASING LTD. DJJ LEASING LTD. JOSEPH LEASING LTD. JOSEPH LEASING LTD. ECDC ENVIRONMENTAL, L.C. ECDC ENVIRONMENTAL, L.C. I&M RAIL LINK, L.L.C. I&M RAIL LINK, L.L.C. DOCUMENTS DEPOSITED DÉPÔT DE DOCUMENTS Notice is herebygiven, pursuant to section 105 of the Canada Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 105 Transportation Act,thatonApril 5, 2000, copies of the following de la Loi sur les transports au Canada, que le 5 avril 2000 des documents were deposited in the Office of the Registrar General copies des documents suivants ont été déposées au Bureau du of Canada: registraire général du Canada : 1. Railroad Equipment Lease by and between Joseph Leasing 1. Bail d’équipement ferroviaire par et entre la Joseph Leasing Ltd. and ECDC Environmental, L.C. dated as of March 21, Ltd. et la ECDC Environmental, L.C. en date du 21 mars 2000, 2000, relating to 50 2000 Trinity-built, 89 feet flatcars bearing ayant trait à 50 wagons plats fabriqués par la Trinity en 2000, reporting marks ECXX 20001–20050, inclusive; mesurant 89 pieds de long et portant les marques de wagon 2. Railroad Equipment Lease among Joseph Leasing Ltd. ECXX 20001 à 20050, inclusivement; (formerly DJJ Leasing Ltd.) and I&M Rail Link, L.L.C. dated 2. Bail d’équipement ferroviaire entre la Joseph Leasing Ltd. as of March 16, 2000, relating to 100 2000 National Steel Car- (anciennement la DJJ Leasing Ltd.) et la I&M Rail Link, built coil cars bearing reporting marks IMRL 70000–70099, L.L.C. en date du 16 mars 2000, ayant trait à 100 wagons pour inclusive and 50 2000 National Steel Car-built covered coil tôle en rouleaux fabriqués par la National Steel Car en 2000, et cars bearing reporting marks IMRL 70100–70149, inclusive; portant les marques de wagon IMRL 70000 à 70099, inclusi- and vement et 50 wagons couverts pour tôle en rouleaux fabriqués 3. Security Documents Supplement No. 2 dated April 3, 2000, par la National Steel Car en 2000, et portant les marques de to the Security Agreement dated as of December 29, 1999, wagon IMRL 70100 à 70149, inclusivement; between DJJ Leasing Ltd., as Borrower, and Firstar Bank, 3. Deuxième supplément aux documents de sûreté en date du N.A., as Lender, and to the Assignment of Leases dated as of 3 avril 2000, accompagnant l’accord de sûreté en date du Decem- 29 décembre 1999 entre la DJJ Leasing Ltd., à titre d’em- ber 29, 1999, between such Borrower and such Lender, relating prunteur, et la Firstar Bank, N.A., à titre de prêteur, et accom- to, among others, flatcars and coil cars bearing reporting pagnant aussi la cession des baux en date du 29 décembre 1999 marks ECXX 20001–20025, inclusive, ECXX 20028–20030, entre l’emprunteur et le prêteur ayant trait, entre autres, à des inclusive, ECXX 20032–20033, inclusive, IMRL 70069 and wagons plats et des wagons pour tôle en rouleaux portant les IMRL 70100–70149, inclusive. marques de wagons ECXX 20001 à 20025, inclusivement, ECXX 20028 à 20030, inclusivement, ECXX 20032 à 20033, inclusivement, IMRL 70069 et IMRL 70100 à 70149, inclusivement. April 5, 2000 Le 5 avril 2000 FRASER MILNER Les conseillers juridiques Solicitors FRASER MILNER [18-1-o] [18-1-o]

DONOHUE FOREST PRODUCTS INC. DONOHUE FOREST PRODUCTS INC. PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS Donohue Forest Products Inc. herebygives notice that an ap- La société Donohue Forest Products Inc. donne avis, par les plication has been made to the Minister of Fisheries and Oceans présentes, qu’une demande a été déposée auprès du ministre des under the Navigable Waters Protection Act for approval of the Pêches et des Océans en vertu de la Loi sur la protection des eaux plans and site of the work described herein. Under section 9 of navigables, pour l’approbation des plans et de l’emplacement de the said Act, Donohue Forest Products Inc. has deposited with the l’ouvrage décrit ci-après. La Donohue Forest Products Inc. a, en Minister of Fisheries and Oceans, at Vancouver, British vertu de l’article 9 de ladite loi, déposé auprès du ministre des 1352 Canada Gazette Part I April 29, 2000

Columbia, and in the office of the District Registrar of the Land Pêches et des Océans, à Vancouver (Colombie-Britannique), et au Registry District of Prince George, at Prince George, British Co- bureau de la publicité des droits du district d’enregistrement de lumbia, under deposit number PP 012499, a description of the Prince George,àPrinceGeorge (Colombie-Britannique), sous le site and plans of the McGraw Creek BridgeovertheMcGraw numéro de dépôt PP 012499, une description de l’emplacement et Creek, at kilometer 32+000 on the Russel Mainline. les plans du pont McGraw Creek au-dessus du ruisseau McGraw, au kilomètre 32+000 sur le prolongement Russel. Written objections based on the effect of the work on marine Toute objection aux répercussions que les travaux pourraient navigation and on the environment should be directed, not later avoir sur la navigation maritime et sur l’environnement doit être than one month from the date of publication of this notice, to adressée par écrit, dans un délai d’un mois suivant la date de the Regional Director, Navigable Waters Protection Division, publication du présent avis, au Directeur régional, Division de Canadian Coast Guard, Department of Fisheries and Oceans, la protection des eaux navigables, Garde côtière canadienne, 350–555 West Hastings Street, Vancouver, British Columbia Ministère des Pêches et des Océans, 555, rue HastingsOuest, V6B 5G3. Bureau 350, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3. Prince George, April 18, 2000 Prince George, le 18 avril 2000 ALLNORTH CONSULTANTS LIMITED ALLNORTH CONSULTANTS LIMITED DARBY D. KREITZ L’ingénieur Professional Engineer DARBY D. KREITZ [18-1-o] [18-1-o]

DONOHUE FOREST PRODUCTS INC. DONOHUE FOREST PRODUCTS INC. PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS Donohue Forest Products Inc. herebygives notice that an ap- La société Donohue Forest Products Inc. donne avis, par les plication has been made to the Minister of Fisheries and Oceans présentes, qu’une demande a été déposée auprès du ministre des under the Navigable Waters Protection Act for approval of the Pêches et des Océans en vertu de la Loi sur la protection des eaux plans and site of the work described herein. Under section 9 of navigables, pour l’approbation des plans et de l’emplacement de the said Act, Donohue Forest Products Inc. has deposited with the l’ouvrage décrit ci-après. La Donohue Forest Products Inc. a, en Minister of Fisheries and Oceans, at Vancouver, British Colum- vertu de l’article 9 de ladite loi, déposé auprès du ministre des bia, and in the office of the District Registrar of the Land Registry Pêches et des Océans, à Vancouver (Colombie-Britannique), et au District of Prince George, at Prince George, British Columbia, bureau de la publicité des droits du district d’enregistrement de under deposit number PP 012498, a description of the site and Prince George,àPrinceGeorge (Colombie-Britannique), sous le plans of the Russel Creek BridgeovertheRusselCreek,atkilo- numéro de dépôt PP 012498, une description de l’emplacement et meter 42+000 on the Russel Mainline. les plans du pont Russel Creek au-dessus du ruisseau Russel, au kilomètre 42+000 sur le prolongement Russel. Written objections based on the effect of the work on marine Toute objection aux répercussions que les travaux pourraient navigation and on the environment should be directed, not later avoir sur la navigation maritime et sur l’environnement doit être than one month from the date of publication of this notice, to adressée par écrit, dans un délai d’un mois suivant la date de the Regional Director, Navigable Waters Protection Division, publication du présent avis, au Directeur régional, Division de Canadian Coast Guard, Department of Fisheries and Oceans, la protection des eaux navigables, Garde côtière canadienne, 350–555 West Hastings Street, Vancouver, British Columbia Ministère des Pêches et des Océans, 555, rue HastingsOuest, V6B 5G3. Bureau 350, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3. Prince George, April 18, 2000 Prince George, le 18 avril 2000 ALLNORTH CONSULTANTS LIMITED ALLNORTH CONSULTANTS LIMITED DARBY D. KREITZ L’ingénieur Professional Engineer DARBY D. KREITZ [18-1-o] [18-1-o]

DONOHUE FOREST PRODUCTS INC. DONOHUE FOREST PRODUCTS INC. PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS Donohue Forest Products Inc. herebygives notice that an ap- La société Donohue Forest Products Inc. donne avis, par les plication has been made to the Minister of Fisheries and Oceans présentes, qu’une demande a été déposée auprès du ministre des under the Navigable Waters Protection Act for approval of the Pêches et des Océans en vertu de la Loi sur la protection des eaux plans and site of the work described herein. Under section 9 of navigables, pour l’approbation des plans et de l’emplacement de the said Act, Donohue Forest Products Inc. has deposited with the l’ouvrage décrit ci-après. La Donohue Forest Products Inc. a, en Minister of Fisheries and Oceans, at Vancouver, British Colum- vertu de l’article 9 de ladite loi, déposé auprès du ministre des bia, and in the office of the District Registrar of the Land Registry Pêches et des Océans, à Vancouver (Colombie-Britannique), et au District of Prince George, at Prince George, British Columbia, bureau de la publicité des droits du district d’enregistrement de under deposit number PP 012496, a description of the site and Prince George,àPrinceGeorge (Colombie-Britannique), sous le Le 29 avril 2000 Gazette du Canada Partie I 1353 plans of the Stelkuz Creek Bridge over the Stelkuz Creek, at numéro de dépôt PP 012496, une description de l’emplacement et kilometer 5+600 on the Stelkuz Mainline. les plans du pont Stelkuz Creek au-dessus du ruisseau Stelkuz, au kilomètre 5+600 sur le prolongement Stelkuz. Written objections based on the effect of the work on marine Toute objection aux répercussions que les travaux pourraient navigation and on the environment should be directed, not later avoir sur la navigation maritime et sur l’environnement doit être than one month from the date of publication of this notice, to adressée par écrit, dans un délai d’un mois suivant la date de the Regional Director, Navigable Waters Protection Division, publication du présent avis, au Directeur régional, Division de Canadian Coast Guard, Department of Fisheries and Oceans, la protection des eaux navigables, Garde côtière canadienne, 350–555 West Hastings Street, Vancouver, British Columbia Ministère des Pêches et des Océans, 555, rue HastingsOuest, V6B 5G3. Bureau 350, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3. Prince George, April 18, 2000 Prince George, le 18 avril 2000 ALLNORTH CONSULTANTS LIMITED ALLNORTH CONSULTANTS LIMITED DARBY D. KREITZ L’ingénieur Professional Engineer DARBY K. KREITZ [18-1-o] [18-1-o]

DONOHUE FOREST PRODUCTS INC. DONOHUE FOREST PRODUCTS INC. PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS Donohue Forest Products Inc. herebygives notice that an ap- La société Donohue Forest Products Inc. donne avis, par les plication has been made to the Minister of Fisheries and Oceans présentes, qu’une demande a été déposée auprès du ministre des under the Navigable Waters Protection Act for approval of the Pêches et des Océans en vertu de la Loi sur la protection des eaux plans and site of the work described herein. Under section 9 of navigables, pour l’approbation des plans et de l’emplacement de the said Act, Donohue Forest Products Inc. has deposited with the l’ouvrage décrit ci-après. La Donohue Forest Products Inc. a, en Minister of Fisheries and Oceans, at Vancouver, British Colum- vertu de l’article 9 de ladite loi, déposé auprès du ministre des bia, and in the office of the District Registrar of the Land Registry Pêches et des Océans, à Vancouver (Colombie-Britannique), et au District of Prince George, at Prince George, British Columbia, bureau de la publicité des droits du district d’enregistrement de under deposit number PP 012497, a description of the site and Prince George,àPrinceGeorge (Colombie-Britannique), sous le plans of the Tsaydiz Creek BridgeovertheTsaydiz Creek, at numéro de dépôt PP 012497, une description de l’emplacement et kilometer 15+000 on the Russel Forest Service Road. les plans du pont Tsaydiz Creek au-dessus du ruisseau Tsaydiz, au kilomètre 15+000 sur le chemin de service forestier Russel. Written objections based on the effect of the work on marine Toute objection aux répercussions que les travaux pourraient navigation and on the environment should be directed, not later avoir sur la navigation maritime et sur l’environnement doit être than one month from the date of publication of this notice, to adressée par écrit, dans un délai d’un mois suivant la date de the Regional Director, Navigable Waters Protection Division, publication du présent avis, au Directeur régional, Division de Canadian Coast Guard, Department of Fisheries and Oceans, la protection des eaux navigables, Garde côtière canadienne, 350–555 West Hastings Street, Vancouver, British Columbia Ministère des Pêches et des Océans, 555, rue HastingsOuest, V6B 5G3. Bureau 350, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3. Prince George, April 18, 2000 Prince George, le 18 avril 2000 ALLNORTH CONSULTANTS LIMITED ALLNORTH CONSULTANTS LIMITED DARBY D. KREITZ L’ingénieur Professional Engineer DARBY D. KREITZ [18-1-o] [18-1-o]

THE FIRST CATHOLIC SLOVAK LADIES THE FIRST CATHOLIC SLOVAK LADIES ASSOCIATION OF THE UNITED STATES OF AMERICA ASSOCIATION OF THE UNITED STATES OF AMERICA RELEASE OF ASSETS LIBÉRATION D’ACTIF Notice is herebygiven, in accordance with sections 650, 651 Avis est par les présentes donné, conformément aux arti- and 652 of the Insurance Companies Act, that The First Catholic cles 650, 651 et 652 de la Loi sur les sociétés d’assurances, que Slovak Ladies Association of the United States of America, hav- The First Catholic Slovak Ladies Association of the United States ing ceased to carry on business in Canada, intends to apply to the of America, laquelle a cessé d’exercer des affaires au Canada, a Superintendent of Financial Institutions for release of the Com- l’intention de demander au surintendant des institutions finan- pany’s assets in Canada on or after June 5, 2000. The First cières, le 5 juin 2000 ou après cette date, la libération de son actif Catholic Slovak Ladies Association of the United States of au Canada. The First Catholic Slovak Ladies Association of the America has discharged or provided for the discharge of all of its United States of America s’est acquittée ou prend des disposi- obligations in Canada, including its liabilities under its policies in tions pour s’acquitter de toutes ses obligations au Canada, Canada. incluant ses obligations liées aux polices au Canada. 1354 Canada Gazette Part I April 29, 2000

Anypolicyholder who opposes such release of assets must file Tout assuré qui s’oppose à cette libération doit enregistrer son notice of such opposition with the Superintendent of Financial opposition auprès du Surintendant des institutions financières, Institutions, Ottawa, Ontario K1A 0H2, on or before June 5, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, au plus tard le 5 juin 2000. 2000. April 15, 2000 Le 15 avril 2000 JOHN R. MILNES L’agent principal au Canada Chief Agent for Canada JOHN R. MILNES [17-4-o] [17-4-o]

FLEX LEASING II, LLC FLEX LEASING II, LLC FLEX LEASING CORPORATION FLEX LEASING CORPORATION DOCUMENTS DEPOSITED DÉPÔT DE DOCUMENTS Notice is herebygiven, pursuant to section 105 of the Canada Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 105 Transportation Act,thatonApril 10, 2000, the following docu- de la Loi sur les transports au Canada, que le 10 avril 2000 les ments were deposited in the Office of the Registrar General of documents suivants ont été déposés au Bureau du registraire gé- Canada: néral du Canada : 1. Memorandum of Partial Termination of Lease dated as of 1. Résumé de résiliation partielle du contrat de location daté April 10, 2000, of the Lease dated as of August 7, 1998, and du 10 avril 2000, du contrat de location daté du 7 août 1998 et Schedule No. 1 dated as of August 7, 1998, between Flex de la première annexe datée du 7 août 1998, entre la Flex Leas- Leasing II, LLC (“Flex”) as Successor Lessor by assignment ing II, LLC (« Flex »), en qualité de bailleur remplaçant par from Flex Leasing Corporation (“FLC”), and PhillipsPetro- cession la Flex Leasing Corporation (« FLC »), et la Phillips leum Company,asLessee,only as to the railcars listed on An- Petroleum Company,enqualité de preneur à bail, des seuls nex A to the Memorandum of Partial Termination of Lease; autorails énumérés à l’annexe A du résumé de résiliation par- 2. Memorandum of Lease dated as of April 10, 2000, of the tielle de contrat de location; Lease dated as of March 10, 2000, between Flex, as Successor 2. Résumé du contrat location daté du 10 avril 2000, du con- Lessor by assignment from FLC, and Variform Incorporated trat de location daté du 10 mars 2000, entre la Flex, en qualité (“Variform”), as Lessee, covering the railcars listed on An- de bailleur remplaçant par cession la FLC, et la Variform In- nex A to the Memorandum of Lease; corporated (« Variform »), en qualité de preneur à bail, cou- 3. Memorandum of Use Agreement dated as of April 10, 2000, vrant les autorails énumérés à l’annexe A du résumé du contrat of the Use Agreement dated as of March 3, 2000, between de location; Flex, as Successor Lessor by assignment from FLC, and Vari- 3. Résumé de convention d’utilisation daté du 10 avril 2000, form, covering the railcars listed on Annex A to the Memoran- de la convention d’utilisation datée du 3 mars 2000, entre la dum of Use; Flex, en qualité de bailleur remplaçant par cession la FLC, et la 4. Memorandum of Use Agreement dated as of April 10, 2000, Variform, couvrant les autorails énumérés à l’annexe A du ré- of the Use Agreement dated as of February 18, 2000, between sumé de convention d’utilisation; Flex, as Successor Lessor by assignment from FLC, and Vari- 4. Résumé de convention d’utilisation daté du 10 avril 2000, form, covering the railcars listed on Annex A to the Memoran- de la convention d’utilisation datée du 18 février 2000, entre la dum of Use; Flex, en qualité de bailleur remplaçant par cession la FLC, et la 5. Memorandum of Use Agreement dated as of April 10, 2000, Variform, couvrant les autorails énumérés à l’annexe A du ré- of the Use Agreement dated as of February 7, 2000, between sumé de convention d’utilisation; Flex, as Successor Lessor by assignment from FLC, and Vari- 5. Résumé de convention d’utilisation daté du 10 avril 2000, form, covering the railcars listed on Annex A to the Memoran- de la convention d’utilisation datée du 7 février 2000, entre la dum of Use; and Flex, en qualité de bailleur remplaçant par cession la FLC, et la 6. Amendment and Supplement to the Memorandum of Se- Variform, couvrant les autorails énumérés à l’annexe A du ré- curity Agreement — Chattel Mortgage dated as of April 10, sumé de convention d’utilisation; 2000, of the Memorandum of Security Agreement — Chattel 6. Modification et supplément au résumé de convention de ga- Mortgage dated as of August 31, 1999, between First Security rantie — hypothèque mobilière datés du 10 avril 2000, du ré- Bank, National Association, as Secured Party,andFlex,as sumé de convention de garantie — hypothèque mobilière daté Borrower. du 31 août 1999, entre la First Security Bank, National Asso- ciation, en qualité de partie garantie, et la Flex, en qualité d’emprunteur. April 10, 2000 Le 10 avril 2000 HEENAN BLAIKIE Les conseillers juridiques Solicitors HEENAN BLAIKIE [18-1-o] [18-1-o] Le 29 avril 2000 Gazette du Canada Partie I 1355

GE GLOBAL INSURANCE HOLDING CORPORATION GE GLOBAL INSURANCE HOLDING CORPORATION LETTERS PATENT LETTRES PATENTES Notice is herebygiven, pursuant to the provisions of section 25 Avis est par les présentes donné que la GE Global Insurance of the Insurance Companies Act, S.C., 1991, c. 47, that GE Holding Corporation ou une filiale de la GE Global Insurance Global Insurance Holding Corporation (or a subsidiary of GE Holding Corporation a l’intention de présenter, aux termes de Global Insurance Holding Corporation) intends to file an applica- l’article 25 de la Loi sur les sociétés d’assurances, L.C. (1991), tion with the Minister of Finance (Canada) for letters patent in- ch. 47, au ministre des Finances (Canada), une demande de lettres corporating GE Reassurance Company of Canada in English, and patentes constituant en personne morale GE Compagnie de Réas- in French, GE CompagniedeRéassuranceduCanadaforthepur- surance du Canada, en français, et GE Reassurance Company of pose of transacting the business of life insurance and accident and Canada, en anglais, afin d’exercer des activités relatives à sickness insurance, limited to the business of reinsurance. l’assurance-vie et à l’assurance accidents et maladie, limitées aux affaires de réassurance. Anyperson objecting to the proposed incorporation may Quiconque s’oppose au projet de constitution en personne mo- submit an objection in writing to the Office of the Superintendent rale peut soumettre une opposition par écrit au Bureau du surin- of Financial Institutions, 255 Albert Street, 15th Floor, Ottawa, tendant des institutions financières, 255, rue Albert, 15e étage, Ontario K1A 0H2, on or before June 5, 2000. Ottawa (Ontario) K1A 0H2, au plus tard le 5 juin 2000. Toronto, April 4, 2000 Toronto, le 4 avril 2000 GE GLOBAL INSURANCE HOLDING CORPORATION GE GLOBAL INSURANCE HOLDING CORPORATION [16-4-o] [16-4-o]

THE LAKE ERIE & DETROIT RIVER RAILWAY THE LAKE ERIE & DETROIT RIVER RAILWAY COMPANY COMPANY

ANNUAL AND SPECIAL MEETING OF SHAREHOLDERS ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE ET ANNUELLE DES ACTIONNAIRES Notice is herebygiven that the Annual and Special Meeting Avis est par les présentes donné de l’assemblée extraordinaire (“the “Meeting”) of the Shareholders of The Lake Erie & Detroit et annuelle (l’assemblée) des actionnaires de The Lake Erie & Railway Company (the “Corporation”) will be held at the head Detroit River Railway Company (la compagnie) qui aura lieu au office of the Corporation at 100 Ouellette Avenue, Suite 1300, siègesocialdelacompagnie située au 100, avenue Ouellette, Bu- Windsor, Ontario, on June 25, 2000, at 11 a.m. (Eastern time), for reau 1300, Windsor (Ontario), le 25 juin 2000, à 11 h (heure the followingpurpose : normale de l’Est), pour les raisons suivantes : 1. To elect directors and other general purposes; and 1. Élire les administrateurs et examiner d’autres questions 2. To consider and retroactively validate the sale on Febru- d’ordre général; ary 15, 1991, by the Corporation to Canadian National Rail- 2. Étudier et valider rétroactivement la vente aux Chemins de ways or its nominee, certain tracks and real estate located in fer nationaux du Canada ou à ses mandataires, le 15 février Windsor, Ontario, between mileposts 2.0 and 8.0 and at 1991, par la compagnie, de certaines voies ferrées et propriétés Leamington, Ontario, between mileposts 37.4 and 38.2, includ- situées à Windsor, Ontario, entre les bornes 2.0 et 8.0 et à ing various lead and spur tracks. Leamington, Ontario, entre les bornes 37,4 et 38,2 y compris les diverses voies d’accès et embranchements. PATRICIA AFTOORA La secrétaire Secretary PATRICIA AFTOORA [17-4-o] [17-4-o]

LOBLAW PROPERTIES LIMITED LOBLAW PROPERTIES LIMITED PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS Loblaw Properties Limited herebygives notice that an applica- La société Loblaw Properties Limited donne avis, par les pré- tion has been made to the Minister of Fisheries and Oceans under sentes, qu’une demande a été déposée auprès du ministre des the Navigable Waters Protection Act for approval of the plans Pêches et des Océans en vertu de la Loi sur la protection des eaux and site of the work described herein. Under section 9 of the said navigables, pour l’approbation des plans et de l’emplacement de Act, Loblaw Properties Limited has deposited with the Minister l’ouvrage décrit ci-après. La Loblaw Properties Limited a, en of Fisheries and Oceans, and in the office of the District Registrar vertu de l’article 9 de ladite loi, déposé auprès du ministre des of the Land Registry District of Halifax County, at 5151 Terminal Pêches et des Océans, et au bureau de la publicité des droits du Road, 2nd Floor, Halifax, Nova Scotia, under deposit num- district d’enregistrement du comté de Halifax, situé au 5151, che- ber 3061, a description of the site and plans of a proposed vehicu- min Terminal, 2e étage, Halifax (Nouvelle-Écosse), sous le numé- lar and pedestrian bridge over the Sackville River, at civic 1650 ro de dépôt 3061, une description de l’emplacement et les plans Bedford Highway, at the intersection of the Bedford Highway and d’un pont-route et d’une passerelle que l’on propose de construire Rocky Lake Drive, in Bedford, Nova Scotia. au-dessus de la rivière Sackville, au niveau de la route municipale 1356 Canada Gazette Part I April 29, 2000

1650 Bedford, à l’intersection de la route Bedford et de la pro- menade Rocky Lake, à Bedford (Nouvelle-Écosse). Written objections based on the effect of the work on marine Toute objection aux répercussions que les travaux pourraient navigation should be directed, not later than one month from the avoir sur la navigation maritime doit être adressée par écrit, dans date of publication of this notice, to the Regional Director, Ca- un délai d’un mois suivant la date de publication du présent avis, nadian Coast Guard, Department of Fisheries and Oceans, Foot of au Directeur régional, Garde côtière canadienne, Ministère des Parker Street, P.O. Box 1000, Dartmouth, Nova Scotia B2Y 3Z8. Pêches et des Océans, Rue Parker, Case postale 1000, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 3Z8. Bedford, April 18, 2000 Bedford, le 18 avril 2000 LOBLAW PROPERTIES LIMITED LOBLAW PROPERTIES LIMITED [18-1-o] [18-1]

NATIONAL CITY BANK NATIONAL CITY BANK APPLICATION TO ESTABLISH A FOREIGN BANK DEMANDE D’ÉTABLISSEMENT D’UNE SUCCURSALE DE BRANCH BANQUE ÉTRANGÈRE Notice is herebygiven, pursuant to subsection 525(2) of the Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 525(2) Bank Act, that National City Bank, a foreign bank located in de la Loi sur les banques, que la National City Bank, une banque Cleveland, Ohio, U.S.A., intends to apply to the Minister of Fi- étrangère ayant son siège social à Cleveland, Ohio, États-Unis, a nance for an order permitting it to establish a foreignbankbranch l’intention de demander au ministre des Finances une ordonnance in Canada to carry on the business of banking.Theprincipal l’autorisant à établir une succursale de banque étrangère au Cana- office of the foreign bank branch will be located in Toronto, da pour y mener des activités bancaires. Le bureau principal de la Ontario. succursale de la banque étrangère sera situé à Toronto (Ontario). Anyperson who objects to the proposed order may submit an Toute personne qui s’oppose à une telle ordonnance peut sou- objection in writing to the Office of the Superintendent of Finan- mettre son opposition, par écrit, au Bureau du surintendant des cial Institutions, 255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, on institutions financières, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A or before June 20, 2000. 0H2, au plus tard le 20 juin 2000. Ohio, April 29, 2000 Ohio, le 29 avril 2000 NATIONAL CITY BANK NATIONAL CITY BANK [18-4-o] [18-4-o]

ORGANIZATION FOR THE SUPPORT ŒUVRE DU SOUTIEN AUX RÉFUGIÉS OF VIETNAMESE REFUGEES VIETNAMIENS SURRENDER OF CHARTER ABANDON DE CHARTE Notice is herebygiven that the ŒUVRE DU SOUTIEN AUX Avis est par les présentes donné que l’ŒUVRE DU SOUTIEN RÉFUGIÉS VIETNAMIENS/ORGANIZATION FOR THE AUX RÉFUGIÉS VIETNAMIENS/ORGANIZATION FOR THE SUPPORT OF VIETNAMESE REFUGEES intends to apply to SUPPORT OF VIETNAMESE REFUGEES demandera au minis- the Minister of Industry for leave to surrender its charter, pursu- tre de l’Industrie la permission d’abandonner sa charte en vertu ant to the Canada Corporations Act. de la Loi sur les corporations canadiennes. April 6, 2000 Le 6 avril 2000 DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST Les procureurs de la corporation Attorneys to the Corporation DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST [18-1-o] [18-1-o]

PROCOR LIMITED PROCOR LIMITED DOCUMENTS DEPOSITED DÉPÔT DE DOCUMENTS Notice is herebygiven, pursuant to section 105 of the Canada Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 105 Transportation Act that on March 20, 2000, the following docu- de la Loi sur les transports au Canada, que le 20 mars 2000 les ments were deposited in the Office of the Registrar General of documents suivants ont été déposés au Bureau du registraire gé- Canada: néral du Canada : 1. Termination of Trust Agreement (Series CAN-5) dated as of 1. Résiliation de la convention de fiducie (série CAN-5) en November 15, 1999, between Procor Limited and The Royal date du 15 novembre 1999 entre la Procor Limited et The Trust Company, as Trustee, terminating an Equipment Trust Royal Trust Company,enqualité de fiduciaire, résiliant un ac- Agreement dated as of December 1, 1989; and cord de nantissement de matériel en date du 1er décembre 1989; Le 29 avril 2000 Gazette du Canada Partie I 1357

2. Bill of Sale (Series CAN-5) effective as of November 15, 2. Contrat de vente (série CAN-5) entrant en vigueur le 1999, from The Royal Trust Company, as Trustee, under 15 novembre 1999 de The Royal Trust Company,enqualité de Equipment Trust Agreement dated as of December 1, 1989, fiduciaire aux termes de l’accord de nantissement de matériel between Procor Limited and the Trustee, relating to 340 vari- en date du 1er décembre 1989 entre la Procor Limited et le ous railcars. fiduciaire, concernant 340 wagons divers. March 20, 2000 Le 20 mars 2000 OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP Les conseillers juridiques Barristers and Solicitors OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP [18-1-o] [18-1-o]

RBC LIFE INSURANCE COMPANY COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE RBC WESTBURY CANADIAN LIFE INSURANCE COMPANY WESTBURY CANADIENNE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE

LETTERS PATENT OF AMALGAMATION LETTRES PATENTES DE FUSION Notice is herebygiven, pursuant to the provisions of subsec- Avis est par les présentes donné, conformément au paragra- tion 250(2) of the Insurance Companies Act (Canada), that RBC phe 250(2) de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) que Life Insurance Company,having its head office at 55 City Centre la Compagnie d’assurance vie RBC, dont le siège social est sis au Drive, Suite 1100, Mississauga, Ontario L5B 1M3, and Westbury 55, promenade City Centre, Bureau 1100, Mississauga (Ontario) Canadian Life Insurance Company,having its head office at L5B 1M3, et la Westbury Canadienne, Compagnie d’Assurance 21 King Street W, Suite 1100, Hamilton, Ontario L8N 3R5, in- Vie, dont le siège social est sis au 21, rue King Ouest, Bu- tend to make a joint application to the Minister of Finance on or reau 1100, Hamilton (Ontario) L8N 3R5, entendent faire une after May 9, 2000, for letters patent of amalgamation continuing demande conjointe au ministre des Finances, le 9 mai 2000 ou them as one company under the name RBC Life Insurance Com- après cette date, pour obtenir des lettres patentes de fusion leur pany, and in French, Compagnie d’assurance vie RBC. permettant de poursuivre leurs activités en tant que compagnie unique sous le nom de Compagnie d’assurance vie RBC, et en anglais, RBC Life Insurance Company. Mississauga, March 27, 2000 Mississauga, le 27 mars 2000 RBC LIFE INSURANCE COMPANY COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE RBC WESTBURY CANADIAN LIFE INSURANCE COMPANY WESTBURY CANADIENNE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE [15-4-o] [15-4-o]

SONYA’S MARIONNETTE THEATRE INC. THÉÂTRE DE MARIONNETTES SONYA INC. SURRENDER OF CHARTER ABANDON DE CHARTE Notice is herebygiven that SONYA’S MARIONNETTE Avis est par les présentes donné que le THÉÂTRE DE MA- THEATRE INC. intends to apply to the Minister of Industry for RIONNETTES SONYA INC. demandera au ministre de l’Indus- leave to surrender its charter, pursuant to the Canada Corpora- trie la permission d’abandonner sa charte en vertu de la Loi sur tions Act. les corporations canadiennes. April 4, 2000 Le 4 avril 2000 NATHALIE GURAL Le président President NATHALIE GURAL [18-1-o] [18-1-o]

ST. LAWRENCE ARTIFICIAL REEF ASSOCIATION ST. LAWRENCE ARTIFICIAL REEF ASSOCIATION PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS The St. Lawrence Artificial Reef Association herebygives no- La St. Lawrence Artificial Reef Association donne avis, par les tice that an application has been made to the Minister of Fisheries présentes, qu’une demande a été déposée auprès du ministre des and Oceans under the Navigable Waters Protection Act for ap- Pêches et des Océans en vertu de la Loi sur la protection des eaux proval of the plans and site of the work described herein. Under navigables, pour l’approbation des plans et de l’emplacement de section 9 of the said Act, the St. Lawrence Artificial Reef Asso- l’ouvrage décrit ci-après. La St. Lawrence Artificial Reef Asso- ciation has deposited with the Minister of Fisheries and Oceans, ciation a, en vertu de l’article 9 de ladite loi, déposé auprès du and in the NWP office for the county of Leeds and Grenville, at ministre des Pêches et des Océans, au bureau NWP du comté de Prescott, Ontario, a description of the site and plans of an artifi- Leeds et Grenville, à Prescott (Ontario), une description de cial reef in the St. Lawrence River, at Brockville, south of the l’emplacement et les plans d’un récif artificiel dans le fleuve 1358 Canada Gazette Part I April 29, 2000 shipping channel, in front of Blockhouse Island or lot number Saint-Laurent, à Brockville, au sud du canal de navigation se Register Plan 67 - Block 29. trouvant devant l’île Blockhouse ou du lot portant l’inscription Register Plan 67 - Block 29. Written objections based on the effect of the work on marine Toute objection aux répercussions que les travaux pourraient navigation should be directed, not later than one month from the avoir sur la navigation maritime doit être adressée par écrit, dans date of publication of this notice, to the Regional Director, un délai d’un mois suivant la date de publication du présent avis, Canadian Coast Guard, Department of Fisheries and Oceans, au Directeur régional, Garde côtière canadienne, Ministère des 201 Front Street N, Suite 703, Sarnia, Ontario N7T 8B1. Pêches et des Océans, 201, rue Front Nord, Bureau 703, Sarnia (Ontario) N7T 8B1. Brockville, April 29, 2000 Brockville, le 29 avril 2000 DOUG CAMPBELL Le président Chairman DOUG CAMPBELL [18-1-o] [18-1-o]

SUN LIFE TRUST COMPANY COMPAGNIE DE FIDUCIE SUN LIFE CHANGE OF NAME CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE Notice is herebygiven that, in accordance with the provisions Avis est par les présentes donné que, conformément aux dis- of the Trust and Loan Companies Act (Canada), Sun Life Trust positions de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada), Company, a wholly-owned subsidiary of Laurentian Bank of la Compagnie de fiducie Sun Life, une filiale en propriété exclu- Canada, intends to make an application to the Minister of Finance sive de la Banque Laurentienne du Canada, a l’intention de de- to approve the change of its name to B2B Trust. mander au ministre des Finances l’autorisation de changer sa dénomination sociale à B2B Trust. Montréal, March 2, 2000 Montréal, le 2 mars 2000 SUZANNE MASSON La secrétaire Secretary SUZANNE MASSON [15-4-o] [15-4-o]

UNIGARD SECURITY INSURANCE COMPANY UNIGARD SECURITY INSURANCE COMPANY CHANGE OF NAME CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE Notice is herebygiven that UNIGARD SECURITY INSUR- Avis est par les présentes donné que la UNIGARD SECURITY ANCE COMPANY intends to make an application to the Su- INSURANCE COMPANY a l’intention de présenter une de- perintendent of Financial Institutions Canada pursuant to mande au surintendant des institutions financières du Canada, en section 576 of the Insurance Companies Act to change the name vertu de l’article 576 de la Loi sur les sociétés d’assurances,vi- under which it is authorized to insure risks to SEATON sant à changer la raison sociale sous laquelle celle-ci est autorisée INSURANCE COMPANY. à garantir des risques à SEATON INSURANCE COMPANY. Vancouver, March 27, 2000 Vancouver, le 27 mars 2000 JOHN D. SAPINSKY L’agent principal Chief Agent JOHN D. SAPINSKY [15-4-o] [15-4-o] Le 29 avril 2000 Gazette du Canada Partie I 1359

PROPOSED REGULATIONS RÈGLEMENTS PROJETÉS

Table of Contents Table des matières

Page Page Health, Dept. of Santé, min. de la Regulations Amending the Food and Drug Regulations Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et (1097 — Aminopeptidase) [Erratum] ...... 1360 drogues (1097 — aminopeptidase) [Erratum] ...... 1360 1360 Canada Gazette Part I April 29, 2000

(Erratum)(Erratum) Regulations Amending the Food and Drug Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et Regulations (1097 — Aminopeptidase) drogues (1097 — aminopeptidase) Statutory Authority Fondement législatif Food and Drugs Act Loi sur les aliments et drogues Sponsoring Department Ministère responsable Department of Health Ministère de la Santé Notice is herebygiven that in the above-mentioned Regulations Avis est par les présentes donné que dans le règlement sus- published on page 1200 of the Canada Gazette, Part I, Vol. 134, mentionné publiéàlapage 1200 de la Partie I de la Gazette du No. 16, dated Saturday,April 15, 2000, the table on page 1203 Canada, vol. 134, no 16, en date du samedi 15 avril 2000, la ver- should have read as follows: sion anglaise du tableau à la page 1203 aurait dû se lire comme suit :

Column III Column IV Column III Column IV Item Item No. Permitted in or Upon Maximum Level of Use No. Permitted in or Upon Maximum Level of Use M.1 (2) Dairy based flavouring (2) Good Manufacturing Practice M.1 (2) Dairy based flavouring (2) Good Manufacturing Practice preparations preparations (3) Hydrolyzed animal, milk and (3) Good Manufacturing Practice (3) Hydrolyzed animal, milk and (3) Good Manufacturing Practice vegetable protein vegetable protein

[18-1-o] [18-1-o] Le 29 avril 2000 Gazette du Canada Partie I 1361

INDEX MISCELLANEOUS NOTICES — Continued Donohue Forest Products Inc., bridge over Stelkuz Creek, No. 18 — April 29, 2000 B.C...... 1352 Donohue Forest Products Inc., bridge over Tsaydiz Creek, (An asterisk indicates a notice previously published.) B.C...... 1353 *First Catholic Slovak Ladies Association of the United States of America (The), release of assets...... 1353 COMMISSIONS Flex Leasing II, LLC and Flex Leasing Corporation, Canadian Radio-television and Telecommunications documents deposited...... 1354 Commission *GE Global Insurance Holding Corporation, letters patent.. 1355 *Addresses of CRTC offices — Interventions...... 1340 Killins, Brian, and Elaine Killins, expansion of the existing Decisions oyster lease site in the Lemmens Inlet, B.C...... 1348 2000-102 to 2000-104 ...... 1340 *Lake Erie & Detroit River Railway Company (The), Public Hearings annual and special meeting of shareholders...... 1355 2000-3...... 1341 Loblaw Properties Limited, vehicular and pedestrian bridge 2000-4...... 1344 over the Sackville River, N.S...... 1355 Public Notices London, City of, footbridge over the Thames River, Ont..... 1348 2000-55...... 1345 National City Bank, application to establish a foreign bank 2000-56...... 1345 branch ...... 1356 NAFTA Secretariat ORGANIZATION FOR THE SUPPORT OF Solder joint pressure pipe fittings and solder joint VIETNAMESE REFUGEES, surrender of charter...... 1356 drainage, waste and vent pipe fittings — Decision ...... 1346 Procor Limited, documents deposited ...... 1356 *RBC Life Insurance Company and Westbury Canadian GOVERNMENT HOUSE Life Insurance Company, letters patent of amalgamation. 1357 Awards to Canadians ...... 1334 SONYA’S MARIONNETTE THEATRE INC., surrender of charter...... 1357 GOVERNMENT NOTICES *Sun Life Trust Company, change of name...... 1358 Health, Dept. of St. Lawrence Artificial Reef Association, artificial reef in Food and Drugs Act the St. Lawrence River, Ont...... 1357 Food and Drug Regulations — Amendment (alpha- *UNIGARD SECURITY INSURANCE COMPANY, amylase enzyme) ...... 1335 change of name ...... 1358 Food and Drug Regulations — Amendment (glucose Woods, Clarence Michael, and Patrick Donald Koreski, isomerase enzyme) ...... 1335 expansion of an oyster farm in Lemmens Inlet, B.C...... 1349 Food and Drug Regulations — Amendment (pullulanase enzyme)...... 1336 PARLIAMENT Superintendent of Financial Institutions, Office of the House of Commons Bank Act *Filing applications for private bills (2nd Session, Habib Canadian Bank, letters patent of incorporation ...... 1338 36th Parliament)...... 1339 Senate MISCELLANEOUS NOTICES Royal Assent *Associates Financial Life Insurance Company, application Bills assented to ...... 1339 for an order ...... 1348 Commercial Travelers Mutual Insurance Company, release PROPOSED REGULATIONS of assets...... 1349 Health, Dept. of Corner Brook Pulp and Paper Limited, bridge over the Food and Drugs Act Main River, Nfld...... 1350 Regulations Amending the Food and Drug Regulations Cortes Island Shellfish Growers Co-operative, off-bottom (1097 — Aminopeptidase) [Erratum]...... 1360 oyster culture in Talbot Cove, B.C...... 1350 DJJ Leasing Ltd., Joseph Leasing Ltd., ECDC SUPPLEMENTS Environmental, L.C. and I&M Rail Link, L.L.C., Superintendent of Financial Institutions, Office of the documents deposited...... 1351 Insurance Companies and Fraternal Benefit Societies Donohue Forest Products Inc., bridge over McGraw Creek, B.C...... 1351 Donohue Forest Products Inc., bridge over Russel Creek, B.C...... 1352 1362 Canada Gazette Part I April 29, 2000

INDEX AVIS DIVERS (suite)

o Woods, Clarence Michael, et Patrick Donald Koreski, N 18 — Le 29 avril 2000 agrandissement d’un parc à huîtres dans le bras de mer Lemmens (C.-B.) ...... 1349 (L’astérisque indique un avis déjà publié.) AVIS DU GOUVERNEMENT Santé, min. de la AVIS DIVERS Loi sur les aliments et drogues *Associates Financial Life Insurance Company, demande Règlement sur les aliments et drogues — Modification d’ordonnance ...... 1348 (enzyme alpha-amylase)...... 1335 *Compagnie d’assurance vie RBC et Wesbury Canadienne, Règlement sur les aliments et drogues — Modification Compagnie d’Assurance Vie, lettres patentes de fusion... 1357 (enzyme glucose-isomérase) ...... 1335 Compagnie Mutuelle D’Assurances Commercial Règlement sur les aliments et drogues — Modification Travellers, libération d’actif...... 1349 (enzyme pullulanase)...... 1336 *Compagnie de fiducie Sun Life, changement de Surintendant des institutions financières, bureau du dénomination sociale ...... 1358 Loi sur les banques Corner Brook Pulp and Paper Limited, pont au-dessus de la Banque Habib Canadienne, lettres patentes de rivière Main (T.-N.) ...... 1350 constitution...... 1338 Cortes Island Shellfish Growers Co-operative, ostréiculture en suspension dans l’anse Talbot (C.-B.)...... 1350 COMMISSIONS DJJ Leasing Ltd., Joseph Leasing Ltd., ECDC Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications Environmental, L.C. et I&M Rail Link, L.L.C., dépôt de canadiennes documents...... 1351 *Adresses des bureaux du CRTC — Interventions...... 1340 Donohue Forest Products Inc., pont au-dessus du ruisseau Audiences publiques McGraw (C.-B.)...... 1351 2000-3...... 1341 Donohue Forest Products Inc., pont au-dessus du ruisseau 2000-4...... 1344 Russel (C.-B.) ...... 1352 Avis publics Donohue Forest Products Inc., pont au-dessus du ruisseau 2000-55...... 1345 Stelkuz (C.-B.) ...... 1352 2000-56...... 1345 Donohue Forest Products Inc., pont au-dessus du ruisseau Décisions Tsaydiz (C.-B.)...... 1353 2000-102 à 2000-104...... 1340 *First Catholic Slovak Ladies Association of the United Secrétariat de l’ALÉNA States of America (The), libération d’actif...... 1353 Raccords de tuyauterie à souder de types à pression et à Flex Leasing II, LLC et Flex Leasing Corporation, dépôt de drainage, renvoi et évent — Décision ...... 1346 documents...... 1354 *GE Global Insurance Holding Corporation, lettres PARLEMENT patentes ...... 1355 Chambre des communes Killins, Brian, et Elaine Killins, agrandissement d’un bail *Demandes introductives de projets de loi privés huîtrier actuellement dans le bras de mer Lemmens (2e session, 36e législature)...... 1339 (C.-B.)...... 1348 Sénat *Lake Erie & Detroit River Railway Company (The), Sanction royale assemblée extraordinaire et annuelle des actionnaires...... 1355 Projets de loi sanctionnés...... 1339 Loblaw Properties Limited, pont-route et passerelle au-dessus de la rivière Sackville (N.-É.) ...... 1355 RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL London, City of, passerelle au-dessus de la rivière Thames Décorations à des Canadiens ...... 1334 (Ont.)...... 1348 National City Bank, demande d’établissement d’une RÈGLEMENTS PROJETÉS succursale de banque étrangère...... 1356 Santé, min. de la ŒUVRE DU SOUTIEN AUX RÉFUGIÉS Loi sur les aliments et drogues VIETNAMIENS, abandon de charte...... 1356 Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et Procor Limited, dépôt de documents ...... 1356 drogues (1097 — aminopeptidase) [Erratum] ...... 1360 St. Lawrence Artificial Reef Association, récif artificiel dans le fleuve Saint-Laurent (Ont.)...... 1357 SUPPLÉMENTS THÉÂTRE DE MARIONNETTES SONYA INC., abandon Surintendant des institutions financières, bureau du de charte...... 1357 Sociétés d’assurances et sociétés de secours mutuel *UNIGARD SECURITY INSURANCE COMPANY, changement de dénomination sociale ...... 1358 Supplement Supplément Canada Gazette, Part I Gazette du Canada, Partie I April 29, 2000 Le 29 avril 2000

INSURANCE COMPANIES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES AND ET FRATERNAL BENEFIT SOCIÉTÉS DE SECOURS SOCIETIES MUTUEL

Registered to do business in Canada under the Enregistrées pour faire des affaires au Canada en vertu de la Insurance Companies Act as at March 31, 2000. Loi sur les sociétés d’assurances au 31 mars 2000. 2 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

TABLE OF CONTENTS TABLE DES MATIÈRES

PagePage

Insurance Companies...... 3 Sociétés d’assurances ...... 3 Fraternal Benefit Societies...... 41 Sociétés de secours mutuel ...... 41 Notes...... 44 Remarques ...... 44

______Prepared by the Office of the Superintendent of Financial Institutions, Canada in Préparé par le Bureau du surintendant des institutions financières, Canada con- accordance with section 585 of the Insurance Companies Act. formément à l’article 585 de la Loi sur les sociétés d’assurances. Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 3

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement ACE INA Insurance Property, Accident and sickness, Voir-Assurance ACE INA 250 Yonge Street, Suite 1400 Aircraft, Automobile, Boiler and Toronto, Ontario M5B 2L7 machinery, Fidelity,Hail, Samuel B. Cupp, President and Liability and Surety. Chief Executive Officer. Aegon Insurance Company (U.K.) Limited Property, Aircraft and Liability, Aegon Insurance Company (U.K.) Limited Biens, aériennes et responsabilité, 57 Lakeshore Road East, No. 1 limited to the servicing of 57, chemin Lakeshore Est, No 1 limitée à l’écoulement des Mississauga, Ontario L5G 1C9 existingpolicies. Mississauga (Ontario) L5G 1C9 polices existantes. Eric G. Winn, Chief Agent. Eric G. Winn, Agent principal. Ætna Life Insurance Company Life, Personal accident and Ætna Life Insurance Company Vie, accidents corporels et T-D Bank Tower, 42nd Floor Sickness. T-D Bank Tower, 42e étage maladie. Box 20, Suite 4200, T-D Centre C.P. 20, Bureau 4200, T-D Centre Toronto, Ontario M5K 1N6 Toronto (Ontario) M5K 1N6 Robert W. McDowell, Chief Agent. Robert W. McDowell, Agent principal. Affiliated F M Insurance Company Property, Boiler and machinery, Affiliated F M Insurance Company Biens, chaudières et machines, 155 Gordon Baker Rd., Suite 202 Fidelity, Liability and Surety. 155, chemin Gordon Baker, Bureau 202 abus de confiance, responsabilité Willowdale, Ontario M2H 3N7 Willowdale (Ontario) M2H 3N7 et caution. Perry Brazeau, Chief Agent. Perry Brazeau, Agent principal. AIG Life Insurance Company of Canada Life, Accident and sickness. Voir-La Compagnie d’Assurance-Vie 145 Wellington Street West, 8th Floor AIG du Canada Toronto, Ontario M5J 2T4 Ralph J. Gaudio, President and Chief Executive Officer. Alexander Hamilton Life Insurance Life, Accident and sickness, Alexander Hamilton Life Insurance Vie, accidents et maladie, limitée à Company of America limited to the servicing of Company of America la gestion des polices émises 3400 One policies issued prior to 3400, One First Canadian Place avant le 1er janvier 1997. P.O. Box 130 January 1, 1997. C.P. 130 Toronto, Ontario M5X 1A4 Toronto (Ontario) M5X 1A4 Stephen Paddon, Chief Agent. Stephen Paddon, Agent principal. Allianz Insurance Company of Canada Property, Accident and sickness, Voir-Compagnie d’Assurance Allianz du 10 York Mills Road, Suite 700 Aircraft, Automobile, Boiler and Canada Toronto, Ontario M2P 2G5 machinery, Credit, Fidelity, Robert E. Maynard, President and Chief Legal expense, Liability and Executive Officer. Surety. Allianz Life Insurance Company of Life, Accident and sickness. Allianz Life Insurance Company of Vie, accidents et maladie. North America North America 2005 Sheppard Avenue East, 2005, av. Sheppard Est, Bureau 700 Suite 700 Willowdale (Ontario) M2J 5B4 Willowdale, Ontario M2J 5B4 Doreen G. Johnston, Agent principal. Doreen G. Johnston, Chief Agent. Allstate Insurance Company Property, Aircraft, Automobile, Allstate Insurance Company Biens, aériennes, automobile, 10 Allstate Parkway Boiler and machinery, Fidelity, 10 Allstate Parkway chaudières et machines, Markham, Ontario L3R 5P8 Hail, Liability and Surety. Markham (Ontario) L3R 5P8 détournements, grêle, Paul R. Morin, Chief Agent. Paul R. Morin, Agent principal. responsabilité et caution. Allstate Insurance Company of Canada Property, Accident and sickness, Allstate du Canada, Compagnie d’Assurance Biens, accidents et maladie, 10 Allstate Parkway Automobile, Boiler and 10 Allstate Parkway automobile, chaudières et Markham, Ontario L3R 5P8 machinery,Legal expense, Markham (Ontario) L3R 5P8 machines, frais juridiques, Michael L. Haskell, President Fidelity, Liability and Surety. Michael L. Haskell, Président et détournements, responsabilité et and Chief Executive Officer. chef de la direction. caution. Allstate Life Insurance Company Life, Accident and sickness, Allstate Life Insurance Company Vie, accidents et maladie, limitée à 10 Allstate Parkway limited to the servicing of 10 Allstate Parkway la gestion des polices émises Markham, Ontario L3R 5P8 policies issued prior to Markham (Ontario) L3R 5P8 avant le 15 novembre 1996. Paul R. Morin, Chief Agent. November 15, 1996. Paul R. Morin, Agent principal. Allstate Life Insurance Company of Canada Life, Accident and sickness, Allstate du Canada, Compagnie Vie, accidents et maladie, limitée à 10 Allstate Parkway limited to the servicing of d’Assurance-Vie la gestion des polices émises Markham, Ontario L3R 5P8 policies issued prior to 10 Allstate Parkway avant le 15 novembre 1996. Michael L. Haskell, President November 15, 1996. Markham (Ontario) L3R 5P8 and Chief Executive Officer. Michael L. Haskell, Président et chef de la direction. Alpina Insurance Company Limited Property, Automobile and Alpina Insurance Company Limited Biens, automobile et 400 University Ave. Liability, limited to the servicing 400, av. University responsabilité, limitée à Toronto, Ontario M5G 1S7 of existingpolicies. Toronto (Ontario) M5G 1S7 l’écoulement des polices Barry John Gilway, Chief Agent. Barry John Gilway,Agent principal. existantes. Alta Surety Company Fidelity and Surety, limited to the Voir-La Compagnie de Cautionnement Alta 800 René-Lévesque Blvd. West servicing of existingpolicies. Suite 2795 Montréal, Quebec H3B 1X9 Aram Semerjian, President. 4 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement American Bankers Insurance Company Property, Accident and sickness, American Bankers Compagnie Biens, accidents et maladie, of Florida Automobile, Credit, Fidelity, d’Assurances Générales automobile, détournements, 5001 Yonge Street, Suite 1700 Surety and Liability, on the de la Floride crédit, responsabilité et caution, North York, Ontario M2N 6T7 condition that if in the 5001, rue Yonge, Bureau 1700 pourvu que, si la société utilise Mark S.J. Scime, Chief Agent. transaction of its business in North York (Ontario) M2N 6T7 une dénomination sociale Canada the company uses a Mark S.J. Scime, Agent principal. française dans le cadre de French form of name, that name l’exercice de son activité au shall be “American Bankers Canada, ce soit « American Compagnie d’Assurances Bankers Compagnie Générales de la Floride”. d’Assurances Générales de la Floride ». American Bankers Life Assurance Company Life, Accident and sickness, on the American Bankers Compagnie Vie, accidents et maladie à la of Florida condition that if in the d’Assurances-Vie de la condition que, si la Compagnie 5001 Yonge Street, Suite 1700 transaction of its business in Floride utilise un nom français dans ses North York, Ontario M2N 6T7 Canada the Company uses a 5001, rue Yonge, Bureau 1700 affaires au Canada, ce nom serait Mark S.J. Scime, Chief Agent. French form of name that name North York (Ontario) M2N 6T7 « American Bankers Compagnie shall be “American Bankers Mark S.J. Scime, Agent principal. d’Assurances-Vie de la Floride ». Compagnie d’Assurances-Vie de la Floride”. American Home Assurance Company Property, Accident and sickness, American Home Assurance Company Biens, accidents et maladie, 145 Wellington St. West Aircraft, Automobile, Boiler and 145, rue Wellington Ouest aériennes, automobile, Toronto, Ontario M5J 1H8 machinery, Credit, Fidelity,Hail, Toronto (Ontario) M5J 1H8 chaudières et machines, crédit, Gary A. McMillan, Chief Agent. Liability and Surety. Gary A. McMillan, Agent principal. détournements, grêle, responsabilité et caution. American Income Life Insurance Company Life, Accident and sickness. American Income Life Insurance Company Vie, accidents et maladie. c/o McLean & Kerr a/s McLean & Kerr 130 Adelaide Street West 130, rue Adelaide Ouest, Bureau 2800 Suite 2800 Toronto (Ontario) M5H 3P5 Toronto, Ontario M5H 3P5 Robin B. Cumine, C.R., Agent principal. Robin B. Cumine, Q.C., Chief Agent. American National Fire Insurance Company Fire, Accident, Automobile, Boiler American National Fire Insurance Company Incendie, accidents, automobile, 40 King Street West excluding machinery, 40, rue King Ouest biens immeubles, biens meubles, Scotia Plaza, Suite 2100 Earthquake, Explosion, Forgery, Scotia Plaza, Bureau 2100 brise des glaces, chaudières (les Toronto, Ontario M5H 3C2 Hail, Inland transportation, Toronto (Ontario) M5H 3C2 machines non comprises), J. Brian Reeve, Chief Agent. Personal property,Plateglass, J. Brian Reeve, Agent principal. explosions, faux, grêle, Real property, Theft and transports terrestres, additional classes 3, 5, 7, 8, 9 tremblements de terre, vol et and 10. (See Note (B)) catégories additionnelles 3, 5, 7, 8, 9 et 10. (Voir Remarque (B)) American Re-Insurance Company Property, Accident and sickness, American Re-Insurance Company Biens, accidents et maladie, 250 Yonge Street, P.O. Box 20 Aircraft, Automobile, Boiler and 250, rue Yonge accidents d’aviation, automobile, Suite 2010 machinery, Credit, Fidelity,Hail, C.P. 20, Bureau 2010 chaudières et machines, crédit, Toronto, Ontario M5B 2L7 Liability and Surety. Toronto (Ontario) M5B 2L7 abus de confiance, grêle, Randolph B. Scott, Chief Agent. Randolph B. Scott, Agent principal. responsabilité et caution. The American Road Insurance Company Property, Automobile, Boiler and The American Road Insurance Company Biens, automobile, chaudières et 1145 Nicholson Road, Unit 2 machinery (limited to the 1145, chemin Nicholson, Unité 2 machines (limitée à la province Newmarket, Ontario L3Y 7V1 Province of Alberta and vehicle Newmarket (Ontario) L3Y 7V1 de l’Alberta, et l’assurance de Colleen Sexsmith, Chief Agent. warranty insurance as defined by Colleen Sexsmith, Agent principal. garantie des véhicules telle que the Classes of Insurance définie par le règlement pertinent Regulations of the Province of de la province de l’Alberta), Alberta), Credit, Liability and crédit, responsabilité et caution. Surety. AMEX Assurance Company Life, Accident and sickness, to the AMEX Compagnie d’Assurance Vie, accidents et maladie, dans la 60 Bloor St. West, Suite 403 extent authorized by its articles 60, rue Bloor Ouest, Bureau 403 mesure prévue par ses articles Toronto, Ontario M4W 3L8 of incorporation and limited to Toronto (Ontario) M4W 3L8 constitutifs et se limitant à Judy K. S. Ha, Chief Agent. group airflight insurance and Judy K. S. Ha, Agent principal. l’assurance collective des group travel accident insurance, occupants d’avions et à on the condition that if in the l’assurance collective contre les transaction of its business in accidents de voyage, pourvu que, Canada the company uses a si la société utilise une French form of name, that name dénomination sociale française shall be “AMEX Compagnie dans le cadre de l’exercice de d’Assurance”. son activité au Canada, ce soit «AMEXCompagnie d’Assurance ». See-Old Republic Insurance Company L’Ancienne République, Compagnie Biens, aériennes, automobile et of Canada d’Assurance du Canada responsabilité. 100, rue King Ouest, C.P. 557 Hamilton (Ontario) L8N 3K9 Frank Szirt, Président et chef de la direction. Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 5

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement Anglo Canada General Insurance Company Property, Accident and sickness, Anglo Canada General Insurance Company Biens, accidents et maladie, 5700 Yonge Street, Suite 1400 Automobile, Boiler and 5700, rue Yonge, Bureau 1400 automobile, chaudières et North York, Ontario M2M 4K2 machinery, Fidelity,Hail, North York (Ontario) M2M 4K2 machines, détournements, grêle, JosephK.Fung, Chief Financial Officer. Liability and Surety, limited to JosephK.Fung, Chef des finances. responsabilité et caution, limitée the business of reinsurance. aux affaires de réassurance. Antigonish Farmers’ Mutual Fire Fire, Public liability,Theft,and Antigonish Farmers’ Mutual Fire Incendie, responsabilité civile, vol, Insurance Company additional classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, Insurance Company et catégories additionnelles 1, 2, P.O. Box 1535 7, 8, 9 and 10 (See Note (B)), C.P. 1535 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 (voir Antigonish, Nova Scotia B2G 2L8 restricted to the Province of Antigonish (Nouvelle-Écosse) B2G 2L8 Remarque (B)), restreint à la W. J. Chisholm, Secretary- Nova Scotia. W. J. Chisholm, Secrétaire-trésorier province de la Nouvelle-Écosse. Treasurer and Manager. et directeur. Assicurazioni Generali S.p.A. Property, Automobile, Fidelity, Assicurazioni Generali S.p.A. Biens, automobile, détournements, 1000 rue de la Gauchetière West Hail, Legal expense, Liability, 1000, rue de la Gauchetière Ouest grêle, frais juridiques, Suite 500 and Surety, limited to the Bureau 500 responsabilité et caution, limitée Montréal, Quebec H3B 4W5 business of reinsurance. Montréal (Québec) H3B 4W5 aux affaires de réassurance. W. J. Green, Chief Agent. W. J. Green, Agent principal. Assitalia-Le Assicurazioni d’Italia S.P.A. Property and liability, limited to Assitalia-Le Assicurazioni d’Italia S.P.A. Biens et responsabilité, limitée à 1190 Hornby Street, Suite 1000 the servicing of existingpolicies. 1190, rue Hornby, Bureau 1000 l’administration des polices Vancouver British Columbia V6Z 2W2 Vancouver existantes. D. Jay Smith, Chief Agent. (Colombie-Britannique) V6Z 2W2 D. Jay Smith, Agent principal. Associates Insurance Company Automobile, limited to the Associates Insurance Company Automobile, limitée à c/o Blake, Cassels & Graydon servicing of existingpolicies. a/s Blake, Cassels & Graydon l’administration des polices P.O. Box 25 C.P. 25, West existantes. Commerce Court West Toronto (Ontario) M5L 1A9 Toronto, Ontario M5L 1A9 Barry G. McGee, Agent principal. Barry G. McGee, Chief Agent. See-ACE INA Insurance Assurance ACE INA Biens, accidents et maladie, 250, rue Yonge, Bureau 1400 aériennes, automobile, Toronto (Ontario) M5B 2L7 chaudières et machines, Samuel B. Cupp, Président et chef détournements, grêle, de la direction. responsabilité et caution. See-Trade Indemnity P.L.C. Assurances Trade Indemnity Crédit, limitée à l’écoulement des 320, chemin March, Bureau 103 polices existantes. Kanata (Ontario) K2K 2D3 Ian Douglas Miller, Agent principal. Avemco Insurance Company Accident and sickness, Aircraft. Avemco Insurance Company Accidents et maladie, accidents 133 Richmond St. West 133, rue Richmond Ouest, Bureau 600 d’aviation. Suite 600 Toronto (Ontario) M5H 2L3 Toronto, Ontario M5H 2L3 Donald G. Smith, Agent principal. Donald G. Smith, Chief Agent. Aviation & General Insurance Aircraft and Liability. Aviation & General Insurance Accidents d’aviation et Company Limited Company Limited responsabilité. c/o British Aviation Insurance Group a/s British Aviation Insurance Group (Canada) Ltd. (Canada) Ltd. 100 Renfrew Drive, Suite 200 100, promenade Renfrew, Bureau 200 Markham, Ontario L3R 9R6 Markham (Ontario) L3R 9R6 Murray Frank Bartel, Chief Agent. Murray Frank Bartel, Agent principal. AXA Insurance (Canada) Property, Accident and sickness, AXA Assurances (Canada) Biens, accidents et maladie, 5700 Yonge Street, Suite 1400 Automobile, Boiler and 5700, rue Yonge, Bureau 1400 automobile, chaudières et North York, Ontario M2M 4K2 machinery, Fidelity,Hail, North York (Ontario) M2M 4K2 machines, détournements, grêle, JosephK.Fung, Chief Financial Officer. Liability and Surety. JosephK.Fung, Chef des finances. responsabilité et caution. AXA Pacific Insurance Company Property, Accident and sickness, AXA Pacifique Compagnie d’Assurance Biens, accidents et maladie, 999 West Hastings Street Aircraft, Automobile, Boiler and 999, rue West Hastings aériennes, automobile, Vancouver, British Columbia V6C 2W2 machinery, Credit, Fidelity,Hail, Vancouver chaudières et machines, crédit, Robert P. Vickerstaff, President Liability and Surety. (Colombie-Britannique) V6C 2W2 détournements, grêle, and Chief Operating Officer. Robert P. Vickerstaff, Président et responsabilité et caution. chef des opérations. Axa Réassurance Life, Property, Accident and Axa Réassurance Vie, biens, accidents et maladie, 1800 McGill College, Suite 2000 sickness, Aircraft, Automobile, 1800, McGill College, Bureau 2000 aériennes, automobile, Montréal, Quebec H3A 3J6 Boiler and Machinery, Fidelity, Montréal (Québec) H3A 3J6 chaudières et machines, Claire Gariépy, Chief Agent. Hail, Liability and Surety, Claire Gariépy,Agent principal. détournements, grêle, limited to the business of responsabilité et caution, limitée reinsurance. aux affaires de réassurance. Balboa Insurance Company Property and Accident and Balboa Insurance Company Biens et accidents et maladie, 201 Queens Avenue sickness, limited to the servicing 201, av. Queens limitée à l’écoulement des P.O. Box 5071, Terminal A of existingpolicies. C.P. 5071, Terminus A polices existantes. London, Ontario N6A 4M5 London (Ontario) N6A 4M5 Anthony W. Miles, Chief Agent. Anthony W. Miles, Agent principal. 6 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement Balboa Life Insurance Company Life, and Accident and sickness La Balboa, compagnie d’assurance-vie Vie, et accidents et maladie (les 201 Queens Avenue (accident and sickness insurance 201, av. Queens opérations d’assurance accidents P.O. Box 5071, Terminal A is limited to the servicing of C.P. 5071, Terminus A et maladie sont limitées à London, Ontario N6A 4M5 existingpolicies). London (Ontario) N6A 4M5 l’écoulement des polices Anthony W. Miles, Chief Agent. Anthony W. Miles, Agent principal. existantes). Bankers Life and Casualty Company Life, Accident and sickness, Bankers Life and Casualty Company Vie, accidents et maladie, limitée à c/o Fasken Campbell Godfrey limited to the servicing of a/s Fasken Campbell Godfrey la gestion des polices émises Toronto-Dominion Centre, policies issued prior to Toronto-Dominion Centre, avant le 10 décembre 1999, sauf P.O. Box 20, Suite 4200 December 10, 1999, with the C.P. 20, Bureau 4200 qu’elle peut assurer la vie de Toronto, Ontario M5K 1N6 exception that the foreign Toronto (Ontario) M5K 1N6 résidents fu Canada qu’emploie Robert W. McDowell, Chief Agent. company mayprovide insurance Robert W. McDowell, Agent principal. l’un de ses clients des États-Unis on the lives of Canadian ou un membre du groupedel’un residents employed by a United de ces mêmes clients. States client of the foreign company or an affiliate of one of its United States clients. Blue Cross Life Insurance Company Life, Accident and sickness. Voir-Compagnie d’Assurance-Vie Croix of Canada Bleue du Canada. P.O. Box 220, 644 Main Street Moncton, New Brunswick E1C 8L3 Pierre-Yves Julien, President and Chief Executive Officer. The Boiler Inspection and Insurance Property, Boiler and machinery Voir-La Compagnie d’Inspection et Company of Canada and Liability. d’Assurance Chaudières et Machinerie. 18 King St. East Toronto, Ontario M5C 1C4 Hans A. Schols, President and General Manager. See-Canadian Northern Shield Insurance Le Bouclier du Nord Canadien, Biens, accidents et maladie, Company. Compagnie d’Assurance automobile, chaudières et C.P. 12133, Bureau 1900 machines, abus de confiance, 555, rue West Hastings responsabilité et caution. Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 4N6 T. Michael Porter, Président et chef de la direction. The British Aviation Insurance Accident, Aircraft and Inland The British Aviation Insurance Company Accidents, aéronefs et transports Company Limited transportation. Limited terrestres. 100 Renfrew Drive, Suite 200 100, promenade Renfrew, Bureau 200 Markham, Ontario L3R 9R6 Markham (Ontario) L3R 9R6 Murray Frank Bartel, Chief Agent. Murray Frank Bartel, Agent principal. Caisse Centrale de Réassurance Property, Accident and sickness, Caisse Centrale de Réassurance Biens, accidents et maladie, c/o Jacques Davis Lefaivre & cie Ltée Aircraft, Automobile, Boiler and a/s Jacques Davis Lefaivre & cie Ltée aériennes, automobile, 1080 Beaver Hall Hill, 19th Floor Machinery, Fidelity,Legal 1080, côte du Beaver Hall, 19e étage chaudières et machines, , Quebec H2Z 1S8 expense, Liability and Surety, Montréal (Québec) H2Z 1S8 détournements, frais juridiques, Jacques Mailloux, Chief Agent limited to the business of Jacques Mailloux, Agent principal responsabilité et caution, limitée reinsurance. aux affaires de réassurance.

Calvert Insurance Company Property, Automobile and Calvert Insurance Company Biens, automobile et c/o Focus Group Inc. Liability. a/s Focus Group Inc. responsabilité. 36 King Street East, Suite 500 36, rue King Est, Bureau 500 Toronto, Ontario M5C 1E5 Toronto (Ontario) M5C 1E5 Philip H. Cook, Chief Agent. Philip H. Cook, Agent principal. The Canada Life Assurance Company Life, Accident and sickness. Voir-La Compagnie d’Assurance du Canada 330 University Ave. sur la Vie. Toronto, Ontario M5G 1R8 David Alexander Nield, President and Chief Executive Officer. Canada Life Casualty Insurance Company Property, Accident and sickness, Canada-Vie Compagnie D’Assurance Biens, accidents et maladie, c/o Canada Life Assurance Company Automobile, Boiler and Générales automobile, chaudières et 330 University Ave. machinery,Legal expense and a/s La Compagnie d’Assurance du Canada machines, frais juridiques et Toronto, Ontario M5G 1R8 Liability. sur la Vie responsabilité. David Victor Newton, President and 330, av. University Chief Operating Officer. Toronto (Ontario) M5G 1R8 David Victor Newton, Président et chef Des opérations. Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 7

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement Canada Life Financial Corporation Life Voir-Corporation Financière Canada-Vie Vie 330 University Ave Toronto, Ontario M5G 1R8 David Nield, President and Chief Executive officer Canadian Northern Shield Insurance Property, Accident and sickness, Voir-Le Bouclier du Nord Canadien, Company Automobile, Boiler and Compagnie d’Assurance. P.O. Box 12133 machinery, Fidelity, Liability and 1900–555 West HastingsSt. Surety. Vancouver, British Columbia V6B 4N6 T. Michael Porter, President and Chief Executive Officer. Canadian Premier Life Insurance Company Life, Accident and sickness. Voir-Compagnie d’assurance-vie Première 80 Tiverton Court, Suite 500 du Canada. Markham, Ontario L3R 0G4 Aaron Hill, Vice-President and Chief Executive Officer. Centennial Insurance Company Property, Accident and sickness, Centennial Insurance Company Biens, accidents et maladie, c/o Focus Group Inc. Aircraft, Automobile, Boiler and a/s Focus Group Inc. aériennes, automobile, 36 King Street East, Suite 500 machinery, Hail, Fidelity and 36, rue King Est, Bureau 500 chaudières et machines, grêle, Toronto, Ontario M5C 1E5 Liability. Toronto (Ontario) M5C 1E5 détournements et responsabilité. Philip H. Cook, Chief Agent. Philip H. Cook, Agent principal. See-Gold Circle Insurance Company. Cercle d’Or, Compagnie d’Assurance Biens, accidents et maladie, a/s The Great-West Life Assurance automobile et responsabilité, Company limitée à l’administration des 100, rue Osborne Nord polices existantes. Winnipeg (Manitoba) R3C 3A5 Sheila Wagar, Secrétaire. CGU Insurance Company of Canada Property, Accident and sickness, CGU, Compagnie D’Assurance du Canada Biens, accidents et maladie, 2206 Eglinton Avenue East Aircraft, Automobile, Boiler and 2206, av. Eglinton Est aériennes, automobile, Scarborough, Ontario M1L 4S8 machinery, Fidelity,Hail,Legal Scarborough (Ontario) M1L 4S8 chaudières et machines, Mark Webb, Executive Vice President and expense, Liability and Surety. Mark Webb, Vice-président exécutif détournements, grêle, frais Chief Operating Officer. et chef des opérations. juridiques, responsabilité et caution. CGU International Insurance plc Property, Liability and Aircraft. CGU International Insurance plc Biens, responsabilité et aériennes. 350 Albert Street, Suite 700 350, rue Albert, Bureau 700 Ottawa, Ontario K1R 1A4 Ottawa (Ontario) K1R 1A4 Denis Shillington, Chief Agent. Denis Shillington, Agent principal. Chancellor Reinsurance Company of Canada Property, Accident and sickness, Voir-La Compagnie de Réassurance Suite 2000, Oceanic Plaza Aircraft, Automobile, Boiler and Chancellor du Canada. 1066 West Hastings Street machinery, Credit, Fidelity,Hail, Vancouver, British Columbia V6E 3X2 Legal expense, Liability and Robert Rusko, Agent Surety, limited to the business of KPMG Chartered Accountants reinsurance. As of July 5, 1995, Agent for the Superintendent of Chancellor Reinsurance Financial Institutions, Provisional Company of Canada is in Liquidator. voluntary,courtsupervised liquidation and dissolution under the provisions of the Insurance Companies Act. KPMG Chartered Accountants has been appointed as liquidator of the company by court order. Chicago Title Insurance Company Title. Chicago Title Insurance Company Titres. 141 Adelaide Street West 141, rue Adelaide Ouest Suite 1006 Bureau 1006 Toronto, Ontario M5H 3L5 Toronto (Ontario) M5H 3L5 J. Donald Bergeron, Chief Agent. J. Donald Bergeron, Agent principal. Chieftain Insurance Company Property, Automobile and Chieftain Insurance Company Biens, automobile et 165 University Avenue Liability. 165, av. University responsabilité. Toronto, Ontario M5H 3B9 Toronto (Ontario) M5H 3B9 George L. Cooke, President and George L. Cooke, Président et Chief Executive Officer. Chef de la direction. Chrysler Insurance Company Property, Automobile, Liability Chrysler Insurance Company Biens, automobile, responsabilité 2700 Matheson Blvd. East and Surety. 2700, boul. Matheson Est et caution. Suite 400, East Tower Bureau 400, Tour Est Mississauga, Ontario L4W 4V9 Mississauga (Ontario) L4W 4V9 Richard Wong, Chief Agent. Richard Wong,Agent principal. 8 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement Chrysler Life Insurance Company of Canada Life, Accident and sickness to the Chrysler Compagnie D’Assurance-Vie Vie, accidents et maladie dans la 2700 Matheson Blvd. East extent authorized by its du Canada mesure autorisée par son acte de Suite 400, East Tower instrument of incorporation and 2700, boul. Matheson Est constitution en corporation et Mississauga, Ontario L4W 4V9 limited to the servicing of Bureau 400, Tour Est sous réserve de la restriction que Richard Wong, Chief Executive Officer. policies issued prior to Mississauga (Ontario) L4W 4V9 les affaires de la compagnie April 1, 1991. Richard Wong, Chef de la direction. soient limitées à l’écoulement des polices émises avant le 1er avril 1991. Chubb Insurance Company of Canada Property, Accident and sickness, Chubb du Canada Compagnie d’Assurance Biens, accidents et maladie, One Financial Place Aircraft, Automobile, Boiler and One Financial Place accidents d’aviation, automobile, 1 Adelaide Street East machinery, Fidelity, Liability and 1, rue Adelaide Est chaudières et machines, abus de Toronto, Ontario M5C 2V9 Surety. Toronto (Ontario) M5C 2V9 confiance, responsabilité et Janice M. Tomlinson, President. Janice M. Tomlinson, Président. caution. CIBC General Insurance Company Limited Property, Automobile, Liability Voir-Compagnie d’assurance générale 3 Robert Speck Parkway and Surety. CIBC Limitée. Suite 500, P.O. Box 7065 Mississauga, Ontario L5A 4K7 Dwight Lacey, Chief Executive Officer. CIBC Life Insurance Company Limited Life, Accident and sickness. Voir-Compagnie d’assurance-vie 3 Robert Speck Parkway CIBC Limitée. Suite 500, P.O. Box 7065 Mississauga, Ontario L5A 4K7 Gabor Kalmar, President and Chief Operating Officer. CIGNA Life Insurance Company of Canada Life, Accident and sickness, and CIGNA du Canada compagnie d’assurance Vie, accidents et maladie et perte 55 Town Centre Court, Suite 606 Loss of Employment. sur la vie d’emploi. P. O. Box 14 55, cour Town Centre, Scarborough, Ontario M1P 4X4 Bureau 606, C.P. 14 Samuel B. Cupp, President and Scarborough (Ontario) M1P 4X4 Chief Executive Officer. Samuel B. Cupp, Président et chef de la direction. The Citadel General Assurance Company Property, Accident and sickness, La Citadelle, Compagnie d’Assurances Biens, accidents et maladie, 1075 Bay St. Aircraft, Automobile, Boiler and Générales aériennes, automobile, Toronto, Ontario M5S 2W5 machinery, Fidelity,Hail,Legal 1075, rue Bay chaudières et machines, Ernst Notz, President and Chief expense, Liability,Lossof Toronto (Ontario) M5S 2W5 détournements, grêle, frais Executive Officer. Employment and Surety. Ernst Notz, Président et chef juridiques, responsabilité, perte de la direction. d’emploi et caution. Clare Mutual Insurance Company Fire and Theft and additional Clare Mutual Insurance Company Incendie et vol; et catégories Belliveau’s Cove, Nova Scotia B0W 1J0 classes1,2,3,4,5,6,7,8,9and Belliveau’s Cove additionnelles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Henri J. Thibodeau, President. 10 (See Note (B)), restricted to (Nouvelle-Écosse) B0W 1J0 8,9et10(Voir Remarque (B)), the Province of Nova Scotia. Henri J. Thibodeau, Président. restreint à la provincedela Nouvelle-Écosse. Clarica Life Insurance Company Life, Accident and Sickness. Clarica, compagnie d’assurance sur la vie Vie, accidents et maladie. 227 King St. South 227, rue King Sud Waterloo, Ontario N2J 4C5 Waterloo (Ontario) N2J 4C5 Robert M. Astley, President and Chief Robert M. Astley, Président et chef Executive Officer. de la direction. CNA Life Insurance Company of Canada Life, Accident and sickness and Voir-Compagnie d’Assurance-Vie CNA 40 Weber Street East, 7th Floor Loss of employment. du Canada. Kitchener, Ontario N2H 6R3 Robert D. Scott, President and Chief Executive Officer. Cologne Reinsurance Company Property, Aircraft, Automobile, Cologne Reinsurance Company Biens, accidents d’aviation, (Kolnische Ruckversicherungs- Boiler and machinery, Credit, (Kolnische Ruckversicherungs- automobile, crédit, chaudières et Gesellschaft Aktiengesellschaft) Fidelity, Hail, Liability and Gesellschaft Aktiengesellschaft) machines, abus de confiance, c/o D. M. Williams & Associates Ltd. Surety, limited to the business of a/s D. M. Williams & Associates Ltd. grêle, responsabilité et caution, 3650 Victoria Park Ave., Suite 201 reinsurance. 3650, av. Victoria Park, Bureau 201 limitée aux affaires de North York, Ontario M2H 3P7 North York (Ontario) M2H 3P7 réassurances. V. Lorraine Williams, Chief Agent. V. Lorraine Williams, Agent principal. Combined Insurance Company of America Life, Accident and sickness, on the Voir-Compagnie d’assurance Combined 7300 Warden Avenue condition that if in the d’Amérique. Markham, Ontario L3R 0X3 transaction of its business in Dan C. Evans, Chief Agent. Canada the Company uses a French name, that name shall be “Compagnie d’assurance Combined d’Amérique”. The Commerce Group Insurance Company Property, Accident and sickness, Voir-Le Groupe Commerce Compagnie 2450 Girouard St. West, P.O. Box 1000 Aircraft, Automobile, Boiler and d’Assurances. Saint-Hyacinthe, Quebec J2S 7C4 machinery,Legal Expense, Claude Gravel, President and Fidelity, Hail, Liability and Chief Operating Officer. Surety. Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 9

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement Commercial Travelers Mutual Insurance Accident and sickness, on the Voir-Compagnie Mutuelle D’Assurances Company (incorporated under the laws condition that the words Commercial Travelers. of the State of New York, U.S.A.) “incorporated under the laws of 8 Ranchwood Place the State of New York, U.S.A.” Brampton, Ontario L6R 1W5 will be used in conspicuous William C. Jorgens, Chief Agent. relation to the name “Commercial Travelers Mutual Insurance Company” wherever it appears in the Company’s contracts, application forms, advertisements or other published material, and on the condition that if in the transaction of its business in Canada the Company uses a French name, that name shall be “Compagnie Mutuelle D’Assurances Commercial Travelers”. The company’s business in Canada is limited to the servicing of policies issued prior to April 1, 1991. Commercial Union Life Assurance Company Life, Accident and sickness. Voir-La Compagnie d’Assurance-Vie Union of Canada Commerciale du Canada. 300 Consilium Place P.O. Box 370, Station A Scarborough, Ontario M1K 5C3 Frank J. Crowley, President and Chief Operating Officer. Commonwealth Insurance Company Property, Accident and sickness, Voir-Compagnie d’assurances Suite 1500, Bentall Three Aircraft, Automobile, Boiler and Commonwealth. 595 Burrard St. machinery, Fidelity, Liability and P.O. Box 49115 Surety. Vancouver, British Columbia V7X 1G4 John Watson, President. See-Allianz Insurance Company of Canada. Compagnie d’Assurance Allianz du Canada Biens, accidents et maladie, 10, chemin York Mills, Bureau 700 aériennes, automobile, Toronto (Ontario) M2P 2G5 chaudières et machines, crédit, Robert E. Maynard, Président et chef détournements, frais juridiques, de la direction. responsabilité et caution. See-The Canada Life Assurance Company.LaCompagnie d’Assurance du Canada Vie, accidents et maladie. sur la Vie 330, av. University Toronto (Ontario) M5G 1R8 David Alexander Nield, Président et chef de la direction. See-Combined Insurance Company of Compagnie d’assurance Combined Vie, accidents et maladie, à la America. d’Amérique condition que, si la Compagnie 7300, av. Warden utilise un nom français dans les Markham (Ontario) L3R 0X3 affaires au Canada, ce nom serait Dan C. Evans, Agent principal. «Compagnie d’assurance Combined d’Amérique ». See-Commonwealth Insurance Company.Compagnie d’assurances Commonwealth Biens, accidents et maladie, Bureau 1500, Bentall Trois accidents d’aviation, automobile, 595, rue Burrard, C.P. 49115 chaudières et machines, abus de Vancouver (Colombie-Britannique) confiance, responsabilité et V7X 1G4 caution. John Watson, Président. See-Coseco Insurance Company.Compagnie d’Assurance Coseco Biens, accident et maladie, Priory Square Guelph (Ontario) N1H 6P8 automobile et responsabilité. Terry Squire, Président et chef de la direction. See-Elite Insurance Company.LaCompagnie d’Assurances Elite Biens, accidents et maladie, 649, chemin North Service Ouest aériennes, automobile, Burlington (Ontario) L7R 4L5 chaudières et machines, Mark Webb, Vice-président exécutif détournements, responsabilité et et chef des opérations. caution. 10 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement See-Everest Insurance Company of Canada. La Compagnie d’Assurance Everest Biens, automobile, aériennes, du Canada chaudières et machines, crédit, 130, rue King Ouest détournements, grêle, The Exchange Tower, Bureau 2520 responsabilité et caution. Toronto (Ontario) M5X 1E3 William G. Jonas, Président et chef de la direction. See-Federal Insurance Company.Compagnie d’assurances Fédérale Biens, accidents et maladie, One Financial Place automobile, chaudières et 1, rue Adelaide Est machines, abus de confiance, Toronto (Ontario) M5C 2V9 responsabilité et caution, à la Janice M. Tomlinson, Agent principal. condition que, si la Compagnie utilise un nom français dans ses affaires au Canada, ce nom serait «Compagnie d’assurances Fédérale ». See-Grain Insurance and Guarantee La Compagnie d’assurance et de Biens, automobile, détournements, Company. Garantie Grain chaudières et machines, 1240, One Lombard Place responsabilité et caution. Winnipeg (Manitoba) R3B 0V9 Ralph N. Jackson, Président. See-GE Capital Casualty Company, Canada. Compagnie d’assurance GE Capital Biens, chaudières et machines au Casualty, Canada sein de la province de l’Alberta, 2023, 7495, 132e rue et l’assurance de garantie des Surrey (Colombie-Britannique) véhicules telle qu’elle est définie V3W 1J8 par le règlement pertinent de la Danielle Bolduc, Président et province de l’Alberta, et caution. chef de la direction. See-CIBC General Insurance Company Compagnie d’assurance générale Biens, automobile, responsabilité Limited. CIBC Limitée et caution. 3, promenade Robert Speck Bureau 500, C.P. 7065 Mississauga (Ontario) L5A 4K7 Dwight Lacey, Chef de la direction. See-Co-operators General Insurance La Compagnie d’Assurance Générale Biens, accidents et maladie, Company. Co-operators accidents d’aviation, automobile, Priory Square, Guelph (Ontario) N1H 6P8 chaudières et machines, crédit, Terry Squire, Président et chef frais juridiques, abus de de la direction. confiance, grêle, responsabilité et caution. See-CUMIS General Insurance Company.LaCompagnie d’Assurance Générale Biens, accidents et maladie, CUMIS automobile, chaudières et C.P. 5065, Burlington (Ontario) L7R 4C2 machines, abus de confiance, T. Michael Porter, Président et chef responsabilité et caution. de la direction. See-The Dominion of Canada General Compagnie d’assurance générale Dominion Biens, aériennes, automobile, Insurance Company. du Canada chaudières et machines, 165, av. University détournements, grêle, Toronto (Ontario) M5H 3B9 responsabilité et caution. George L. Cooke, Président et chef de la direction. See-Legacy General Insurance Company.Compagnie d’assurances générales Legacy Biens, accidents et maladie et perte 80, cour Tiverton, Bureau 500 d’emploi. Markham (Ontario) L3R 0G4 Aaron Hill, Vice-président et chef de la direction. See-Liberty Mutual Fire Insurance Company.LaCompagnie d’Assurance Générale Biens, accidents et maladie, Liberté Mutuelle détournements, aériennes, BCE Place, Bay Wellington Tower automobile, chaudières et 181, rue Bay, Bureau 3320 machines, responsabilité et Toronto (Ontario) M5J 2T3 caution, limitée à l’écoulement Gery Barry,Agent principal. des polices existantes, sauf pour la branche automobile; et pourvu que, si la société utilise une dénomination sociale française dans le cadre de l’exercice de son activité au Canada, ce soit «LaCompagnie d’Assurance Générale Liberté Mutuelle ». Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 11

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement See-RBC General Insurance Company.Compagnie d’assurance générale RBC Biens, accident et maladie, 55, promenade City Centre, Bureau 1100 automobile et responsabilité. Mississauga (Ontario) L5B 1M3 Andrew Rogacki, Président et chef de la direction See-The Halifax Insurance Company.LaCompagnie d’Assurance Halifax Biens, accidents et maladie, 75, av. Eglinton Est accidents d’aviation, automobile, Toronto (Ontario) M4P 3A4 chaudières et machines, abus de Donald K. Lough, Président. confiance, grêle, responsabilité et caution. See-Hartford Insurance Company of Canada. Compagnie d’Assurance Hartford du Canada Biens, accidents et maladie, 20, chemin York Mills accidents d’aviation, automobile, Willowdale (Ontario) M2P 2C2 chaudières et machines, abus de Gray G. Davis, Président et chef confiance, grêle, responsabilité et de la direction. caution. See-HSBC Canadian Direct Insurance La Compagnie d’Assurances HSBC Biens, automobile, accidents et Incorporated. Canadienne Direct Incorporée maladie et responsabilité. 610, rue 6e, Bureau 217 New Westminster (Colombie-Britannique) V3L 3C2 Guy Cloutier, Président et chef de la direction. See-The Mortgage Insurance Company La Compagnie d’Assurance d’Hypothèques Détournements et caution, limitée of Canada. du Canada à l’écoulement des polices 100, rue Yonge, Bureau 400 existantes, et hypothèque, limitée Toronto (Ontario) M5H 1H1 aux affaires de réassurance. Oscar Zimmerman, Président. See-GE Capital Mortgage Insurance Compagnie d’assurance d’hypothèques Hypothèque. Company (Canada). GE Capital (Canada) 2300, boul. Meadowvale Mississauga (Ontario) L5N 5P9 Peter Vukanovich, Président, chef de la direction et chef des finances. See-Jevco Insurance Company.LaCompagnie d’Assurances Jevco Biens, automobile, responsabilité 2021, Union, Bureau 1150 et caution. Montréal (Québec) H3A 2S9 William G. Star, Président du conseil, président et chef de la direction. See-Liberty Insurance Company of Canada. Compagnie d’Assurance Liberté du Canada Biens, automobile et 200, place Consilium, 8e étage responsabilité. Scarborough (Ontario) M1H 3E6 Ronald H. Switzer, Président et chef de la direction. See-Liberty Mutual Insurance Company.LaCompagnie d’Assurance Liberté Mutuelle Biens, détournements, aériennes, BCE Place, Bay Wellington Tower accidents et maladie, automobile, 181, rue Bay, Bureau 3320 chaudières et machines, Toronto (Ontario) M5J 2T3 responsabilité et caution. Gery Barry,Agent principal. See-Life Investors Insurance Company Compagnie D’Assurances Life Investors Vie, accidents et maladie. of America. D’Amérique a/s John Milnes & Associates 68, rue Scollard, 2e étage Toronto (Ontario) M5R 1G2 John R. Milnes, Agent principal. See-Lombard Insurance Company.Compagnie d’assurance Lombard Biens, aériennes, automobile, 105, rue Adelaide Ouest chaudières et machines, crédit, Toronto (Ontario) M5H 1P9 détournements, grêle, Byron G. Messier, Chef de la direction. responsabilité et caution. See-London Guarantee Insurance Company.Compagnie d’Assurance London Garantie Biens, accidents et maladie, 77, rue King Ouest, Bureau 3426 aériennes, automobile, Royal Trust Tower, C.P. 284 chaudières et machines, crédit Toronto (Ontario) M5K 1K2 (sous réserve que la personne à Robert E. Taylor, Président. qui le crédit est accordé soit présente au Canada), détournements, frais juridiques, titres, grêle, responsabilité et caution. 12 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement See-The Missisquoi Insurance Company.LaCompagnie d’Assurance Missisquoi Biens, automobile, chaudières et 625, boul. René-Lévesque Ouest machines, abus de confiance, Bureau 600 responsabilité et caution. Montréal (Québec) H3B 1R2 Jean P. Courtemanche, Président. See-New York Life Insurance Company.Compagnie d’assurances New York Life Vie, accidents et maladie, à la Scotia Plaza, Bureau 2100 condition que, si la compagnie 40, rue King Ouest utilise un nom français dans les Toronto (Ontario) M5H 3C2 affaires au Canada, ce nom serait J. Brian Reeve, Agent principal. «Compagnie d’assurances New York Life ». See-Quebec Assurance Company.Compagnie d’Assurance du Québec Biens, accidents et maladie, 3500, boul. de Maisonneuve Ouest aériennes, automobile, 2, place Alexis-Nihon, Bureau 800 chaudières et machines, Montréal (Québec) H3Z 3C1 responsabilité, détournements et Robert John Gunn, Président. caution. See-St. Paul Fire and Marine Insurance La Compagnie d’Assurance Saint Paul Biens, aériennes, automobile, Company. 121, rue King Ouest chaudières et machines, Bureau 1200, C.P. 93 détournements, responsabilité et Toronto (Ontario) M5H 3T9 caution, à la condition que Wayne McKellar Edmondson, Agent lorsque la société utilise un nom principal. français dans l’exercice de ses activités au Canada, ce nom soit «LaCompagnie d’Assurance Saint Paul ». See-The Standard Life Assurance Company.Compagnie d’assurance Standard Life Vie, accidents et maladie, et la 1245, rue Sherbrooke Ouest compagnie peut utiliser dans les Montréal (Québec) H3G 1G3 affaires au Canada son nom en Claude A. Garcia, Agent principal. anglais « The Standard Life Assurance Company »ouson nom en français « Compagnie d’assurance Standard Life », ou tous deux à la fois. See-The Standard Life Assurance Company Compagnie d’assurance Standard Life Vie. of Canada. du Canada 1245, rue Sherbrooke Ouest Montréal (Québec) H3G 1G3 Claude A. Garcia, Président et chef des opérations. See-Temple Insurance Company.Lacompagnie d’assurance Temple Biens, accidents et maladie, 390, rue Bay, Bureau 2300 aériennes, automobile, Toronto (Ontario) M5H 2Y2 chaudières et machines, crédit, John P. Phelan, Président et chef détournements, grêle, frais de la direction. juridiques, responsabilité et caution. See-Traders General Insurance Company.Compagnie d’Assurance Traders Générale Biens, accidents et maladie, 2206, av. Eglinton Est, Bureau 500 aériennes, automobile, Scarborough (Ontario) M1L 4S8 chaudières et machines, Mark Webb, Vice-président exécutif détournements, grêle, frais et chef des opérations. juridiques, responsabilité et caution. See-Trafalgar Insurance Company Compagnie d’Assurance Trafalgar Biens, accidents et maladie, of Canada. du Canada automobile, chaudières et 10, chemin York Mills, Bureau 700 machines et responsabilité. Toronto (Ontario) M2P 2G3 Robert E. Maynard, Président et chef de la direction. See-Transit Insurance Company.LaCompagnie d’Assurance Transit Biens, automobile et 5310, promenade Explorer, Bureau 201 responsabilité, limitée à Mississauga (Ontario) L4W 5H9 l’administration des polices William Star, Président. existantes. See-AIG Life Insurance Company of Canada. La Compagnie d’Assurance-Vie AIG Vie, accidents et maladie. du Canada 145, rue Wellington Ouest, 8e étage Toronto (Ontario) M5J 2T4 Ralph J. Gaudio, Président et chef de la direction. Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 13

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement See-CIBC Life Insurance Company Limited. Compagnie d’assurance-vie CIBC Limitée Vie, accidents et maladie. 3, promenade Robert Speck Bureau 500, C.P. 7065 Mississauga (Ontario) L5A 4K7 Gabor Kalmar, Président et chef des opérations. See-CNA Life Insurance Company of Compagnie d’Assurance-Vie CNA Vie, accidents et maladie et perte Canada. du Canada d’emploi. 40, rue Weber Est, 7e étage Kitchener (Ontario) N2H 6R3 Robert D. Scott, Président et chef de la direction. See-Blue Cross Life Insurance Company Compagnie d’Assurance-Vie Croix Bleue Vie, accidents et maladie. of Canada. du Canada C.P. 220, 644, rue Main Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8L3 Pierre-Yves Julien, Président et chef de la direction. See-CUMIS Life Insurance Company.LaCompagnie d’Assurance-Vie CUMIS Vie, accidents et maladie dans la C.P. 5065, 151, rue North Service mesure où son acte de Burlington (Ontario) L7R 4C2 constitution en corporation T. Michael Porter, Président et chef l’autorise. de la direction. See-Federated Life Insurance Company La Compagnie d’Assurance-Vie Federated Vie, accidents et maladie. of Canada. du Canada 717, av. Portage, C.P. 5800 Winnipeg (Manitoba) R3C 3C9 John M. Paisley, Président. See-Household Life Insurance Company.Compagnie d’Assurance-Vie Household Vie, accidents et maladie, à la Place Marois, condition que lorsque la société 3268, boul. Saint-Martin Ouest utilise un nom français dans Laval (Québec) H7T 1A1 l’exercice de ses activitiés au Jennifer Vinet, Agent principal. Canada, ce nom soit «Compagnie d’Assurance-Vie Household ». See-J.C. Penney Life Insurance Company.Compagnie d’assurance-vie J.C. Penney Vie, accidents et maladie. 80, Tiverton Court, Bureau 500 Markham (Ontario) L3R 0G4 Isaac Sananes, Agent principal. See-John Alden Life Insurance Company.LaCompagnie D’Assurance-Vie John Alden Vie, accidents et maladie, à la 1145, chemin Nicholson, Unité 2 condition que, si la Compagnie Newmarket (Ontario) L3Y 7V1 utilise un nom français dans ses Colleen Sexsmith, Agent principal. affaires au Canada, ce nom serait «LaCompagnie D’Assurance-Vie John Alden ». Les affaires de la compagnie sont limitées à l’écoulement des polices émises avant le 1er avril 1991. See-Liberty Life Assurance Company La Compagnie d’Assurance-Vie Liberté Vie, accidents et maladie. of Boston. de Boston BCE Place, Bay Wellington Tower 181, rue Bay, Bureau 3320 Toronto (Ontario) M5J 2T3 Gery Barry,Agent principal. See-The Manufacturers Life Insurance La Compagnie d’Assurance-Vie Vie, accidents et maladie. Company. Manufacturers 200, rue Bloor Est Toronto (Ontario) M4W 1E5 Dominic D’Alessandro, Président et chef de la direction. See-MIC Life Insurance Corporation. La Compagnie d’Assurance-Vie MIC Vie, accidents et maladie, limitée à C.P. 6000, 8500, rue Leslie, Bureau 400 la gestion des polices émises Thornhill (Ontario) L3T 4S5 avant le 1er janvier 1997 et sur la Charles W. Hastings, Agent principal. condition que lorsque la société étrangère utilise un nom français dans l’exercice de ses activités au Canada, ce nom soit « La Compagnie d’Assurance-Vie MIC ». 14 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement See-Minnesota Life Insurance Company Compagnie d’Assurance-vie Minnesota Vie, pourvu que, si la société a/s McLean & Kerr étrangère utilise une 130, rue Adelaide Ouest, Bureau 2800 dénomination sociale française Toronto (Ontario) M5H 3P5 dans le cadre de l’exercise de son Robin B. Cumine, C.R., Agent principal. activité au Canada, ce soit «Compagnie d’Assurance-vie Minnesota ». See-The North West Life Assurance La Compagnie d’Assurance-Vie North West Vie, accidents corporels et Company of Canada. du Canada maladie. 2165, Broadway Ouest, C.P. 5900 Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5H6 Douglas A. Carrothers, Vice-président, conseil général et secrétaire. See-Penncorp Life Insurance Company.LaCompagnie D’Assurance Vie Penncorp Vie, accidents et maladie. 90, rue Dundas Ouest, Bureau 400 Mississauga (Ontario) L5B 2T5 J. Paul Edmondson, Président et chef de la direction. See-Canadian Premier Life Insurance Compagnie d’assurance-vie Première Vie, accidents et maladie. Company. du Canada. 80, Tiverton Court, Bureau 500 Markham (Ontario) L3R 0G4 Aaron Hill, Vice-président et chef de la direction. See-Primerica Life Insurance Company La Compagnie d’Assurance-Vie Primerica Vie, accidents et maladie. of Canada. du Canada 2000, chemin Argentia, Plaza V, Bureau 300 Mississauga (Ontario) L5N 2R7 Glenn J. Williams, Vice-président exécutif et chef de la direction. See-Principal Life Insurance Company.Compagnie d’assurance-vie Principal Vie, accidents et maladie, pourvu 68, rue Scollard, 2e étage que, si la société étrangère utilise Toronto (Ontario) M5R 1G2 une dénomination social John Milnes, Agent principal. française dans le cadre de l’exercise de son activité au Canada, ce soit « Compagnie d’assurance-vie Principal ». See-RBC Life Insurance Company.Compagnie d’assurance vie RBC Vie, accidents et maladie. 55, promenade City Centre, Bureau 1100 Mississauga (Ontario) L5B 1M3 W. Grant Hardy, Président et chef de la direction. See-ReliaStar Life Insurance Company.Compagnie D’Assurance-Vie ReliaStar Vie, accidents et maladie, limitée 3650, av. Victoria Park, Bureau 201 aux affaires de réassurance, la North York (Ontario) M2H 3P7 société étrangère peut également V. Lorraine Williams, Agent principal. souscrire des polices d’assurance sur la vie de résidents du Canada assurés en vertu de polices collectives émises aux États-Unis, et à la condition que si la société étrangère utilise un nom français, ce nom serait «Compagnie D’Assurance-Vie ReliaStar ». See-Seaboard Life Insurance Company.Compagnie d’Assurance-vie Seaboard Vie, accidents et maladie, limitée à 2165, Broadway Ouest, C.P. 5900 la gestion des polices émises Vancouver avant le 31 mai 1999. (Colombie-Britannique) V6B 5H6 Robert T. Smith, Président et chef de la direction. See-Transamerica Life Insurance Company Compagnie d’Assurance-Vie Transamerica Vie, accidents et maladie. of Canada. du Canada 300, place Consilium Scarborough (Ontario) M1H 3G2 GeorgeA.Foegele, Président et chef de la direction. Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 15

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement See-Commercial Union Life Assurance La Compagnie d’Assurance-Vie Union Vie, accidents et maladie. Company of Canada. Commerciale du Canada 300, place Consilium C.P. 370, Succursale A Scarborough (Ontario) M1K 5C3 Frank J. Crowley, Président et chef des opérations. See-Union Fidelity Life Insurance Company.Compagnie d’Assurance-Vie Union Fidelity Vie, accidents et maladie,limitée à 200, rue Wellington Ouest la gestion des polices émises C.P. 166, Bureau 400 avant le 1er janvier 1999. Toronto (Ontario) M5V 3C7 Alan K. Ryder, Agent principal. See-The Wawanesa Life Insurance La Compagnie d’Assurance-vie Wawanesa Vie, accidents et maladie. Company. 191, Broadway Winnipeg (Manitoba) R3C 3P1 G. J. Hanson, Président et chef de la direction. See-Voyageur Insurance Company.Compagnie d’Assurance Voyageur Biens, accidents et maladie. 44, promenade centre Peel, Bureau 300 Brampton (Ontario) L6T 4M8 Walter Schutte, Président et chef de la direction. See-Wellington Insurance Company.Compagnie d’Assurance Wellington Biens, accidents et maladie, One Concord Gate aériennes, automobile, Don Mills (Ontario) M3C 3N6 chaudières et machines, Yves Brouillette, Président et chef détournements, grêle, perte de la direction. d’emploi, responsabilité et caution. See-Zenith Insurance Company.Compagnie d’assurance Zenith Biens, automobile et a/s Lombard Canada Ltd. responsabilité. 105, rue Adelaide Ouest Toronto (Ontario) M5H 1P9 Byron G. Messier, Président et chef de la direction. See-Lombard General Insurance Company Compagnie canadienne d’assurances Biens, aériennes, automobile, of Canada. générales Lombard chaudières et machines, crédit, 105, rue Adelaide Ouest détournements, grêle, Toronto (Ontario) M5H 1P9 responsabilité et caution. Byron G. Messier, Chef de la direction. See-Alta Surety Company.LaCompagnie de Cautionnement Alta Détournements et caution, limitée 800, boul. René-Lévesque Ouest à l’administration des polices Bureau 2795 existantes. Montréal (Québec) H3B 1X9 Aram Semerjian, Président. See-Northern Indemnity,Inc. LaCompagnie d’Indemnité du Nord, Inc. Biens, responsabilité, 2, rue Bloor ouest, Bureau 1500 détournements et caution. Toronto (Ontario) M4W 3E2 Robert Lamendola, Président. See-The Boiler Inspection and Insurance La Compagnie d’Inspection et d’Assurance Biens, chaudières et machines et Company of Canada. Chaudières et Machinerie responsabilité. 18, rue King Est Toronto (Ontario) M5C 1C4 Hans A. Schols, Président et directeur général. See-Maryland Casualty Company.Compagnie Maryland Casualty Biens, abus de confiance, accidents a/s Lavery, DeBilly, Avocats et maladie, accidents d’aviation, 1, , 40e étage automobile, caution, chaudières Montréal (Québec) H3B 4M4 et machines et responsabilité, à Pierre Caron, Agent principal. la condition que, si la Compagnie utilise un nom français dans ses affaires au Canada, ce nom serait «Compagnie Maryland Casualty », limitée à l’administration des polices existantes. 16 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement See-Commercial Travelers Mutual Compagnie Mutuelle D’Assurances Accidents et maladie, à condition Insurance Company. Commercial Travelers que les mots « constituée en (Incorporée sous les lois de l’état vertu des lois de l’État de New de New York, É.-U.A.) York, É.-U. d’Amérique » soient 8, place Ranchwood placés bien en évidence par Brampton (Ontario) L6R 1W5 rapport au nom « Commercial William C. Jorgens, Agent principal. Travelers Mutual Insurance Company » partoutoùcenomse trouve dans les contrats, formules de proposition, annonces et autres documents publiés par la Compagnie, et à la condition que, si la Compagnie utilise un nom français dans ses affaires au Canada, ce nom serait «Compagnie Mutuelle D’Assurances Commercial Travelers ». Les affaires de la compagnie sont limitées à l’écoulement des polices émises avant le 1er avril 1991. See-Chancellor Reinsurance Company of La Compagnie de Réassurance Chancellor Biens, accidents et maladie, Canada. du Canada. accidents d’aviation, automobile, Bureau 2000, Oceanic Plaza chaudières et machines, crédit, 1066, rue West Hastings abus de confiance, grêle, frais Vancouver juridiques, responsabilité et (Colombie-Britannique) V6E 3X2 caution, limitée aux affaires de Robert Rusko, Agent réassurance. Depuis le 5 juillet KPMG Comptables Agréés 1995, La Compagnie de Mandataire du surintendant des Réassurance Chancellor du institutions financières, liquidateur Canada fait l’objet d’une provisoire. procédure volontaire de liquidation et de dissolution sous la supervision des tribunaux, en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances. La firme KPMG Comptables Agréés a été nommée liquidateur de la société en vertu d’une ordonnance du tribunal. See-Suecia Reinsurance Company Compagnie de réassurance Suecia Biens, accidents et maladie, 18, rue King Est, Bureau 1402 aériennes, automobile, Toronto (Ontario) M5C 1C4 chaudières et machines, J. Leo Daly, Président. détournements, grêle, responsabilité et caution, limitée aux affaires de réassurance, et à l’écoulement des polices existantes. See-The Toa Reinsurance Company of La Compagnie de réassurance Toa Biens, accidents et maladie, America. d’Amérique. automobile, chaudières et Une rue Queen Est, Bureau 2606 machines, crédit, détournements, Toronto (Ontario) M5C 2W5 grêle, responsabilité et caution, David E. Wilmot, Agent principal limitée aux affaires de réassurance et pourvu que, si la société utilise une dénomination sociale française dans le cadre de l’exercise de son activité au Canada, ce soit « La Compagnie de réassurance Toa d’Amérique ». See-Swiss Reinsurance Company Canada. Compagnie Suisse de Réassurance Canada Biens, accidents et maladie, 150, rue King Ouest aériennes, automobile, C.P. 50, Bureau 2200 chaudières et machines, crédit, Toronto (Ontario) M5H 1J9 détournements, grêle, frais Patrick Mailoux, Président and chef juridiques, responsabilité, de la direction. hypothèque et caution, limitée aux affaires de réassurance. See-Western Surety Company.LaCompagnie de Sûreté de l’Ouest Détournements et caution. C.P. 527, 1874, rue Scarth, 20e étage Regina (Saskatchewan) S4P 2G8 L. C. Ell, Président. Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 17

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement See-Virginia Surety Company,Inc. Compagnie de sûreté Virginia Inc. Biens, automobile, chaudières et 7300, av. Warden, Bureau 300 machines et responsabilité, à la Markham (Ontario) L3R 0X3 condition que lorsque la société Dan C. Evans, Agent principal. utilise un nom français dans l’exercice de ses activités au Canada, ce nom soit «Compagnie de sûreté Virginia Inc. ». CompCorp Life Insurance Company Life, Accident and sickness, to the Voir-Société d’assurance vie SIAP 1 Queen Street East, Suite 1700 extent authorized by its Toronto, Ontario M5C 2X9 incorporating instrument. Gordon M. Dunning, President and Chief Executive Officer. Concordia Life Insurance Company Life, Accident and sickness. Concordia compagnie d’assurance-vie Vie, accidents et maladie. 2 St. Clair Ave. East, 6th Floor 2, av. St. Clair Est, 6e étage Toronto, Ontario M4T 2V6 Toronto (Ontario) M4T 2V6 Christopher H. McElvaine, President and Christopher H. McElvaine, Président et Chief Executive Officer. chef de la direction. Confederation Life Insurance Company Life, Personal accident and La Confédération, Compagnie Vie, accidents corporels et 800 Bay Street, 8th Floor Sickness. d’Assurance-Vie maladie. Toronto, Ontario M5S 3A9 On August 11, 1994 the 800, rue Bay,8e étage Le 11 août 1994, le surintendant Robert O. Sanderson, President, Superintendent of Financial Toronto (Ontario) M5S 3A9 des institutions financières a pris KPMG Inc. Institutions took control of Robert O. Sanderson, le contrôle de La Confédération, Agent for the Superintendent of Confederation Life Insurance Président KPMG Inc. Compagnie d’Assurance-Vie et Financial Institutions, Provisional Company and the court granted a Mandataire du surintendant des la cour accordait une ordonnance Liquidator. winding-up order appointing the institutions financières, liquidateur de liquidation nommant le Superintendent as provisional provisoire. surintendant au titre de liquidator of the company.The liquidateur provisoire de la court subsequently appointed société. La cour a par la suite KPMG Inc. as permanent désigné la firme KPMG Inc. à liquidator. The winding up of the titre de liquidateur permanent. company’s business and affairs La liquidation des opérations et continues. des affaires de la société se poursuivent. Connecticut General Life Insurance Life, Personal accident and Connecticut General Life Insurance Vie, accidents corporels et Company Sickness. Company maladie. 55 Town Centre Court 55, cour Town Centre P.O. Box 14, Suite 606 Bureau 606, C.P. 14 Scarborough, Ontario M1P 4X4 Scarborough (Ontario) M1P 4X4 M. E. Hassan, Chief Agent. M. E. Hassan, Agent principal. Constitution Insurance Company of Canada Property, Accident and sickness, Constitution du Canada, Compagnie Biens, accidents et maladie, 500 University Ave., 4th Floor Automobile, Fidelity,Legal d’Assurance automobile, détournements, frais Toronto, Ontario M5G 1V9 expense, Liability and Surety, 500, av. University,4e étage juridiques, responsabilité et Frank DiTomasso, President. limited to the servicing of Toronto (Ontario) M5G 1V9 caution, limitée à l’écoulement existingpolicies. Frank DiTomasso, Président. des polices existantes. Continental Assurance Company Life, Accident and sickness, Continental Assurance Company Vie, accidents et maladie, limitée à 40 Weber Street East, 7th Floor limited to the servicing of 40, rue Weber Est, 7e étage la gestion des polices émises Kitchener, Ontario N2H 6R3 policies issued prior to Kitchener (Ontario) N2H 6R3 avant le 1er janvier 1999. Robert D. Scott, Chief Agent. January 1, 1999. Robert D. Scott, Agent principal. Continental Casualty Company Property, Accident and sickness, Continental Casualty Company Biens, accidents et maladie, 105 Adelaide Street West Aircraft, Automobile, Boiler and 105, rue Adelaide Ouest aériennes, automobile, Toronto, Ontario M5H 1P9 machinery, Credit, Fidelity,Hail, Toronto (Ontario) M5H 1P9 chaudières et machines, crédit, Charles R. Lawrence, Chief Agent. Liability and Surety. Charles R. Lawrence, Agent principal. détournements, grêle, responsabilité et caution. The Continental Insurance Company Property, Aircraft, Automobile, The Continental Insurance Company Biens, accidents d’aviation, 105 Adelaide Street West Boiler and machinery, Credit, 105, rue Adelaide Ouest automobile, chaudières et Toronto, Ontario M5H 1P9 Fidelity, Hail, Liability and Toronto (Ontario) M5H 1P9 machines, crédit, abus de Charles R. Lawrence, Chief Agent. Surety. Charles R. Lawrence, Agent principal. confiance, responsabilité et caution. Co-operators General Insurance Company Property, Accident and sickness, Voir-La Compagnie d’Assurance Générale Priory Square, Guelph, Ontario N1H 6P8 Aircraft, Automobile, Boiler and Co-operators Terry Squire, President and machinery, Credit, Legal Chief Executive Officer. expense, Fidelity, Hail, Liability and Surety. Co-operators Life Insurance Company Life, Accident and sickness. Co-operators, Compagnie d’Assurance-Vie Vie, accidents et maladie. Priory Square, Guelph, Ontario N1H 6P8 Priory Square, Guelph (Ontario) N1H 6P8 Terry Squire, President and Chief Terry Squire, Président et chef Executive Officer. de la direction. 18 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement Coseco Insurance Company Property, Accident and sickness, Voir-Compagnie d’Assurance Coseco Priory Square Guelph, Ontario N1H 6P8 Automobile and Liability. Terry Squire, President and Chief Executive Officer. See-Canada Life Financial Corporation Corporation Financière Canada-Vie Vie 330, av. University Toronto (Ontario) M5G 1R8 David Nield, Président et chef de la direction. Crown Life Insurance Company Life, Accident and sickness. Crown, compagnie d’assurance-vie Vie, accidents et maladie. 1874 Scarth Street, Suite 1900 1874, rue Scarth, Bureau 1900 Regina, Saskatchewan S4P 4B3 Regina (Saskatchewan) S4P 4B3 Brian A. Johnson, President and Brian A. Johnson, Président et chef Chief Executive Officer. de la direction. CT Direct Insurance Inc. Property, Accident and sickness, CT assurance directe inc. Biens, accidents et maladie, 2161 Yonge Street, 4th Floor Aircraft, Automobile, Boiler and 2161, rue Yonge, 4e étage aériennes, automobile, Toronto, Ontario M4S 3A6 machinery, Fidelity, Liability and Toronto (Ontario) M4S 3A6 chaudières et machines, Alain Thibault, Chief Operating Officer. Surety. Alain Thibault, Chef de l’exploitation. détournements, responsabilité et caution. CUMIS General Insurance Company Property, Accident and sickness, Voir-La Compagnie d’Assurance Général P.O. Box 5065 Automobile, Boiler and CUMIS Burlington, Ontario L7R 4C2 machinery, Fidelity, Liability and T. Michael Porter, President and Surety. Chief Executive Officer. CUMIS Life Insurance Company Life, Accident and sickness to the Voir-La Compagnie d’Assurance-Vie P.O. Box 5065, 151 North Service Road extent authorized by its CUMIS Burlington, Ontario L7R 4C2 instrument of incorporation. T. Michael Porter, President and Chief Executive Officer. CUNA Mutual Insurance Society Life, Accident and sickness, Voir-La Société d’Assurance CUNA P.O. Box 5065, 151 North Service Road limited to the writing of Mutuelle Burlington, Ontario L7R 4C2 insurance on the members of T. Michael Porter, Chief Agent. credit unions, and the Company may use in the transaction of its business in Canada its name in English “CUNA Mutual Insurance Society” or its name in French “La Société d’Assurance CUNA Mutuelle”, or both of such names. The Dominion Life Assurance Company Life insurance, limited to the La Dominion, Compagnie d’Assurance Vie, sous réserve de la restriction 200 Bloor St. East, North Tower 10 servicing of policies issued prior sur la Vie que les affaires de la compagnie Toronto, Ontario M4W 1E5 to January 1, 1986. 200, rue Bloor Est, North Tower 10 soient limitées à l’écoulement Ian Beverly, Provisional Liquidator. Toronto (Ontario) M4W 1E5 des polices émises avant le Ian Beverly,Liquidateur 1er janvier 1986. provisoire. The Dominion of Canada General Property, Aircraft, Automobile, Voir-Compagnie d’assurance générale Insurance Company Boiler and machinery, Fidelity, Dominion du Canada 165 University Ave. Hail, Liability and Surety. Toronto, Ontario M5H 3B9 George L. Cooke, President and Chief Executive Officer. Eagle Star Insurance Company Limited Property, Accident and sickness, Eagle Star Insurance Company Limited Biens, accidents et maladie, c/o Focus Group Inc. Aircraft, Automobile, Boiler and a/s Focus Group Inc. accidents d’aviation, automobile, 36 King Street East, Suite 500 machinery, Fidelity, Liability and 36, rue King Est, Bureau 500 chaudières et machines, abus de Toronto, Ontario M5C 1E5 Surety. Toronto (Ontario) M5C 1E5 confiance, responsabilité et P. H. Cook, Chief Agent. P. H. Cook, Agent principal. caution. Ecclesiastical Insurance Office Public Property, Automobile, Boiler and Voir-Société des Assurances Écclésiastiques Limited Company Machinery, Fidelity and Liability Box 2401, Suite 502, 2300 YongeSt. on the condition that if in the Toronto, Ontario M4P 1E4 transaction of its business in Stephen Malcolm Oxley, Chief Agent. Canada the Company uses a French name, that name shall be “Société des Assurances Écclésiastiques”. Echelon General Insurance Company Property, Automobile and Échelon, Compagnie D’Assurances Générale Biens, automobile et Priory Square Liability. Priory Square responsabilité. Guelph, Ontario N1H 6P8 Guelph (Ontario) N1H 6P8 Terry Squire, President and Chief Terry Squire, Président et chef Executive Officer. de la direction. Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 19

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement Economical Mutual Insurance Company Property, Accident and sickness, Economical, Compagnie Mutuelle Biens, accidents et maladie, P.O. Box 2000 Automobile, Boiler and d’Assurance automobile, chaudières et 111 Westmount Road South machinery, Fidelity, Liability and C.P. 2000 machines, détournements, Waterloo, Ontario N2J 4S4 Surety. 111, chemin Westmount Sud responsabilité et caution. Noel G. Walpole, President and Chief Waterloo (Ontario) N2J 4S4 Executive Officer. Noel G. Walpole, Président et chef de la direction. Elite Insurance Company Property, Accident and sickness, Voir-La Compagnie d’Assurances Elite 649 North Service Road West Aircraft, Automobile, Boiler and Burlington, Ontario L7R 4L5 machinery, Fidelity, Liability and Mark Webb, Executive Vice President and Surety. Chief Operating Officer. The Empire Life Insurance Company Life, Accident and sickness. L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie Vie, accidents et maladie. 259 King Street East 259, rue King Est Kingston, Ontario K7L 3A8 Kingston (Ontario) K7L 3A8 Christopher H. McElvaine, President and Christopher H. McElvaine, Président et Chief Executive Officer. chef de la direction. Employers Insurance of Wausau Property, Accident and sickness, Voir-Société d’assurance mutuelle des a Mutual Company Aircraft, Automobile, Boiler and employeurs de Wausau c/o D. M. Williams & Associates Ltd. machinery, Fidelity, Liability and 3650 Victoria Park Ave., Suite 201 Surety on the condition that if in North York, Ontario M2H 3P7 the transaction of its business in V. Lorraine Williams, Chief Agent. Canada the Company uses a French name, that name shall be “Société d’assurance mutuelle des employeurs de Wausau”. Employers Reassurance Corporation Life, Accident and sickness, Employers Reassurance Corporation Vie, accidents et maladie, limitée 200 Wellington Street West, Suite 400 limited to the business of 200, rue Wellington Ouest aux affaires de réassurance. P.O. Box 166 reinsurance. Bureau 400, C.P. 166 Toronto, Ontario M5V 3C7 Toronto (Ontario) M5V 3C7 Alan Ryder, Chief Agent. Alan Ryder, Agent principal. Employers Reinsurance Corporation Property, Accident and sickness, Employers Reinsurance Corporation Biens, abus de confiance, accidents 200 Wellington Street West, Suite 1400 Aircraft, Automobile, Boiler and 200, rue Wellington Ouest d’aviation, accidents et maladie, P.O. Box 166 machinery, Credit, Fidelity, Bureau 1400, C.P. 311 automobile, caution, chaudières Toronto, Ontario M5V 3C7 Liability and Surety. Toronto (Ontario) M5V 3C7 et machines, crédit et Peter Borst, Chief Agent. Peter Borst, Agent principal. responsabilité. The Equitable General Insurance Company Property, Automobile, Boiler and L’Équitable, Compagnie d’Assurances Biens, automobile, chaudières et 2475 Laurier Blvd., P.O. Box 4700 machinery, Fidelity, Liability and Générales machines, abus de confiance, Sillery, Quebec G1V 4E4 Surety, limited to the servicing of 2475, boul. Laurier, C.P. 4700 responsabilité et caution, limitée John Arbour, President and Chief existingpolicies. Sillery (Québec) G1V 4E4 à l’écoulement des polices Executive Officer. John Arbour, Président et chef existantes. de la direction. The Equitable Life Assurance Society of Life, Personal accident and The Equitable Life Assurance Society of Vie, accidents corporels et the United States Sickness. the United States maladie. 55 Town Centre Court 55, cour Town Centre P.O. Box 14, Suite 606 C.P. 14, Bureau 606 Scarborough, Ontario M1P 4X4 Scarborough (Ontario) M1P 4X4 M. E. Hassan, Chief Agent. M. E. Hassan, Agent principal. The Equitable Life Insurance Company Life, Personal accident and L’Équitable Compagnie d’Assurance-Vie Vie, accidents corporels et of Canada Sickness. du Canada maladie. 1 Westmount Rd. North 1, chemin Westmount Nord Waterloo, Ontario N2J 4C7 Waterloo (Ontario) N2J 4C7 Ron Beaubien, President and Ron Beaubien, Président et chef Chief Executive Officer. de la direction. ERC Frankona Rückversicherungs-Aktien- Life, Property, Accident and ERC Frankona Rückversicherungs-Aktien- Vie, biens, accidents et maladie, Gesellschaft sickness, Aircraft, Automobile, Gesellschaft aériennes, automobile, Life Branch Boiler and machinery, Credit, Vie chaudières et machines, crédit, 200 Wellington Street West Fidelity, Hail, Liability and 200, rue Wellington Ouest détournements, grêle, Suite 400, P.O. Box 166 Surety, limited to the business of Bureau 400, C.P. 166 responsabilité et caution, limitée Toronto, Ontario M5V 3C7 reinsurance. Toronto (Ontario) M5V 3C7 aux affaires de réassurance. Alan K. Ryder, Chief Agent. Alan K. Ryder, Agent principal. Property and Casualty Branch Biens et risques divers 20 Richmond St. East, Suite 330 20, rue Richmond Est, Bureau 330 Toronto, Ontario M5C 2R9 Toronto (Ontario) M5C 2R9 Brian Frederick Maltman, Chief Agent. Brian Frederick Maltman, Agent principal. EULER American Credit Indemnity Credit. EULER American Credit Indemnity Crédit. Company Company 1155 René-Lévesque Blvd. West, 1155, boul. René-Lévesque Ouest Suite 1702, CIBC Tower Bureau 1702, Tour CIBC Montreal, Quebec H3B 3Z7 Montréal (Québec) H3B 3Z7 Robert Labelle, Chief Agent. Robert Labelle, Agent principal. 20 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement Everest Insurance Company of Canada Property, Automobile, Aircraft, Voir-La Compagnie d’Assurance Everest du 130 King Street West Boiler and machinery, Credit, Canada The Exchange Tower, Suite 2520 Fidelity, Hail, Liability and Toronto, Ontario M5X 1E3 Surety. William G. Jonas, President and Chief Executive Officer. Everest Reinsurance Company Property, Accident and sickness, Everest Reinsurance Company Biens, accidents et maladie, 130 King Street West Aircraft, Automobile, Boiler and 130, rue King Ouest aériennes, automobile, The Exchange Tower, Suite 2520 machinery, Credit, Fidelity,Hail, The Exchange Tower, Bureau 2520 chaudières et machines, crédit, Toronto, Ontario M5X 1E3 Liability and Surety, limited to Toronto (Ontario) M5X 1E3 détournements, grêle, William G. Jonas, Chief Agent. the business of reinsurance. William G. Jonas, Agent principal. responsabilité et caution, limitée aux affaires de réassurance. Factory Mutual Insurance Company Property, Boiler and machinery, Factory Mutual Insurance Company Biens, chaudières et machines, 165 Commerce Valley Drive West, Fidelity, Liability and Surety. 165, promenade Commerce Valley Ouest, détournements, responsabilité et Suite 500 Bureau 500 caution. Thornhill, Ontario L3T 7V8 Thornhill (Ontario) L3T 7V8 Perry Brazeau, Chief Agent. Perry Brazeau, Agent principal. Federal Insurance Company Property, Accident and sickness, Voir-Compagnie d’assurances Fédérale One Financial Place Automobile, Boiler and 1 Adelaide Street East machinery, Fidelity, Liability and Toronto, Ontario M5C 2V9 Surety, on the condition that if in Janice M. Tomlinson, Chief Agent. the transaction of its business in Canada the company uses a French name, that name shall be “Compagnie d’assurances Fédérale”. Federated Insurance Company of Canada Property, Automobile, Boiler and La Federated, Compagnie d’Assurance Biens, automobile, chaudières et P.O. Box 5800, 717 Portage Ave. machinery, Fidelity, Liability and du Canada machines, abus de confiance, Winnipeg, Manitoba R3C 3C9 Surety. C.P. 5800, 717, av. Portage responsabilité et caution. John M. Paisley, President. Winnipeg (Manitoba) R3C 3C9 John M. Paisley, Président. Federated Life Insurance Company Life, Accident and sickness. Voir-La Compagnie d’Assurance-Vie of Canada Federated du Canada 717 Portage Avenue, P.O. Box 5800 Winnipeg, Manitoba R3C 3C9 John M. Paisley, President. Federation Insurance Company of Canada Property, Automobile, Boiler and La Fédération Compagnie d’Assurances Biens, automobile, chaudières et 1000 de la Gauchetière Street West machinery,Legal expense, du Canada machines, frais juridiques, Suite 500 Fidelity, Hail, Liability and 1000, rue de la Gauchetière Ouest détournements, grêle, Montréal, Quebec H3B 4W5 Surety. Bureau 500 responsabilité et caution. W. J. Green, President. Montréal (Québec) H3B 4W5 W. J. Green, Président. Financial Life Assurance Company Life, Accident and sickness. Financial du Canada, Compagnie Vie, accidents et maladie. of Canada d’Assurance-Vie 10 Four Seasons Place, 10th Floor 10 Four Seasons Place, 10e étage P.O. Box 335 C.P. 335 Etobicoke, Ontario M9C 4V3 Etobicoke (Ontario) M9C 4V3 Hugh D. Haney, President. Hugh D. Haney, Président. See-Sun Life Financial Services of Financière Sun Life du Canada inc. Vie. Canada Inc. 150, rue King Ouest Toronto (Ontario) M5H 1J9 Donald A. Stewart, Président du conseil et chef de la direction First Allmerica Financial Life Insurance Life, Accident and sickness, First Allmerica Financial Life Insurance Vie, accidents et maladie, sous Company limited to the servicing of Company réserve de la restriction que les 40 King St. West policies issued prior to 40, rue King Ouest affaires de la compagnie soient Scotia Plaza, Suite 2100 June 1, 1992. Scotia Plaza, Bureau 2100 limitées à l’écoulement des Toronto, Ontario M5H 3C2 Toronto (Ontario) M5H 3C2 polices émises avant le J. Brian Reeve, Chief Agent. J. Brian Reeve, Agent principal. 1er juin 1992. First American Title Insurance Company Title. First American Title Insurance Company Titres. 1290 Central Parkway West, Suite 801 1290, promenade Central Ouest Mississauga, Ontario L5C 4R3 Bureau 801 Tom Grifferty, Chief Agent. Mississauga (Ontario) L5C 4R3 Tom Grifferty,Agent principal. First National Insurance Company Property, Automobile, Fidelity, First National Insurance Company Biens, automobile, abus de of America Liability and Surety, limited to of America confiance, responsabilité et c/o Fasken, Campbell, Godfrey the servicing of existingpolicies. a/s Fasken, Campbell, Godfrey caution, limitée à P.O. Box 20, Toronto-Dominion Centre C.P. 20, Toronto-Dominion Bank Tower l’administration des polices Toronto-Dominion Bank Tower Toronto-Dominion Centre existantes. Toronto, Ontario M5K 1N6 Toronto (Ontario) M5K 1N6 Robert M. Sutherland, Chief Agent. Robert M. Sutherland, Agent principal. Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 21

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement First North American Insurance Company Accident and sickness, Property Voir-La Nord-américaine, première 5650 YongeSt. limited to job loss insurance, compagnie d’assurance North York, Ontario M2M 4G4 baggage insurance, merchandise Dominic D’Alessandro, President and repair and replacement Chief Executive Officer. insurance, and credit card insurance arising from mass marketing initiatives, and Automobile limited to indemnification of credit card holders insured under a group policy in respect of collision damage waivers. Folksamerica Reinsurance Company Property, Automobile, Fidelity, Folksamerica Reinsurance Company Biens, automobile, détournements, 80 Bloor Street West, Suite 1202 Hail, Liability and Surety, 80, rue Bloor Ouest, Bureau 1202 responsabilité, grêle et caution, Toronto, Ontario M5S 2V1 limited to the business of Toronto (Ontario) M5S 2V1 limitée aux affaires de James M. Willis, Chief Agent. reinsurance. James M. Willis, Agent principal. réassurance. Ford Life Insurance Company Life, Accident and sickness, Ford Life Insurance Company Vie, accidents et maladie, limitées 1145 Nicholson Road, Unit 2 limited to the servicing of 1145, chemin Nicholson, Unité 2 àlagestion des polices émises Newmarket, Ontario L3Y 7V1 policies issued prior to Newmarket (Ontario) L3Y 7V1 avant le 1er juillet 1992. Colleen Sexsmith, Chief Agent. July 1, 1992. Colleen Sexsmith, Agent principal. Foresters Indemnity Company Property, Accident and sickness Voir-Indemnité Compagnie des Forestiers 789 Don Mills Road and Liability, limited to the Don Mills, Ontario M3C 1T9 servicing of existingpolicies. G. Peter Oakes, Group Vice-President Finance & Administration. Forethought Life Insurance Company Life. Forethought Life Insurance Company Vie. 3380 South Service Road 3380, chemin South Service Burlington, Ontario L7N 3J5 Burlington (Ontario) L7N 3J5 L. Paul Renaud, Chief Agent. L. Paul Renaud, Agent principal. GAN VIE Compagnie Française Life. GAN VIE Compagnie Française Vie. d’Assurances sur la Vie d’Assurances sur la Vie 425, Maisonneuve Blvd. West, Suite 1200 425, boul. de Maisonneuve Ouest Montréal, Quebec H3A 3G5 Bureau 1200 Eric L. Clark, Chief Agent. Montréal (Québec) H3A 3G5 Eric L. Clark, Agent principal. See-The Guarantee Company of La Garantie, Compagnie d’Assurance Biens, accidents et maladie, North America de l’Amérique du Nord automobile, chaudières et , Bureau 1560 machines, abus de confiance, Montréal (Québec) H3B 2R4 frais juridiques, responsabilité et Jules R. Quenneville, Président et chef caution. de la direction. GE Capital Casualty Company, Canada Property, Boiler and machinery Voir-Compagnie d’assurance GE Capital 2023-7495 132 Street limited to the Province of Casualty, Canada Surrey, British Columbia V3W 1J8 Alberta and Vehicle Warranty Danielle Bolduc, President and insurance as defined by the Chief Financial Officer. Classes of Insurance Regulations of the Province of Alberta, and Surety. GE Capital Mortgage Insurance Company Mortgage. Voir-Compagnie d’assurance d’hypothèques (Canada) GE Capital (Canada) 2300 Meadowvale Blvd. Mississauga, Ontario L5N 5P9 Peter Vukanovich, President, Chief Executive Officer, and Chief Financial Officer GE Reinsurance Corporation Property, Accident and sickness, GE Reinsurance Corporation Biens, accidents et maladie, 3650 Victoria Park Ave., Suite 201 Aircraft, Automobile, Boiler and 3650, av. Victoria Park, Bureau 201 accidents d’aviation, automobile, North York, Ontario M2H 3P7 machinery, Fidelity,Hail, North York (Ontario) M2H 3P7 chaudières et machines, abus de V. Lorraine Williams, Chief Agent. Liability and Surety, limited to V. Lorraine Williams, Agent principal. confiance, grêle, responsabilité et the business of reinsurance. caution, limitée aux affaires de réassurances. General & Cologne Life Re of America Life, Accident and sickness, General & Cologne Life Re of America Vie, accidents et maladie, limitée 1 First Canadian Place limited to the business of 1 First Canadian Place aux affaires de réassurance. Suite 5705, P.O. Box 471 reinsurance. Bureau 5705, C.P. 471 Toronto, Ontario M5X 1E4 Toronto (Ontario) M5X 1E4 Gerald A. Wolfe, Chief Agent Gerald A. Wolfe, Agent principal. General American Life Insurance Company Life, Personal accident and General American Life Insurance Company Vie, accidents corporels et 1501 McGill College Avenue Sickness. 1501, av. McGill College maladie. Suite 2220 Bureau 2220 Montréal, Quebec H3A 3M8 Montréal (Québec) H3A 3M8 André St-Amour, Chief Agent. André St-Amour, Agent principal. 22 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement General Insurance Company of America Property, Automobile, Fidelity, General Insurance Company of America Biens, automobile, abus de c/o Fasken, Campbell, Godfrey Liability and Surety, limited to a/s Fasken, Campbell, Godfrey confiance, responsabilité et P.O. Box 20 the servicing of existingpolicies. C.P. 20, Toronto-Dominion Centre caution, limitée à Toronto-Dominion Bank Tower Toronto-Dominion Bank Tower l’administration des polices Toronto-Dominion Centre Toronto (Ontario) M5K 1N6 existantes. Toronto, Ontario M5K 1N6 Robert M. Sutherland, Agent principal. Robert M. Sutherland, Chief Agent. General Reinsurance Corporation Property, Accident and sickness, General Reinsurance Corporation Biens, abus de confiance, accidents 1 First Canadian Place Aircraft, Automobile, Boiler and 1 First Canadian Place et maladie, accidents d’aviation, Suite 5705, P.O. Box 471 machinery, Credit, Fidelity,Hail, Bureau 5705, C.P. 471 automobile, caution, chaudières Toronto, Ontario M5X 1E4 Liability and Surety. Toronto (Ontario) M5X 1E4 et machines, crédit, grêle et Gerald A. Wolfe, Chief Agent. Gerald A. Wolfe, Agent principal. responsabilité. Gold Circle Insurance Company Property, Accident and sickness, Voir-Cercle d’Or, Compagnie d’Assurance c/o The Great-West Life Automobile and Liability, Assurance Company limited to the servicing of 100 Osborne St. North existingpolicies. Winnipeg, Manitoba R3C 3A5 Sheila Wagar, Secretary. Gore Mutual Insurance Company Property, Accident and sickness, Gore Mutual Insurance Company Biens, accident et maladie, 252 Dundas St. Automobile, Boiler and 252, rue Dundas automobile, chaudières et Cambridge, Ontario N1R 5T3 machinery, Fidelity, Liability and Cambridge (Ontario) N1R 5T3 machines, détournements, Claude Smith, President and Chief Surety. Claude Smith, Président et chef responsabilité et caution. Operating Officer. des opérations. Grain Insurance and Guarantee Company Property, Automobile, Boiler and Voir-La Compagnie d’assurance et de 1240 One Lombard Place machinery, Fidelity, Liability and Garantie Grain Winnipeg, Manitoba R3B 0V9 Surety. Ralph N. Jackson, President. Granite Insurance Company Property, Accident and sickness, Granite Compagnie d’Assurances Biens, accidents et maladie, 2 Eva Road, Suite 200 Automobile, Fidelity, Liability 2, chemin Eva, Bureau 200 automobile, abus de confiance, Etobicoke, Ontario M9C 2A8 and Surety, limited to the Etobicoke (Ontario) M9C 2A8 responsabilité et caution, limitée Bruce K. Dwyer, President. servicing of existingpolicies. Bruce K. Dwyer, Président. à l’administration des polices existantes. Great American Insurance Company Property, Accident and sickness, Great American Insurance Company Biens, accidents et maladie, 40 King Street West Aircraft, Automobile, Boiler and 40, rue King Ouest accidents d’aviation, automobile, Scotia Plaza, Suite 2100 machinery, Fidelity,Hail, Scotia Plaza, Bureau 2100 chaudières et machines, abus de Toronto, Ontario M5H 3C2 Liability and Surety. Toronto (Ontario) M5H 3C2 confiance, grêle, responsabilité et J. Brian Reeve, Chief Agent. J. Brian Reeve, Agent principal. caution. The Great-West Life Assurance Company Life, Accident and sickness. La Great-West, compagnie d’assurance-vie Vie, accidents et maladie. 100 Osborne St. North 100, rue Osborne Nord P.O. Box 6000 C.P. 6000 Winnipeg, Manitoba R3C 3A5 Winnipeg (Manitoba) R3C 3A5 Ray McFeetors, President and Ray McFeetors, Président et chef Chief Executive Officer. de la direction. The Guarantee Company of North America Property, Accident and Sickness, Voir-La Garantie, Compagnie d’Assurance Place du Canada, Suite 1560 Automobile, Boiler and de l’Amérique du Nord Montréal, Quebec H3B 2R4 Machinery, Fidelity,Legal Jules R. Quenneville, President and expense, Liability and Surety. Chief Executive Officer. See-The Commerce Group Insurance Le Groupe Commerce Compagnie Biens, accidents et maladie, Company d’Assurances aériennes, automobile, 2450, rue Girouard Ouest, C.P. 1000 chaudières et machines, frais Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C4 juridiques, détournements, grêle, Claude Gravel, Président et chef responsabilité et caution. des opérations. The Halifax Insurance Company Property, Accident and sickness, Voir-La Compagnie d’Assurance Halifax 75 Eglinton Ave. East Aircraft, Automobile, Boiler and Toronto, Ontario M4P 3A4 machinery, Fidelity,Hail, Donald K. Lough, President. Liability and Surety. Hannover Ruckversicherungs- Property, Accident and sickness, Hannover Ruckversicherungs- Biens, accidents et maladie, Aktiengesellschaft Aircraft, Automobile, Boiler and Aktiengesellschaft accidents d’aviation, automobile, 3650 Victoria Park Ave., Suite 201 machinery, Fidelity,Hail, 3650, av. Victoria Park, Bureau 201 chaudières et machines, abus de North York, Ontario M2H 3P7 Liability and Surety, limited to North York (Ontario) M2H 3P7 confiance, grêle, responsabilité et V. Lorraine Williams, Chief Agent. the business of reinsurance. V. Lorraine Williams, Agent principal. caution, limitée aux affaires de réassurance. The Hanover Insurance Company Property, Automobile, Boiler and The Hanover Insurance Company Biens, chaudières et machines, c/o Focus Group,Inc. machinery, Fidelity, Liability and a/s Focus Group,Inc. automobile, abus de confiance, 36 King Street East, Suite 500 Surety, limited to the servicing of 36, rue King Est, Bureau 500 responsabilité et caution, limitée Toronto, Ontario M5C 1E5 existingpolicies. Toronto (Ontario) M5C 1E5 à l’administration des polices Philip H. Cook, Chief Agent. Philip H. Cook, Agent principal. existantes. Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 23

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement The Hartford Fire Insurance Company Property, Accident and sickness, The Hartford Fire Insurance Company Biens, accidents et maladie, 20 York Mills Rd. Aircraft, Automobile, Boiler and 20, chemin York Mills accidents d’aviation, automobile, Willowdale, Ontario M2P 2C2 machinery, Fidelity,Hail, Willowdale (Ontario) M2P 2C2 chaudières et machines, abus de Kenneth Yeaglin, Chief Agent. Liability and Surety. Kenneth Yeaglin, Agent principal. confiance, grêle, responsabilité et caution. Hartford Insurance Company of Canada Property, Accident and sickness, Voir-Compagnie d’Assurance Hartford 20 York Mills Rd. Aircraft, Automobile, Boiler and du Canada. Willowdale, Ontario M2P 2C2 machinery, Fidelity,Hail, Gary G. Davis, President and Chief Liability and Surety. Executive Officer. Hartford Life Insurance Company Life, Accident and sickness. Hartford Life Insurance Company Vie, accidents et maladie. 20 Queen Street West, Suite 1400 20, rue Queen Ouest, Bureau 1400 Toronto, Ontario M5H 2V3 Toronto (Ontario) M5H 2V3 Susan L. Naylor, Chief Agent. Susan L. Naylor, Agent principal. Helvetia Swiss Insurance Company, Limited Property, Automobile, Hail, Legal Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances Biens, automobile, grêle, frais 1000 de la Gauchetière Street West expense, Fidelity, Liability and 1000, rue de la Gauchetière Ouest juridiques, détournements, Suite 500 Surety. Bureau 500 responsabilité et caution. Montréal, Quebec H3B 4W5 Montréal (Québec) H3B 4W5 W. J. Green, Chief Agent. W. J. Green, Agent principal. Highlands Insurance Company Property, Aircraft, Automobile, Highlands Insurance Company Biens, accidents d’aviation, c/o Fasken, Campbell, Godfrey Fidelity, Hail, Liability and a/s Fasken, Campbell, Godfrey automobile, abus de confiance, Toronto-Dominion Centre Surety, limited to the servicing of Toronto-Dominion Centre, C.P. 20 grêle, responsabilité et caution, P.O. Box 20 existingpolicies. Toronto (Ontario) M5K 1C1 limitée à l’administration des Toronto, Ontario M5K 1C1 Robert W. McDowell, Agent principal. polices existantes. Robert W. McDowell, Chief Agent. The Home Insurance Company Property, Accident and sickness, The Home Insurance Company Biens, accidents et maladie, c/o Focus Group Inc. Aircraft, Automobile, Boiler and a/s Focus Group Inc. aériennes, automobile, caution, 36 King Street East, Suite 500 machinery, Fidelity, Liability and 36, rue King Est, Bureau 500 chaudières et machines, Toronto, Ontario M5C 1E5 Surety, limited to the servicing of Toronto (Ontario) M5C 1E5 détournements et responsabilité, Philip H. Cook, Chief Agent. existingpolicies. Philip H. Cook, Agent principal. limitée à l’écoulement des polices existantes. Household Life Insurance Company Life, Accident and sickness, on the Voir-Compagnie d’Assurance-Vie Place Marois condition that if, in the Household 3268 Saint-Martin Boulevard. West transaction of its business in Laval, Quebec H7T 1A1 Canada, the Company uses a Jennifer Vinet, Chief Agent. French form of name, that name shall be “Compagnie d’Assurance-Vie Household”. HSBC Canadian Direct Insurance Property, Accident and sickness, Voir-La Compagnie d’Assurances HSBC Incorporated Automobile and Liability. Canadienne Direct Incorporée. 610-6th Street, Suite 217 New Westminster British Columbia V3L 3C2 Guy Cloutier, President and Chief Executive Officer. ICAROM Public Limited Company Property, Aircraft, Automobile, ICAROM Public Limited Company Biens, accidents d’aviation, c/o Focus Group Inc. Fidelity, Liability and Surety, a/s Focus Group Inc. automobile, abus de confiance, 36 King Street East, Suite 500 limited to the servicing of 36, rue King Est, Bureau 500 responsabilité et caution, limitée Toronto, Ontario M5C 1E5 existingpolicies. Toronto (Ontario) M5C 1E5 à l’administration des polices Philip H. Cook, Chief Agent. Philip H. Cook, Agent principal. existantes. The Imperial Life Assurance Company Life, Accident and sickness. L’Impériale, compagnie d’assurance-vie Vie, accidents et maladie. of Canada 95, av. St. Clair Ouest 95 St. Clair Ave. West Toronto (Ontario) M4V 1N7 Toronto, Ontario M4V 1N7 Marcel Pépin, Président et chef Marcel Pépin, President and Chief de la direction. Executive Officer. See-Foresters Indemnity Company Indemnité Compagnie des Forestiers Biens, accidents et maladie et 789, chemin Don Mills responsabilité, limitée à Don Mills (Ontario) M3C 1T9 l’administration des polices G. Peter Oakes, Vice-président existantes. Groupe des Finances et Administration. ING Novex Insurance Company of Canada Property, Accident and sickness, ING Novex Compagnie d’assurance Biens, accidents et maladie, Suite 300, P.O. Box 130 Automobile, Boiler and du Canada automobile, chaudières et Markborough Place II machinery*, Credit, Fidelity, Bureau 300, C.P. 130 machines*, crédit, 6733 MississaugaRoad Legal expense, Liability and Markborough Place II détournements, frais juridiques, Mississauga, Ontario L5N 6J5 Surety*.(*Denotes classes 6733, chemin Mississauga responsabilité et caution*. Jack (John) P. McCarthy, President limited to the business of Mississauga (Ontario) L5N 6J5 (* Indique que ces branches and Chief Executive Officer. reinsurance.) Jack (John) P. McCarthy, Président d’affaires sont limitées aux et chef de la direction. affaires de réassurances.) 24 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement The Insurance Corporation of New York Property, Accident and sickness, The Insurance Corporation of New York Biens, accidents et maladie, 1145 Nicholson Road, Unit 2 Aircraft, Automobile, Boiler and 1145, chemin Nicholson, Bureau 2 aériennes, automobile, Newmarket, Ontario L3Y 7V1 machinery, Fidelity,Hail, Newmarket (Ontario) L3Y 7V1 chaudières et machines, Colleen Sexsmith, Chief Agent. Liability and Surety, limited to Colleen Sexsmith, Agent principal. détournements, grêle, the business of reinsurance. responsabilité et caution, limitée aux affaires de réassurances. J.C. Penney Life Insurance Company Life, Accident and sickness. Voir-Compagnie d’assurance-vie Suite 500, 80 Tiverton Court J.C. Penney Markham, Ontario L3R 0G4 Isaac Sananes, Chief Agent. Jevco Insurance Company Property, Automobile, Liability Voir-La Compagnie d’Assurances Jevco 2021 Union, Suite 1150 and Surety. Montréal, Quebec H3A 2S9 William G. Star, Chairman, President and Chief Executive Officer. John Alden Life Insurance Company Life, Accident and sickness, on the Voir-La Compagnie D’Assurance-Vie 1145 Nicholson Road, Unit 2 condition that if in the John Alden Newmarket, Ontario L3Y 7V1 transaction of its business in Colleen Sexsmith, Chief Agent. Canada the Company uses a French name, that name shall be “La Compagnie D’Assurance- Vie John Alden”. The company’s business in Canada is limited to the servicing of policies issued prior to April 1, 1991. John Hancock Life Insurance Company Life, Accident and sickness, John Hancock Life Insurance Company Vie, accidents et maladie, limitée à c/o McLean & Kerr limited to the servicing of a/s McLean & Kerr la gestion des polices émises 130 Adelaide Street West, Suite 2800 policies issued prior to 130, rue Adelaide Ouest, Bureau 2800 avant le 31 décembre 1995 Toronto, Ontario M5H 3P5 December 31, 1995 with the Toronto (Ontario) M5H 3P5 exception faite des activités Robin B. Cumine, Q.C., Chief Agent. exception of business arising Robin B. Cumine, C.R., Agent principal. découlant de la conversion de from conversion of group polices collectives à des polices policies to individual policies. individuelles. The Kings Mutual Insurance Company Property and Liability.TheKings Mutual Insurance Company Biens et responsabilité. P.O. Box 10 C.P. 10 Berwick, Nova Scotia B0P 1E0 Berwick (Nouvelle-Écosse) B0P 1E0 Josephus J. Ueffing, President. Josephus J. Ueffing, Président. Lawyers Title Insurance Corporation Title Lawyers Title Insurance Corporation Titres 2170 Torquay Mews 2170, Torquay Mews Mississauga, Ontario L5N 2M6 Mississauga (Ontario) L5N 2M6 Gary Patrick Mooney, Chief Agent. Gary Patrick Mooney,Agent principal. Le Mans Ré Property, Accident and sickness, Le mans Ré Biens, accident et maladie, 20 Queen Street West, Suite 1000 Automobile, Boiler and 20, rue Queen Ouest, Bureau 1000, automobile, chaudières et Toronto, Ontario M5H 3R3 machinery, Fidelity, Liability and Toronto (Ontario) M5H 3R3 machines, détournements, Rui Quintal, Chief Agent. Surety, limited to the business of Rui Quintal, Agent principal. responsabilité et caution, limitée reinsurance. aux affaires de réassurance Legacy General Insurance Company Property, Accident and sickness, Voir-Compagnie d’assurances générales 80 Tiverton Court, Suite 500 andLossofEmployment. Legacy Markham, Ontario L3R 0G4 Aaron Hill, Vice-President and Chief Executive Officer. Liberty Insurance Company of Canada Property, Automobile and Voir-Compagnie d’Assurance Liberté du 200 Consilium Place, 8th Floor Liability. Canada Scarborough, Ontario M1H 3E6 Ronald H. Switzer, President and Chief Executive Officer. Liberty Life Assurance Company of Boston Life, Accident and sickness. Voir-La Compagnie d’Assurance-Vie BCE Place, Bay Wellington Tower Liberté de Boston. 181 Bay Street, Suite 3320 Toronto, Ontario M5J 2T3 Gery Barry, Chief Agent. Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 25

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement Liberty Mutual Fire Insurance Company Property, Accident and sickness, Voir-La Compagnie d’Assurance Générale BCE Place, Bay Wellington Tower Aircraft, Automobile, Boiler and Liberté Mutuelle. 181 Bay Street, Suite 3320 machinery, Fidelity, Liability and Toronto, Ontario M5J 2T3 Surety, limited to the servicing of Gery Barry, Chief Agent. existingpolicies, exceptfor automobile insurance; and on the condition that, if in the transaction of its business in Canada, the company uses a French name, that name shall be “La Compagnie d’Assurance Générale Liberté Mutuelle”. Liberty Mutual Insurance Company Property, Accident and sickness, Voir-La Compagnie d’Assurance Liberté BCE Place, Bay Wellington Tower Aircraft, Automobile, Boiler and Mutuelle 181 Bay Street, Suite 3320 machinery, Fidelity, Liability and Toronto, Ontario M5J 2T3 Surety. Gery Barry, Chief Agent. Life Insurance Company of North America Life, Personal accident and Life Insurance Company of North America Vie, accidents corporels et 55 Town Centre Court, Sickness. 55, cour Town Centre maladie. Suite 606, P.O. Box 14 Bureau 606, C.P. 14 Scarborough, Ontario M1P 4X4 Scarborough (Ontario) M1P 4X4 Eman Hassan, Chief Agent. Eman Hassan, Agent principal. Life Investors Insurance Company of Life, Accident and sickness. Voir-Compagnie D’Assurances Life America Investors D’Amérique c/o John Milnes & Associates 68 Scollard Street, 2nd Floor Toronto, Ontario M5R 1G2 John R. Milnes, Chief Agent. Life Reassurance Corporation of America Life, Accident and sickness, Life Reassurance Corporation of America Vie, accidents et maladie, limitée c/o Deloitte and Touche limited to the business of a/s Deloitte & Touche aux affaires de réassurance. 181 Bay Street, Suite 1400 reinsurance. 181, rue Bay, Bureau 1400 Toronto, Ontario M5J 2V1 Toronto (Ontario) M5J 2V1 P. Wayne Musselman, Chief Agent. P. Wayne Musselman, Agent principal. Lincoln Heritage Life Insurance Company Lincoln Heritage Life Insurance Company see-Superior Life Insurance Company, voir-Superior Life Insurance Company, the name used by Lincoln Heritage le nom utilisé par Lincoln HeritageLife Life Insurance Company to transact Insurance Company dans les affaires au business in Canada. Canada. The Lincoln National Life Insurance Life, Personal accident and The Lincoln National Life Insurance Vie, accidents corporels et Company Sickness. Company maladie. 151 Yonge Street, Suite 1700 151, rue Yonge, Bureau 1700, Toronto, Ontario M5C 2W7 Toronto (Ontario) M5C 2W7 Brenda L. Buckingham, Chief Agent. Brenda L. Buckingham, Agent principal. Lloyd’s Underwriters Property, Accident and sickness, Voir-Les Souscripteurs du Lloyd’s 1155 Metcalfe Street, Suite 1540 Aircraft, Automobile, Boiler and Montréal, Quebec H3B 2V6 machinery, Credit, Fidelity,Hail, Mark J. Oppenheim, Chief Agent. Legal expense, Liability and Surety. Lombard General Insurance Company Property, Aircraft, Automobile, Voir-Compagnie canadienne d’assurances of Canada Boiler and machinery, Credit, générales Lombard. 105 Adelaide Street West Fidelity, Hail, Liability and Toronto, Ontario M5H 1P9 Surety. Byron G. Messier, Chief Executive Officer. Lombard Insurance Company Property, Aircraft, Automobile, Voir-Compagnie d’assurance Lombard. 105 Adelaide Street West Boiler and machinery, Credit, Toronto, Ontario M5H 1P9 Fidelity, Hail, Liability and Byron G. Messier, Chief Surety. Executive Officer. London and Midland General Insurance Property, Accident and sickness, La London et Midland Compagnie Biens, accidents et maladie, Company Automobile, Boiler and d’Assurance Générale automobile, chaudières et 201 Queens Ave., P.O. Box 5071 machinery, Fidelity,Legal 201, av. Queens, C.P. 5071 machines, abus de confiance, London, Ontario N6A 4M5 expense, Liability and Surety. London (Ontario) N6A 4M5 frais juridiques, responsabilité et A. W. Miles, Vice-President and A. W. Miles, Vice-président et caution. General Manager. administrateur gérant. 26 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement London Guarantee Insurance Company Property, Accident and sickness, Voir-Compagnie d’Assurance London 77 King Street West, Suite 3426 Aircraft, Automobile, Credit (on Garantie Royal Trust Tower, P.O. Box 284 condition that the person to Toronto, Ontario M5K 1K2 whom the credit is granted is Robert E. Taylor, President. located in Canada), Boiler and machinery, Fidelity,Hail,Legal Expense, Title, Liability and Surety. London Life Insurance Company Life, Accident and sickness. London Life, Compagnie d’Assurance-Vie Vie, accidents et maladie. 255 Dufferin Ave. 255, av. Dufferin London, Ontario N6A 4K1 London (Ontario) N6A 4K1 Raymond L. McFeetors, President and Raymond L. McFeetors, Président et chef Chief Executive Officer. de la direction. Lumbermens Mutual Casualty Company Property, Accident and sickness, Lumbermens Mutual Casualty Company Biens, accidents et maladie, 320 Front Street West, 6th Floor Aircraft, Automobile, Boiler and 320, rue Front Ouest, 6e étage accidents d’aviation, automobile, Toronto, Ontario M5V 3B6 machinery, Fidelity, Liability and Toronto (Ontario) M5V 3B6 chaudières et machines, abus de Judy Maddocks, Chief Agent. Surety. Judy Maddocks, Agent principal. confiance, responsabilité et caution. Lumbermen’s Underwriting Alliance Property and Boiler and Lumbermen’s Underwriting Alliance Biens, chaudières et machines. 185 Dorval Ave., Suite 500 machinery. 185, av. Dorval, Bureau 500 Dorval, Quebec H9S 5J9 Dorval (Québec) H9S 5J9 Maurice R. Piché, Chief Agent. Maurice R. Piché, Agent principal. The Manufacturers Life Insurance Company Life, Accident and sickness. Voir-La Compagnie d’Assurance-Vie 200 Bloor St. East Manufacturers Toronto, Ontario M4W 1E5 Dominic D’Alessandro, President and Chief Executive Officer. Manulife Financial Corporation Life Voir-Société Financière Manuvie 200 Bloor St. East Toronto, Ontario M4W 1E5 Dominic D’Alessandro, President and Chief Executive Officer. Maritime Insurance Company Limited Property and Liability, limited to Maritime Insurance Company Limited Biens et responsabilité, limitera ses 250 Yonge Street, 15th floor that liability insurance which the 250, rue Yonge, 15e étage activités relatives à l’assurance Toronto, Ontario M5B 2L7 company is authorized to Toronto (Ontario) M5B 2L7 de responsabilité aux catégories Maurice Jaques, Chief Agent. transact in the United Kingdom. Maurice Jaques, Agent principal. qui lui sont autorisées au Royaume-Uni. The Maritime Life Assurance Company Life, Personal accident and La Maritime Compagnie d’Assurance-vie Vie, accidents et maladie. 2701 Dutch Village Rd., P.O. Box 1030 Sickness. 2701, chemin Dutch Village, C.P. 1030 Halifax, Nova Scotia B3J 2X5 Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2X5 Heather Hannon, VP, Counsel and Heather Hannon, VP, Conseillaire et Corporate Secretary Secrétaire corporatif. Markel Insurance Company of Canada Property, Accident and sickness, Markel Compagnie d’Assurance du Canada Biens, accidents et maladie, 105 Adelaide Street West, 7th Floor Aircraft, Automobile, Boiler and 105, rue Adelaide Ouest, 7e étage accidents d’aviation, automobile, Toronto, Ontario M5H 1P9 machinery, Fidelity,Hail, Toronto (Ontario) M5H 1P9 chaudières et machines, abus de Mark Ram, President. Liability and Surety. Mark Ram, Président. confiance, grêle, responsabilité et caution. Maryland Casualty Company Property, Accident and sickness, Voir-Compagnie Maryland Casualty c/o Lavery, DeBilly, Aircraft, Automobile, Boiler and Barristers & Solicitors machinery, Fidelity, Liability and One Place Ville Marie, 40th Floor Surety, on the condition that if in Montréal, Quebec H3B 4M4 the transaction of its business in Pierre Caron, Chief Agent. Canada the Company uses a French name, that name shall be “Compagnie Maryland Casualty”, limited to the servicing of existingpolicies. Massachusetts Mutual Life Insurance Life, Personal accident and Massachusetts Mutual Life Insurance Vie, accidents corporels et Company Sickness Company maladie. c/o McLean & Kerr a/s McLean & Kerr 130 Adelaide St. West, Suite 2800 130, rue Adelaide Ouest, Bureau 2800 Toronto, Ontario M5H 3P5 Toronto (Ontario) M5H 3P5 Robin B. Cumine, Q.C., Chief Agent. Robin B. Cumine, C.R., Agent principal. Metropolitan Life Insurance Company Life, Accident and sickness, on the La Métropolitaine, compagnie Vie, accidents et maladie, à la Constitution Square condition that if in the d’Assurance vie condition que, si la compagnie 360 Albert Street, Suite 1750 transaction of its business in Carré Constitution utilise un nom français dans les Ottawa, Ontario K1R 7X7 Canada the Company uses a 360, rue Albert, Bureau 1750 affaires au Canada, ce nom serait William R. Prueter, Chief Agent. French name, that name shall be Ottawa (Ontario) K1R 7X7 « La Métropolitaine, compagnie “La Métropolitaine, compagnie William R. Prueter, Agent principal. d’Assurance vie ». d’Assurance vie.” Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 27

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement MIC Life Insurance Corporation Life, Accident and sickness, Voir-La Compagnie d’Assurance-Vie MIC P.O. Box 6000, 8500 Leslie St., Suite 400 limited to the servicing of Thornhill, Ontario L3T 4S5 policies issued prior to Charles W. Hastings, Chief Agent. January 1, 1997 and on the condition that if in the transaction of its business in Canada the Company uses a French form of name, that name shall be “La Compagnie d’Assurance-Vie MIC”. Minnesota Life Insurance Company Life, on the condition that if in the Voir-La Compagnie d’Assurance-vie c/o McLean & Kerr transaction of its business in Minnesota. 130 Adelaide St. West, Suite 2800 Canada the foreigncompany Toronto, Ontario M5H 3P5 uses a French name, that name Robin B. Cumine, Q.C., Chief Agent. shall be “Compagnie d’Assurance-vie Minnesota”. The Missisquoi Insurance Company Property, Automobile, Boiler and Voir-La Compagnie d’Assurance Missisquoi. 625 René-Lévesque Blvd. West machinery, Fidelity, Liability and Suite 600 Surety. Montréal, Quebec H3B 1R2 Jean P. Courtemanche, President. Mitsui Marine and Fire Insurance Property, Accident and sickness, Mitsui Marine and Fire Insurance Biens, accidents et maladie, Company, Limited Aircraft, Automobile, Boiler and Company, Limited aériennes, automobile, c/o D.M. Williams & Associates Ltd. machinery, Fidelity, Liability and a/s D.M. Williams & Associates Ltd. chaudières et machines, 3650 Victoria Park Ave., Suite 201 Surety. 3650, av. Victoria Park, Bureau 201 détournements, responsabilité et North York, Ontario M2H 3P7 North York (Ontario) M2H 3P7 caution. V. Lorraine Williams, Chief Agent. V. Lorraine Williams, Agent principal. The Mortgage Insurance Company Fidelity, and Surety, limited to the Voir-La Compagnie d’Assurance of Canada servicing of existingpolicies, d’Hypothèques du Canada 100 Yonge Street, Suite 400 and Mortgage, limited to the Toronto, Ontario M5H 1H1 business of reinsurance. Oscar Zimmerman, President. Motors Insurance Corporation Property, Automobile, Boiler and Motors Insurance Corporation Biens, automobile, chaudières et 8500 Leslie St. machinery, Fidelity, Liability and 8500, rue Leslie machines, abus de confiance, Thornhill, Ontario L3T 4S5 Surety. Thornhill (Ontario) L3T 4S5 responsabilité et caution. Charles W. Hastings, Chief Agent. Charles W. Hastings, Agent principal. Munich Reinsurance Company Life, Property, Accident and La Munich, Compagnie de Réassurance Vie, biens, accidents et maladie, (Munchener Rückversicherungs- sickness, Aircraft, Automobile, (Munchener Rückversicherungs- accidents d’aviation, automobile, Gesellschaft) Boiler and machinery, Credit, Gesellschaft) chaudières et machines, crédit, 390 Bay Street, 26th Floor Fidelity, Hail, Liability and 390, rue Bay,26e étage abus de confiance, grêle, Toronto, Ontario M5H 2Y2 Surety, limited to the business of Toronto (Ontario) M5H 2Y2 responsabilité et caution, limitée Life Branch reinsurance. The Company may Vie aux affaires de réassurance. La James A. Brierley, Chief Agent. use in the transacting of its James A. Brierley,Agent principal. Compagnie peut utiliser dans les Property and Casualty Branch business in Canada its name in Biens et risques divers affaires au Canada son nom en John P. Phelan, Chief Agent. English “Munich Reinsurance John P. Phelan, Agent principal. anglais « Munich Reinsurance Company” or its name in French Company »ousonnomen “La Munich, Compagnie de français « La Munich, Réassurance”. Compagnie de Réassurance ». Munich Reinsurance Company of Canada Property, Accident and sickness, La Munich, du Canada, Compagnie Biens, accidents et maladie, 390 Bay St., 22nd Floor Aircraft, Automobile, Boiler and de Réassurance aériennes, automobile, Toronto, Ontario M5H 2Y2 machinery, Credit, Fidelity,Hail, 390, rue Bay,22e étage chaudières et machines, crédit, John P. Phelan, President. Legal expense, Liability and Toronto (Ontario) M5H 2Y2 détournements, grêle, frais Surety, limited to the business of John P. Phelan, Président. juridiques, responsabilité et reinsurance. caution, limitée aux affaires de réassurance. The Mutual Life Insurance Company Life, Personal accident and The Mutual Life Insurance Company Vie, accidents corporels et of New York Sickness, limited to the servicing of New York maladie, sous réserve de la c/o Tory, Tory, DesLauriers & Binnington of policies issued prior to a/s Tory, Tory, DesLauriers & Binnington restriction que les affaires de la 79 Wellington Street West April 1, 1991. 79, rue Wellington Ouest compagnie soient limitées à Suite 3000, Aetna Tower Bureau 3000, Aetna Tower l’écoulement des polices émises P.O. Box 270, Toronto-Dominion Centre C.P. 270, Toronto-Dominion Centre avant le 1er avril 1991. Toronto, Ontario M5K 1N2 Toronto (Ontario) M5K 1N2 Blair W. Keefe, Chief Agent. Blair W. Keefe, Agent principal. 28 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement Mutual of Omaha Insurance Company Life, Accident and sickness, La Mutuelle d’Omaha, Compagnie Vie, accidents et maladie, limitée à c/o Cassels, Brock & Blackwell limited to the servicing of d’Assurance la gestion des polices émises 40 King Street West policies issued prior to a/s Cassels, Brock & Blackwell avant le 1er janvier 1998, pourvu Scotia Plaza, Suite 2100 January 1, 1998, on the condition 40, rue King Ouest que, si la société étrangère utilise Toronto, Ontario M5H 3C2 that if in the transaction of its Scotia Plaza, Bureau 2100 une dénomination sociale J. Brian Reeve, Chief Agent. business in Canada the foreign Toronto (Ontario) M5H 3C2 française dans le cadre de company uses a French form of J. Brian Reeve, Agent principal. l’exercice de son activité au name, that name shall be “La Canada, ce soit « La Mutuelle Mutuelle d’Omaha, Compagnie d’Omaha, Compagnie d’assurance”. d’assurance ». La Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D. Property, Accident and sickness, La Mutuelle Du Mans Assurances I.A.R.D. Biens, accidents et maladie, 20 Queen St. West, Suite 1000 Automobile, Boiler and 20, rue Queen Ouest, Bureau 1000 automobile, chaudières et Toronto, Ontario M5H 3R3 machinery, Fidelity, Liability and Toronto (Ontario) M5H 3R3 machines, abus de confiance, Rui Quintal, Chief Agent. Surety, limited to the business of Rui Quintal, Agent principal. responsabilité et caution, limitée reinsurance. aux affaires de réassurance. La Mutuelle du Mans Assurances Vie Life, Accident and sickness, La Mutuelle du Mans Assurances Vie Vie, accidents et maladie, limitée c/o Industrial-Alliance Life Insurance Co. limited to the business of a/s L’Industrielle-Alliance Compagnie aux affaires de réassurance. 1080 St-Louis Road, reinsurance. d’Assurance sur la Vie P.O. Box 1907, Station Terminus 1080, chemin St-Louis Sillery, Quebec G1K 7M3 C.P. 1907, succursale Terminus Yvon Charest, Chief Agent. Sillery (Québec) G1K 7M3 Yvon Charest, Agent principal. NAC Reinsurance Corporation Surety, limited to the business of NAC Reinsurance Corporation Caution, limitée aux affaires de 211 Consumers Road, Suite 300 reinsurance, and Property, 211, chemin Consumers, Bureau 300 réassurance, et biens, accident et North York, Ontario M2J 4G8 Accident and sickness, Aircraft, North York (Ontario) M2J 4G8 maladie, aériennes, automobile, Denis Shillington, Chief Agent. Automobile, Fidelity,Hailand Denis Shillington, Agent principal. détournements, grêle et Liability. responsabilité. National Fidelity Life Insurance Company Life, Personal accident and National Fidelity Life Insurance Company Vie, accidents corporels et 19 Celina Street, Suite 104 Sickness 19, rue Celina, Bureau 104 maladie. Oshawa, Ontario L1H 4M9 Oshawa (Ontario) L1H 4M9 J. Terence Hogan, Chief Agent. J. Terence Hogan, Agent principal. The National Life Assurance Company Life, Personal accident and La Nationale du Canada, Compagnie Vie, accidents corporels et of Canada Sickness. d’Assurance-Vie maladie. 522 University Ave. 522, av. University Toronto, Ontario M5G 1Y7 Toronto (Ontario) M5G 1Y7 Vincent Tonna, President and Chief Vincent Tonna, Président et chef Operating Officer. des opérations. National Reinsurance Corporation Property, Automobile, Boiler and National Reinsurance Corporation Biens, automobile, chaudières et 1 First Canadian Place machinery, Hail and Liability, 1 First Canadian Place machines, grêle et responsabilité, Suite 5705, P.O. Box 471 limited to the business of Bureau 5705, C.P. 471 limitée aux affaires de Toronto, Ontario M5X 1E4 reinsurance. Toronto (Ontario) M5X 1E4 réassurance. Gerald A. Wolfe, Chief Agent. Gerald A. Wolfe, Agent principal. Nationwide Mutual Insurance Company Property, Accident and sickness, Nationwide Mutual Insurance Company Biens, accidents et maladie, c/o John Milnes & Associates Aircraft, Automobile, Boiler and a/s John Milnes & Associates accidents d’aviation, automobile, 2nd Floor, 68 Scollard Street machinery, Fidelity,Hail, 2e étage, 68, rue Scollard chaudières et machines, abus de Toronto, Ontario M5R 1G2 Liability and Surety. Toronto (Ontario) M5R 1G2 confiance, grêle, responsabilité et John R. Milnes, Chief Agent. John R. Milnes, Agent principal. caution. Nederlandse Reassurantie Groep N.V. Property, Accident and sickness, Nederlandse Reassurantie Groep N.V. Biens, accidents et maladie, 995 Dupont Street Automobile, Fidelity,Hail, 995, rue Dupont automobile, abus de confiance, Toronto, Ontario M6H 1Z5 Liability and Surety, limited to Toronto (Ontario) M6H 1Z5 grêle, responsabilité et caution, Robert De Marco, Chief Agent. the business of reinsurance, and Robert De Marco, Agent principal. limitée aux affaires de limited to the servicing of réassurance et limitée à existingpolicies; on the l’administration des polices condition that if in the existantes, à la condition que transaction of its business in lorsque la compagnie utilise un Canada the Company uses an nom anglais dans l’exercice de anglicized name, that name shall ses activités au Canada, ce nom be “Netherlands Reinsurance soit « Netherlands Reinsurance Group N.V.”. Group N.V. ». New Hampshire Insurance Company Property, Accident and sickness, New Hampshire Insurance Company Biens, accidents et maladie, 145 Wellington St. West Aircraft, Automobile, Boiler and 145, rue Wellington Ouest accidents d’aviation, automobile, Toronto, Ontario M5J 1H8 machinery, Fidelity, Liability and Toronto (Ontario) M5J 1H8 chaudières et machines, abus de Gary A. McMillan, Chief Agent. Surety. Gary A. McMillan, Agent principal. confiance, responsabilité et caution. Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 29

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement The New India Assurance Company, Fire, Accident, Automobile, Boiler The New India Assurance Company, Incendie, accidents, automobile, Limited excluding machinery, Inland Limited biens immeubles, biens meubles, c/o M. Schwab Accounting Services transportation, Personal property, a/s M. Schwab Accounting Services brise des glaces, chaudières (les Limited Plate glass, Real property,Theft Limited machines non comprises), 278 Bloor Street East, Suite 401 and additional classes 1, 2, 3, 4, 278, rue Bloor Est, Bureau 401 transports terrestres, vol et Toronto, Ontario M4W 3M4 5, 6, 7, 8, 9 and 10 (See Note Toronto (Ontario) M4W 3M4 catégories additionnelles 1, 2, 3, Fernao Ferreira, Chief Agent. (B)), limited to the servicing of Fernao Ferreira, Agent principal. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 (Voir existingpolicies. Remarque (B)), limitée à l’administration des polices existantes. New York Life Insurance Company Life, Accident and sickness, on the Voir-Compagnie d’assurances Scotia Plaza, Suite 2100 condition that if in the New York Life 40 King Street West transaction of its business in Toronto, Ontario M5H 3C2 Canada the Company uses a J. Brian Reeve, Chief Agent. French name, that name shall be “Compagnie d’assurances New York Life”. Niagara Fire Insurance Company Property, Accident and sickness, Niagara Fire Insurance Company Biens, accidents et maladie, c/o CAS Accounting for Insurance Inc. Aircraft, Automobile, Boiler and a/s CAS Accounting for Insurance Inc. aériennes, automobile, Unit 2, 1145 Nicholson Road machinery, Credit, Fidelity,Hail, 1145, chemin Nicholson, Unité 2 chaudières et machines, crédit, Newmarket, Ontario L3Y 7V1 Liability and Surety. Newmarket (Ontario) L3Y 7V1 détournements, grêle, Colleen Anne Sexsmith, Chief Agent. Colleen Anne Sexsmith, Agent principal. responsabilité et caution. The Nippon Fire & Marine Insurance Property, Accident and sickness, The Nippon Fire & Marine Insurance Biens, accidents et maladie, Company Limited Aircraft, Automobile, Boiler and Company Limited accidents d’aviation, automobile, c/o The General Accident Assurance machinery, Fidelity, Liability and a/s General Accident, Compagnie chaudières et machines, abus de Company of Canada Surety. d’Assurance du Canada confiance, responsabilité et 2206 Eglinton Ave. East, Suite 500 2206, av. Eglinton Est, Bureau 500 caution. Scarborough, Ontario M1L 4S8 Scarborough (Ontario) M1L 4S8 Normand W. McIntyre, Chief Agent. Normand W. McIntyre, Agent principal. NN Life Insurance Company of Canada Life, Accident and sickness. NN Compagnie d’Assurance-Vie du Canada Vie, accidents et maladie. One Concorde Gate One Concorde Gate Don Mills, Ontario M3C 3N6 Don Mills (Ontario) M3C 3N6 Claude Dussault, President and Chief Claude Dussault, Président et chef Executive Officer. de la direction. See-First North American Insurance La Nord-américaine, première compagnie Biens, limitée à l’assurance contre Company. d’assurance la perte de revenus, l’assurance 5650, rue Yonge bagages, l’assurance réparation North York (Ontario) M2M 4G4 et remplacement de Dominic D’Alessandro, Président et marchandises et l’assurance des chef de la direction. cartes de crédit résultant d’initiatives de marketing de masse, accidents et maladie et automobile, limitée au dédommagement des détenteurs d’une carte de crédit assurés en vertu d’une assurance collective accordant des droits d’exonération. The Nordic Insurance Company of Canada Property, Accident and sickness, La Nordique compagnie d’assurance Biens, accidents et maladie, P.O. Box 4096, Station A Aircraft, Automobile, Boiler and du Canada aériennes, automobile, Toronto, Ontario M5W 1N1 machinery, Credit, Fidelity, C.P. 4096, Succursale A chaudières et machines, crédit, Henry J. Curtis, President Legal expense, Liability and Toronto (Ontario) M5W 1N1 détournements, frais juridiques, and Chief Executive Officer. Surety. Henry J. Curtis, Président et chef responsabilité et caution. de la direction. Nordisk Reinsurance Company A/S Property, Automobile and Nordisk Reinsurance Company A/S Biens, automobile et c/o M. Schwab Accounting Services Liability, limited to the business a/s M. Schwab Accounting Services responsabilité, limitée aux Limited of reinsurance, and to the Limited affaires de réassurance et à 278 Bloor Street East, Suite 401 servicing of existingpolicies. 278, rue Bloor Est, Bureau 401 l’administration des polices Toronto, Ontario M4W 3M4 Toronto (Ontario) M4W 3M4 existantes. Fernao Ferreira, Chief Agent. Fernao Ferreira, Agent principal. The North Waterloo Farmers Mutual Property, Automobile, Boiler and The North Waterloo Farmers Mutual Biens, automobile, chaudières et Insurance Company machinery, Hail, Fidelity and Insurance Company machines, grêle, détournements 100 Erb St. East Liability. 100, rue Erb Est et responsabilité. Waterloo, Ontario N2J 2L5 Waterloo (Ontario) N2J 2L5 Robert Monte, General Manager. Robert Monte, Directeur général. The North West Life Assurance Company Life, Personal accident and Voir-La Compagnie d’Assurance-Vie of Canada Sickness. North West du Canada 2165 Broadway West, P.O. Box 5900 Vancouver, British Columbia V6B 5H6 Douglas A. Carrothers, Vice-President, General Counsel and Secretary. 30 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement Northern Indemnity,Inc. Property, Liability, Fidelity and Voir-La Compagnie d’Indemnité du Nord, 2 Bloor Street West, Suite 1500 Surety Inc. Toronto, Ontario M4W 3E2 Robert Lamendola, President. Norwich Union Life Insurance Company Life, Accident and sickness. Norwich Union du Canada, Compagnie Vie, accidents et maladie. (Canada) d’assurance-vie 60 YongeSt. 60, rue Yonge Toronto, Ontario M5E 1H5 Toronto (Ontario) M5E 1H5 Guy S. Pentelow, President and Chief Guy S. Pentelow, Président et chef Executive Officer. de la direction. NRG Victory Reinsurance Limited Property, Automobile, Fidelity, NRG Victory Reinsurance Limited Biens, automobile, abus de 995 Dupont Street Liability and Surety, limited to 995, rue Dupont confiance, responsabilité et Toronto, Ontario M6H 1Z5 the business of reinsurance, and Toronto (Ontario) M6H 1Z5 caution, limitée aux affaires de Robert De Marco, Chief Agent. to the servicing of existing Robert De Marco, Agent principal. réassurance, et à l’administration policies. des polices existantes. NW Reinsurance Corporation Limited Property, Accident and sickness, NW Reinsurance Corporation Limited Biens, accidents et maladie, c/o D. M. Williams & Associates Ltd. Automobile, Boiler and a/s D. M. Williams & Associates Ltd. automobile, chaudières et 3650 Victoria Park Ave., Suite 201 machinery, Fidelity,Hail, 3650, av. Victoria Park, Bureau 201 machines, détournements, grêle, North York, Ontario M2H 3P7 Liability and Surety, limited to North York (Ontario) M2H 3P7 responsabilité et caution, limitée V. Lorraine Williams, Chief Agent. the business of reinsurance, and V. Lorraine Williams, Agent principal. aux affaires de réassurance, et limited to the servicing of limitées à l’écoulement des existingpolicies. polices émises. Odyssey America Reinsurance Corporation Property, Accident and sickness, Odyssey America Compagnie de Biens, accidents et maladie, c/o Canadian Insurance Consultants Inc. Aircraft, Automobile, Boiler and Réassurance aériennes, automobile, 133 Richmond St. West, Suite 600 machinery,Hail,Legal expense a/s Canadian Insurance Consultants Inc. chaudières et machines, grêle, Toronto, Ontario M5H 2L3 and Liability, limited to the 133, rue Richmond Ouest, Bureau 600 frais juridiquesetresponsabilité, Donald G. Smith, Chief Agent business of reinsurance and on Toronto (Ontario) M5H 2L3 limitée aux affaires de the condition that if in the Donald G. Smith, Agent principal. réassurance et pourvu que, si la transaction of its business in société utilise une dénomination Canada the company uses a sociale française dans le cadre de French name, that name shall be l’exercice de son activité au “Odyssey America Compagnie Canada, ce soit « Odyssey de Réassurance”. America Compagnie de Réassurance ». Odyssey Reinsurance Company of Canada Property, Automobile, Boiler and Odyssey, société canadienne de réassurance Biens, automobile, chaudières et 55 University Ave., Suite 1600 machinery, Fidelity,Hail, 55, av. University, Bureau 1600 machines, détournements, grêle, Toronto, Ontario M5J 2H7 Liability and Surety, limited to Toronto (Ontario) M5J 2H7 responsabilité et caution, limitée Robert H. Ysseldyk, President. the business of reinsurance with Robert H. Ysseldyk, Président. aux affaires de réassurance et, surety insurance also limited to pour caution, limitée à the servicing of existingpolicies. l’écoulement des polices existantes. Old Republic Insurance Company of Canada Property, Aircraft, Automobile and Voir-L’Ancienne République, Compagnie 100 King St. West, P.O. Box 557 Liability. d’Assurance du Canada. Hamilton, Ontario L8N 3K9 Frank Szirt, President and Chief Executive Officer. See-Peopleplus Insurance Company. Omnimonde, Compagnie d’assurances Biens, accidents et maladie, 400, av. University aériennes, automobile, Toronto (Ontario) M5G 1S7 chaudières et machines, Barry Gilway, Président et chef détournements, grêle, de la direction. responsabilité et caution. The Paul Revere Life Insurance Company Life, Accident and sickness and Paul Revere Compagnie d’Assurance-Vie Vie, accidents et maladie et la 5420 North Service Road, P.O. Box 5044 the Company may use in the 5420, chemin North Service, C.P. 5044 Compagnie peut utiliser dans les Burlington, Ontario L7R 4C1 transaction of its business in Burlington (Ontario) L7R 4C1 affaires au Canada son nom en George A. Shell, Chief Agent. Canada its name in English “The George A. Shell, Agent principal. anglais « The Paul Revere Life Paul Revere Life Insurance Insurance Company »ouson Company” or its name in French nom en français « Paul Revere “Paul Revere Compagnie Compagnie d’Assurance-Vie » d’Assurance-Vie”, or both of ou tous deux à la fois. such names. Pearl Assurance Public Limited Company Property and Liability, limited to Pearl Assurance Public Limited Company Biens et responsabilité, limitée à c/o Focus Group Inc. the servicing of existingpolicies. a/s Focus Group Inc. l’administration des polices 36 King Street East, Suite 500 36, rue King Est, Bureau 500 existantes. Toronto, Ontario M5C 1E5 Toronto (Ontario) M5C 1E5 P. H. Cook, Chief Agent. P. H. Cook, Agent principal. Penncorp Life Insurance Company Life, Accident and sickness. Voir-La Compagnie D’Assurance-Vie 90 Dundas Street West, Suite 400 Penncorp. Mississauga, Ontario L5B 2T5 J. Paul Edmondson, President and Chief Executive Officer. Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 31

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement Pennsylvania Life Insurance Company Life, Accident and sickness. Pennsylvania Life Insurance Company Vie, accidents et maladie. 90 Dundas Street West, Suite 400 90, rue Dundas Ouest, Bureau 400 Mississauga, Ontario L5B 2T5 Mississauga (Ontario) L5B 2T5 J. Paul Edmondson, Chief Agent. J. Paul Edmondson, Agent principal. Peopleplus Insurance Company Property, Accident and sickness, Voir-Omnimonde, Compagnie d’assurances. 400 University Ave. Aircraft, Automobile, Boiler and Toronto, Ontario M5G 1S7 machinery, Fidelity,Hail, Barry Gilway, President and Chief Liability and Surety. Executive Officer. The Personal Insurance Company of Canada Property, Accident and sickness, La Personnelle, compagnie d’assurance Biens, accidents et maladie, 3 Robert Speck Parkway Automobile, Aircraft, Boiler and du Canada automobile, accidents d’aviation, Suite 500, P.O. Box 7065 machinery, Fidelity, Liability and 3, promenade Robert Speck chaudières et machines, abus de Mississauga, Ontario L5A 4K7 Surety. Bureau 500, C.P. 7065 confiance, responsabilité et Dwight Lacey, Chief Executive Officer. Mississauga (Ontario) L5A 4K7 caution. Dwight Lacey, Chef de la direction. Perth Insurance Company Property, Automobile, and Perth, Compagnie d’Assurance Biens, automobile, et 111 Westmount Road South Liability. 111, chemin Westmount Sud, C.P. 2000 responsabilité. P.O. Box 2000 Waterloo (Ontario) N2J 4S4 Waterloo, Ontario N2J 4S4 Noel G. Walpole, Président et chef Noel G. Walpole, President and Chief de la direction. Executive Officer. Philadelphia Reinsurance Corporation Property, Aircraft, Automobile, Philadelphia Reinsurance Corporation Biens, accidents d’aviation, 995 Dupont Street Boiler and machinery, Fidelity, 995, rue Dupont automobile, chaudières et Toronto, Ontario M6H 1Z5 Hail, Liability and Surety, Toronto (Ontario) M6H 1Z5 machines, abus de confiance, Robert DeMarco, Chief Agent. limited to the business of Robert DeMarco, Agent principal. grêle, responsabilité et caution, reinsurance, and to the servicing limitée aux affaires de of existingpolicies. réassurance, et à l’administration des polices existantes. Phoenix Home Life Mutual Insurance Life, Accident and sickness. Phoenix Home Life Mutual Insurance Vie, accidents et maladie. Company Company 40 King Street West 40, rue King Ouest Scotia Plaza, Suite 2100 Scotia Plaza, Bureau 2100 Toronto, Ontario M5H 3C2 Toronto (Ontario) M5H 3C2 J. Brian Reeve, Chief Agent. J. Brian Reeve, Agent principal. The Phoenix Insurance Company Fire, Accident, Aircraft excluding The Phoenix Insurance Company Incendie, accidents, aéronefs sauf 36 Toronto Street, Suite 1070 insurance against liability for 36, rue Toronto, Bureau 1070 l’assurance responsabilité contre Toronto, Ontario M5C 2C5 loss or damagetopersons caused Toronto (Ontario) M5C 2C5 la perte et les dommages causés Brian E. Divell, Chief Agent. by an aircraft or the use or Brian E. Divell, Agent principal. aux personnes par un aéronef ou operation thereof, Automobile, par l’utilisation ou le Boiler, Earthquake, Explosion, fonctionnement d’un aéronef, Forgery, Guarantee, Inland automobile, biens immeubles, transportation, Machinery, biens meubles, brise des glaces, Personal property,Plateglass, chaudières, explosions, faux, Real property, Theft and garantie, machines, transports additional classes 3, 4, 5, 7, 8, 9 terrestres, tremblements de terre, and 10. (See Note (B)) vol et catégories additionnelles 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10. (Voir Remarque (B)) Pictou County Farmers’ Mutual Fire Property and Liability, restricted to Pictou County Farmers’ Mutual Fire Biens et responsabilité, limitée à la Insurance Company the Province of Nova Scotia. Insurance Company province de la Nouvelle-Écosse. P.O. Box 130 C.P. 130 Pictou, Nova Scotia B0K 1H0 Pictou (Nouvelle-Écosse) B0K 1H0 Heather Smith, Secretary-Treasurer. Heather Smith, Secrétaire-trésorier. Pierce National Life Insurance Company Life. Pierce National Life Insurance Company Vie. 1145 Nicholson Road, Unit 2 1145, chemin Nicholson, Unité 2 Newmarket, Ontario L3Y 7V1 Newmarket (Ontario) L3Y 7V1 Colleen Sexsmith, Chief Agent. Colleen Sexsmith, Agent principal. Pohjola Group Insurance Corporation Property, Accident and sickness, Pohjola Group Insurance Corporation Biens, accidents et maladie, 1801 McGill College Avenue, Suite 710 Automobile, Boiler and 1801, av. McGill College, Bureau 710 automobile, chaudières et Montréal, Quebec H3A 3P5 machinery, Fidelity, Liability and Montréal (Québec) H3A 3P5 machines, détournements, René Lapierre, Chief Agent. Surety, limited to the business of René Lapierre, Agent principal. responsabilité et caution, reinsurance and to the servicing limitées aux affaires de of existingpolicies. réassurance et limitées à l’écoulement des polices existantes. Pool Insurance Company Property. Pool Insurance Company Biens. 220 Portage Ave., Suite 1007 220, av. Portage, Bureau 1007 Royal Bank Building Édifice Royal Bank Winnipeg, Manitoba R3C 0A5 Winnipeg (Manitoba) R3C 0A5 Charles H. Swanson, President. Charles H. Swanson, Président. 32 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement The Portage la Prairie Mutual Insurance Property, Automobile, Legal The Portage la Prairie Mutual Insurance Biens, automobile, frais juridiques Company expense and Liability. Company et responsabilité. P.O. Box 340 C.P. 340, 749, av. Saskatchewan Est 749 Saskatchewan Avenue East Portage la Prairie (Manitoba) R1N 3B8 Portage la Prairie, Manitoba R1N 3B8 H. G. Owens, Président. H. G. Owens, President. Primerica Life Insurance Company Life, Accident and sickness. Voir-La Compagnie d’Assurance-Vie of Canada Primerica du Canada. 2000 Argentia Road, Plaza V, Suite 300 Mississauga, Ontario L5N 2R7 Glenn J. Williams, Executive Vice- President and Chief Executive Officer. Principal Life Insurance Company Life, Accident and sickness, on the Voir-Compagnie d’assurance-vie Principal 68 Scollard Street, 2nd Floor condition that if in the Toronto, Ontario M5R 1G2 transaction of its business in John Milnes, Chief Agent. Canada the foreigncompany uses a French name, that name shall be “Compagnie d’assurance-vie Principal”. Progressive Casualty Insurance Company Property, Automobile, Liability Progressive Casualty Insurance Company Biens, automobile, responsabilité 200 Yorkland Blvd., 5th Floor and Surety. 200, boul. Yorkland, 5e étage et caution. Willowdale, Ontario M2J 5C1 Willowdale (Ontario) M2J 5C1 Ms. Anderson, Chief Agent. Ms. Anderson, Agent principal. Progressive Casualty Insurance Company Property, Liability, Automobile Progressive du Canada Compagnie Biens, responsabilité, automobile of Canada and Surety. d’Assurance Générale et caution. 200 Yorkland Blvd., 5th Floor 200, boul. Yorkland, 5e étage Willowdale, Ontario M2J 5C1 Willowdale (Ontario) M2J 5C1 William J. Conner III, President. William J. Conner III, Président. Protective Insurance Company Property, Accident and sickness, La Protectrice, société d’assurance Biens, accidents et maladie, 68 Scollard Street, 2nd Floor Automobile and Liability. 68, rue Scollard, 2e étage automobile et responsabilité. Toronto, Ontario M5R 1G2 Toronto (Ontario) M5R 1G2 John R. Milnes, Chief Agent. John R. Milnes, Agent principal. Providence Washington Insurance Company Property, Automobile and Providence Washington Insurance Company Biens, automobile et 155 University Avenue, Suite 1703 Liability. 155, av. University, Bureau 1703 responsabilité. Toronto, Ontario M5H 3B7 Toronto (Ontario) M5H 3B7 Jack Gorman Dovey, Chief Agent. Jack Gorman Dovey,Agent principal. Provident Life and Accident Insurance Life, Accident and sickness. Provident Compagnie d’Assurance-vie Vie, accidents et maladie. Company et Accident 5420 North Service Road 5420, chemin North Service P.O. Box 5044 C.P. 5044 Burlington, Ontario L7R 4C1 Burlington (Ontario) L7R 4C1 George A. Shell, Chief Agent. George A. Shell, Agent principal. The Prudential Assurance Company Limited Life, Accident and sickness, The Prudential Assurance Company Limited Vie, accidents et maladie, limitée à (of England) limited to the servicing of (of England) la gestion des polices émises c/o Stikeman, Elliott policies issued prior to a/s Stikeman, Elliott avant le 28 février 1995. Suite 5300, Commerce Court West February 28, 1995. Bureau 5300, Commerce Court West Toronto, Ontario M5L 1B9 Toronto (Ontario) M5L 1B9 W. Brian Rose, Chief Agent. W. Brian Rose, Agent principal. The Prudential Insurance Company Life, Accident and sickness, on the La Prudentielle d’Amérique, Compagnie Vie, accidents et maladie, à la of America condition that if, in the d’Assurance condition que, si la Compagnie 300 Consilium Place, Suite 1200 transaction of its business in 300, place Consilium, Bureau 1200 utilise un nom français dans ses Toronto, Ontario M1H 3G2 Canada, the Company uses a Toronto (Ontario) M1H 3G2 affaires au Canada, ce nom serait Brian G. Barbeau, Chief Agent. French name, that name shall be Brian G. Barbeau, Agent principal. « La Prudentielle d’Amérique, “La Prudentielle d’Amérique, Compagnie d’Assurance ». Compagnie d’Assurance”. Prudential of America Life Insurance Life, Accident and sickness. La Prudentielle d’Amérique, Compagnie Vie, accidents et maladie. Company (Canada) d’Assurance-Vie (Canada) 200 Front Street West, Suite 2300 200, rue Front Ouest, Bureau 2300 Toronto, Ontario M5V 3K6 Toronto (Ontario) M5V 3K6 Ronald Meredith-Jones, President and Ronald Meredith-Jones, Président et chef Chief Executive Officer. de la direction. Quebec Assurance Company Property, Accident and sickness, Voir-Compagnie d’Assurance du Québec 3500 de Maisonneuve Blvd. West Aircraft, Automobile, Boiler and 2 place Alexis-Nihon, Suite 800 machinery, Fidelity, Liability and Montréal, Quebec H3Z 3C1 Surety. Robert John Gunn, President. Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 33

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement RBC General Insurance Company Property, Accident and sickness, Voir-Compagnie d’assurance générale RBC 55 City Centre Drive, Suite 1100 Automobile and Liability. Mississauga, Ontario L5B 1M3 Andrew Rogacki, President and Chief Executive Officer RBC Life Insurance Company Life, Accident and sickness. Voir-Compagnie d’assurance vie RBC 55 City Centre Drive, Suite 1100 Mississauga, Ontario L5B 1M3 W. Grant Hardy, President and Chief Executive Officer. Reliable Life Insurance Company Life, Accident and sickness. La Reliable, Compagnie d’Assurance-Vie Vie, accidents et maladie. P.O. Box 557, 100 King St. West C.P. 557, 100, rue King Ouest Hamilton, Ontario L8N 3K9 Hamilton (Ontario) L8N 3K9 Richard A. Hine, President and Richard A. Hine, Président et Chief Executive Officer. chef de la direction. Reliance Insurance Company Property, Accident and sickness, Reliance Insurance Company Biens, accidents et maladie, 200 King St. West Aircraft, Automobile, Boiler and 200, rue King Ouest accidents d’aviation, automobile, Suite 1906, P.O. Box 61 machinery, Fidelity, Liability and Bureau 1906, C.P. 61 chaudières et machines, abus de Toronto, Ontario M5H 3T4 Surety. Toronto (Ontario) M5H 3T4 confiance, responsabilité et Arthur Denis Joseph Morin, Chief Agent. Arthur Denis Joseph Morin, Agent caution. principal. ReliaStar Life Insurance Company Life, Accident and sickness, Voir-Compagnie D’Assurance-Vie ReliaStar. 3650 Victoria Park Ave., Suite 201 limited to the business of North York, Ontario M2H 3P7 reinsurance, except that the V. Lorraine Williams, Chief Agent. foreigncompany may also provide insurance on the lives of residents of Canada insured under grouppolicies issued in the United States, and on the condition that if the foreign company uses a French name, the name shall be “Compagnie D’Assurance-Vie ReliaStar”. RGA Life Reinsurance Company of Canada Life, Accident and sickness, RGA Compagnie de réassurance-vie du Vie, accidents et maladie, limitée 55 University Avenue, Suite 1200 limited to the business of Canada aux affaires de réassurance. Toronto, Ontario M5J 2H7 reinsurance. 55, av. University, Bureau 1200 André St-Amour, President and Chief Toronto (Ontario) M5J 2H7 Executive Officer. André St-Amour, Président et chef de la direction. Rhine Reinsurance Company Limited Property, Accident and sickness, Rhin Réassurance S.A. Biens, accidents et maladie, 55 University Avenue Automobile, Boiler and 55, avenue University automobile, chaudières et Suite 900, P.O. Box 6 machinery, Fidelity,Hail, Bureau 900, C.P. 6 machines, détournements, grêle, Toronto, Ontario M5J 2H7 Liability and Surety, limited to Toronto (Ontario) M5J 2H7 responsabilité et caution, limitée Patrick J. King, Chief Agent. the business of reinsurance. Patrick J. King,Agent principal. aux affaires de réassurance. Royal & Sun Alliance Life Insurance Life, Accident and sickness. Royal & Sun Alliance du Canada, société Vie, accidents et maladie. Company of Canada d’assurance-vie. 277 Lakeshore Road East, Suite 300 277, chemin Lakeshore Est, Bureau 300 Oakville, Ontario L6J 1H9 Oakville (Ontario) L6J 1H9 Clive S. Smith, President and Chief Clive S. Smith, Président et chef Executive Officer. de la direction. Royal & Sun Alliance Insurance Property, Accident and sickness, Royal & Sun Alliance du Canada, Biens, accidents et maladie, Company of Canada Aircraft, Automobile, Boiler and société d’assurances aériennes, automobile, 10 Wellington St. East machinery, Fidelity,Hail,Legal, 10, rue Wellington Est chaudières et machines, Toronto, Ontario M5E 1L5 Liability and Surety. Toronto (Ontario) M5E 1L5 détournements, grêle, frais Robert John Gunn, President. Robert John Gunn, Président. juridiques, responsabilité et caution. Royal Maccabees Life Insurance Company Life, Accident and sickness, Royal Maccabees Life Insurance Company Vie, accidents et maladie, sous 176 University Avenue West, Suite 600 limited to the servicing of 176, av. University Ouest, Bureau 600 réserve de la restriction que les Windsor, Ontario N9A 5P1 policies issued prior to Windsor (Ontario) N9A 5P1 affaires de la compagnie soient Frederic G. Farrell, Q.C., Chief Agent. June 1, 1992. Frederic G. Farrell, C.R., Agent principal. limitées à l’écoulement des polices émises avant le 1er juin 1992. Royale Belge Life, limited to the business of Royale Belge Vie, limitée aux affaires de 425 de Maisonneuve Blvd. West reinsurance. 425, boul. de Maisonneuve Ouest réassurance. Suite 1200 Bureau 1200 Montréal, Quebec H3A 3G5 Montréal (Québec) H3A 3G5 Harvey Campbell, Chief Agent. Harvey Campbell, Agent principal. 34 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement SAFECO Insurance Company of America Property, Automobile, Fidelity, SAFECO Insurance Company of America Biens, automobile, abus de c/o Fasken, Campbell, Godfrey Liability and Surety, limited to a/s Fasken, Campbell, Godfrey confiance, responsabilité et Toronto-Dominion Bank Tower the servicing of existingpolicies. Toronto-Dominion Bank Tower caution, limitée à Toronto-Dominion Centre, P.O. Box 20 Toronto-Dominion Centre, C.P. 20, l’administration des polices Toronto, Ontario M5K 1N6 Toronto (Ontario) M5K 1N6 existantes. Robert M. Sutherland, Q.C., Chief Agent. Robert M. Sutherland, C.R., Agent principal. SAFR PartnerRe Life, Property, Accident and SAFR PartnerRe Vie, biens, accidents et maladie, 130 King Street West sickness, Aircraft, Automobile, 130, rue King Ouest aériennes, automobile, Suite 2300, P.O. Box 166 Boiler and machinery, Credit, Bureau 2300, C.P. 166 chaudières et machines, crédit, Toronto, Ontario M5X 1C7 Fidelity, Hail, Liability and Toronto (Ontario) M5X 1C7 détournements, grêle, P. Lacourte, Chief Agent. Surety, limited to the business of P. Lacourte, Agent principal. responsabilité et caution, reinsurance. limitées aux affaires de réassurance. Saskatchewan Mutual Insurance Company Property, Automobile, Boiler and Saskatchewan Mutual Insurance Company Biens, automobile, chaudières et 279–3rd Avenue North machinery, Fidelity and Liability. 279, 3e Avenue Nord machines, détournements et Saskatoon, Saskatchewan S7K 2H8 Saskatoon (Saskatchewan) S7K 2H8 responsabilité. Randy W. Trost, President. Randy W. Trost, Président. SCOR Canada Reinsurance Company Property, Accident and sickness, SCOR Canada Compagnie de Réassurance Biens, accidents et maladie, BCE Place, 161 Bay Street, Suite 5000 Automobile, Boiler and Place BCE, 161, rue Bay, Bureau 5000 automobile, chaudières et Toronto, Ontario M5J 2T7 machinery, Fidelity,Hail, Toronto (Ontario) M5J 2T7 machines, détournements, grêle, Dominique Lavallee, President and Chief Liability and Surety, limited to Dominique Lavallee, Président et chef responsabilité et caution, limitée Executive Officer. the business of reinsurance. de la direction. aux affaires de réassurance. SCOR Reinsurance Company Property, Automobile, Aircraft, SCOR, Compagnie de Réassurance Biens, automobile, aériennes, BCE Place, 161 Bay Street, Suite 5000 Fidelity, Liability and Surety, Place BCE, 161, rue Bay, Bureau 5000 détournements, responsabilité et Toronto, Ontario M5J 2T7 limited to the business of Toronto (Ontario) M5J 2T7 caution, limitée aux affaires de Jaya Narayan, Chief Agent. reinsurance. Jaya Narayan, Agent principal. réassurance. SCOR Vie Life, Accident and sickness, SCOR Vie Vie, accidents et maladie, limitée 1250 René-Lévesque blvd. West limited to the business of 1250, boul. René-Lévesque Ouest aux affaires de réassurance. Suite 4510 reinsurance. Bureau 4510 Montreal, Quebec H3B 4W8 Montréal (Québec) H3B 4W8 Jacques Sabourin, Chief Agent. Jacques Sabourin, Agent principal. Scotia General Insurance Company Property, Accident and sickness, Scotia Générale, compagnie d’assurance Biens, accidents et maladie, 100 Yonge St., Suite 400 Automobile and Legal expense. 100, rue Yonge, Bureau 400 automobile et frais juridiques. Toronto, Ontario M5H 1H1 Toronto (Ontario) M5H 1H1 O. Zimmerman, President and Chief O. Zimmerman, Président et chef Executive Officer. de la direction. Scotia Life Insurance Company Life, Accident and sickness. Scotia-Vie compagnie d’assurance Vie, accidents et maladie. Scotia Plaza, 44 King Street West Scotia Plaza, 44, rue King Ouest Toronto, Ontario M5H 1H1 Toronto (Ontario) M5H 1H1 Oscar Zimmerman, President and Oscar Zimmerman, Président et chef Chief Executive Officer. de la direction. Seaboard Life Insurance Company Life, Accident and sickness, Voir-Compagnie d’Assurance-vie Seaboard 2165 Broadway West, P.O. Box 5900 limited to the servicing of Vancouver, British Columbia V6B 5H6 policies issued prior to Robert T. Smith, President and Chief May 31, 1999. Executive Officer. Security Insurance Company of Hartford Property, Accident and sickness, Security Insurance Company of Hartford Biens, accidents et maladie, 155 University Avenue, Suite 702 Automobile and Liability. 155, av. University, Bureau 702 automobile et responsabilité. Toronto, Ontario M5H 3B7 Toronto (Ontario) M5H 3B7 Peter Needra, Chief Agent. Peter Needra, Agent principal. Security National Insurance Company Property, Accident and sickness, Sécurité Nationale Compagnie d’Assurance Biens, accidents et maladie, 50 Place Crémazie, 12th Floor Automobile and Liability. 50, place Crémazie, 12e étage automobile et responsabilité. Montréal, Quebec H2P 1B6 Montréal (Québec) H2P 1B6 Alain Thibault, President and Chief Alain Thibault, Président et chef Operating Officer. de l’exploitation. Sentry Insurance a Mutual Company Property, Aircraft, restricted to the Sentry Insurance a Mutual Company Biens, accidents d’aviation limitée 133 Richmond St. West, Suite 600 servicing of business assumed 133, rue Richmond Ouest, Bureau 600 au maintien des affaires Toronto, Ontario M5H 2L3 from Middlesex Insurance Toronto (Ontario) M5H 2L3 assumées par Middlesex Donald G. Smith, Chief Agent. Company, Automobile, Boiler Donald G. Smith, Agent principal. Insurance Company, automobile, and machinery, Fidelity, Liability chaudières et machines, abus de and Surety. confiance, responsabilité et caution. Skandia Insurance Company Ltd. Property, Aircraft, Automobile, Skandia Société Anonyme d’Assurances Biens, aériennes, automobile, c/o D. M. Williams & Associates Ltd. Boiler and machinery, Fidelity, a/s D. M. Williams & Associates Ltd. chaudières et machines, 3650 Victoria Park Ave., Suite 201 Liability and Surety, limited to 3650, av. Victoria Park, Bureau 201 détournements, responsabilité et North York, Ontario M2H 3P7 the servicing of existingpolicies. North York (Ontario) M2H 3P7 caution, limitée à l’écoulement V. Lorraine Williams, Chief Agent. V. Lorraine Williams, Agent principal. des polices existantes. Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 35

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement See-CUNA Mutual Insurance Society La Société d’Assurance CUNA Mutuelle Vie, accidents et maladie, limitée à 151, chemin North Service la souscription d’assurance des C.P. 5065 membres des coopératives de Burlington (Ontario) L7R 4C2 crédit, et la Compagnie peut T. Michael Porter, Agent principal. utiliser dans les affaires au Canada son nom en anglais « CUNA Mutual Insurance Society »ousonnomenfrançais « La Société d’Assurance CUNA Mutuelle », ou tous deux à la fois. See-Ecclesiastical Insurance Office Public Société des Assurances Écclésiastiques Biens, automobile, chaudières et Limited Company C.P. 2401, Bureau 502, 2300, rue Yonge machines, abus de confiance et Toronto (Ontario) M4P 1E4 responsabilité à la condition que Stephen Malcolm Oxley,Agent principal. si la compagnie utilise un nom français dans les affaires au Canada, ce nom serait « Société des Assurances Écclésiastiques ». See-Employers Insurance of Wausau Société d’assurance mutuelle des Biens, accidents et maladie, a Mutual Company employeurs de Wausau accidents d’aviation, automobile, a/s D. M. Williams & Associates Ltd. chaudières et machines, abus de 3650, av. Victoria Park, Bureau 201 confiance, responsabilité et North York (Ontario) M2H 3P7 caution à la condition que, si la V. Lorraine Williams, Agent principal. compagnie utilise un nom français dans les affaires au Canada, ce nom serait « Société d’assurance mutuelle des employeurs de Wausau ». See-TIG Insurance Company Société d’Assurance TIG Biens, accidents et maladie, a/s Canadian Insurance Consultants Inc. automobile, chaudières et 133, rue Richmond Ouest, Bureau 600 machines, détournements, Toronto (Ontario) M5H 2L3 responsabilité et caution. Donald G. Smith, Agent principal. See-CompCorp Life Insurance Company Société d’assurance vie SIAP Vie, accidents et maladie, dans la 1, rue Queen Est, Bureau 1700 mesure autorisée par son acte Toronto (Ontario) M5C 2X9 constitutif. Gordon M. Dunning, Président et chef de la direction. See-Manulife Financial Corporation. Société Financière Manuvie Vie. 200, rue Bloor Est Toronto (Ontario) M4W 1E5 Dominic D’Alessandro, Président et chef de la direction. Sorema North America Reinsurance Property, Accident and sickness, Sorema North America Reinsurance Biens, accidents et maladie, Company Aircraft, Automobile, Boiler and Company aériennes, automobile, 70 York Street, Suite 1520 machinery, Fidelity,Hail, 70, rue York, Bureau 1520 chaudières et machines, Toronto, Ontario M5J 1S9 Liability and Surety, limited to Toronto (Ontario) M5J 1S9 détournements, grêle, Angus Ross, Chief Agent the business of reinsurance. Angus Ross, Agent principal responsabilité et caution, limitée aux affaires de réassurances. See-Lloyd’s Underwriters. Les Souscripteurs du Lloyd’s Biens, accidents et maladie, 1155, rue Metcalfe, Bureau 1540 aériennes, automobile, Montréal (Québec) H3B 2V6 chaudières et machines, crédit, Mark J. Oppenheim, Agent principal. détournements, grêle, frais juridiques, responsabilité et caution. The Sovereign General Insurance Company Property, Accident and sickness, La Souveraine, Compagnie d’Assurance Biens, accidents et maladie, 855–2nd Avenue S.W., Suite 2200 Aircraft, Automobile, Boiler and Générale accidents d’aviation, automobile, Calgary, Alberta T2P 4J8 machinery, Credit, Fidelity,Hail, 855, 2e Avenue Sud-ouest, Bureau 2200 crédit, chaudières et machines, G. T. Squire, President. Liability and Surety. Calgary (Alberta) T2P 4J8 abus de confiance, grêle, G. T. Squire, Président. responsabilité et caution. 36 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement The Sovereign Life Insurance Company Life, Accident and sickness. La Souveraine, Compagnie d’Assurance-Vie Vie, accidents et maladie. Suite 1200, Bow Valley Square II On December 21, 1992 the Bureau 1200, Bow Valley Square II Le 21 décembre 1992, le 205-5th Avenue S.W. Superintendent of Financial 205, 5e Avenue Sud-ouest surintendant des institutions Calgary, Alberta T2P 4B9 Institutions took control of The Calgary (Alberta) T2P 4B9 financières a pris le contrôle de Robert O. Sanderson, President, Sovereign Life Insurance Robert O. Sanderson, Président, La Souveraine, Compagnie KPMG Inc. Company and the court granted a KPMG Inc. d’Assurance-Vie et la cour Agent for the Superintendent of winding-up order appointing the Mandataire du surintendant des accordait une ordonnance de Financial Institutions, Provisional Superintendent as provisional institutions financières, liquidateur liquidation nommant le Liquidator. liquidator of the company. provisoire. surintendant au titre de KPMG Inc. acting as agent for liquidateur provisoire de la the liquidator, is proceeding with société. Le cabinet KPMG Inc., the winding up of the company’s le mandataire du liquidateur, se affairs. chargedesprocédures de liquidation de la société. St. Paul Fire and Marine Insurance Company Property, Aircraft, Automobile, Voir-La Compagnie d’Assurance Saint Paul 121 King Street West Boiler and machinery, Fidelity, Suite 1200, P.O. Box 93 Liability and Surety, on the Toronto, Ontario M5H 3T9 condition that if in the Wayne McKellar Edmondson, Chief transaction of its business in Agent. Canada, the Company uses a French name, that name shall be “La Compagnie d’Assurance Saint Paul”. The Standard Life Assurance Company Life, Accident and sickness and Voir-Compagnie d’assurance Standard Life 1245 Sherbrooke St. West the Company may use in its Montréal, Quebec H3G 1G3 transaction of its business in Claude A. Garcia, Chief Agent. Canada its name in English “The Standard Life Assurance Company” or its name in French “Compagnie d’assurance Standard Life”, or both such names. The Standard Life Assurance Company Life. Voir-Compagnie d’assurance Standard Life of Canada du Canada 1245 Sherbrooke St. West Montréal, Quebec H3G 1G3 Claude A. Garcia, President and Chief Operating Officer. State Farm Fire and Casualty Company Property, Aircraft, Automobile, State Farm Fire and Casualty Company Biens, aériennes, détournements, 100 Consilium Place, Suite 102 Boiler and machinery, Fidelity, 100, place Consilium, Bureau 102 automobile, caution, chaudières Scarborough, Ontario M1H 3G9 Liability and Surety. Scarborough (Ontario) M1H 3G9 et machines et responsabilité. Robert J. Cooke, Chief Agent. Robert J. Cooke, Agent principal. State Farm Life Insurance Company Life. State Farm Life Insurance Company Vie. 100 Consilium Place, Suite 102 100, place Consilium, Bureau 102 Scarborough, Ontario M1H 3G9 Scarborough (Ontario) M1H 3G9 Robert J. Cooke, Chief Agent. Robert J. Cooke, Agent principal. State Farm Mutual Automobile Insurance Automobile and Personal accident. State Farm Mutual Automobile Insurance Accidents corporels et automobile. Company Company 100 Consilium Place, Suite 102 100, place Consilium, Bureau 102 Scarborough, Ontario M1H 3G9 Scarborough (Ontario) M1H 3G9 Robert J. Cooke, Chief Agent. Robert J. Cooke, Agent principal. Stewart Title Guaranty Company Title. Stewart Title Guaranty Company Titres. c/o Encon Insurance Managers Inc. a/s Encon Insurance Managers Inc. 350 Albert Street, Suite 700 350, rue Albert, Bureau 700 Ottawa, Ontario K1R 1A4 Ottawa (Ontario) K1R 1A4 Denis Shillington, Chief Agent. Denis Shillington, Agent principal. Suecia Reinsurance Company Property, Accident and sickness, Voir-Compagnie de réassurance Suecia 18 King St. East, Suite 1402 Aircraft, Automobile, Boiler and Toronto, Ontario M5C 1C4 machinery, Fidelity,Hail, J. Leo Daly, President. Liability and Surety, limited to the business of reinsurance, and to the servicing of existing policies. See-Swiss Re Life & Health Canada Suisse de Réassurances Vie et Vie, accidents et maladie, limitée Santé Canada. aux affaires de réassurance. 161, rue Bay, Bureau 3000 Canada Trust Tower Toronto (Ontario) M5J 2T6 Ann F. Godbehere, Chef de la direction. Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 37

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement The Sumitomo Marine and Fire Insurance Property, Accident and sickness, The Sumitomo Marine and Fire Insurance Biens, accidents et maladie, Company, Limited Automobile, Boiler and Company, Limited automobile, chaudières et 1 Adelaide Street East machinery, Fidelity, Liability and 1, rue Adelaide Est machines, abus de confiance, Toronto, Ontario M5C 2V9 Surety. Toronto (Ontario) M5C 2V9 responsabilité et caution. Janice M. Tomlinson, Chief Agent. Janice M. Tomlinson, Agent principal. Sun Life Assurance Company of Canada Life, Personal accident and Sun Life du Canada, compagnie Vie, accidents corporels et 150 King St. West Sickness. d’assurance-vie maladie. Toronto, Ontario M5H 1J9 150, rue King Ouest John D. McNeil, Chairman and Toronto (Ontario) M5H 1J9 Chief Executive Officer. John D. McNeil, Président du conseil et chef de la direction. Sun Life Financial Services of Canada Inc. Life. Voir-Financière Sun Life du Canada inc. 150 King St. West Toronto, Ontario M5H 1J9 Donald A. Stewart, Chairman and Chief Executive Officer. Sun Life of Canada Group Assurance Life, Accident and sickness, Sun Life du Canada, compagnie d’assurance Vie, accidents et maladie, limitée à Company limited to the servicing of groupe la gestion des polices émises 225 King Street West policies issued prior to 225, rue King Ouest avant le 1er janvier 1995. Toronto, Ontario M5V 3C5 January 1, 1995. Toronto (Ontario) M5V 3C5 Marcel Gingras, President. Marcel Gingras, Président. Superior Life Insurance Company Life, on the condition that in the Superior Life Insurance Company Vie, pourvu que la société utilise la 6205 Airport Road transaction of its business in 6205, chemin Airport dénomination « Superior Life Suite 100, Building B Canada the company uses the Bureau 100, Édifice B Insurance Company », le nom Mississauga, Ontario L4V 1E1 name “Superior Life Insurance Mississauga (Ontario) L4V 1E1 adopté par Lincoln HeritageLife Lee Mayer, Chief Agent. Company”, the name assumed by Lee Mayer, Agent principal. Insurance Company dans le Lincoln Heritage Life Insurance cadre de l’exercice de son Company to transact business in activité au Canada. Canada. Swiss Re Italia S.p.A. Property, Accident and sickness, Swiss Re Italia S.p.A. Biens, accidents et maladie, 1801 McGill College Avenue, Automobile, Fidelity,Hail, 1801, av. McGill College, Bureau 710 automobile, détournements, Suite 710 Liability and Surety, limited to Montréal (Québec) H3A 3P5 grêle, responsabilité et caution, Montréal, Quebec H3A 3P5 the business of reinsurance. René Lapierre, Agent principal. limitée aux affaires de René Lapierre, Chief Agent. réassurance. Swiss Re Life & Health America Inc. Life, Accident and sickness, Swiss Re Life & Health America Inc. Vie, accidents et maladie, limitée à 161 Bay Street, Suite 3000 limited to the servicing of 161, rue Bay, Bureau 3000 l’administration des contrats de Canada Trust Tower reinsurance contracts. Canada Trust Tower réassurance. Toronto, Ontario M5J 2T6 Toronto (Ontario) M5J 2T6 Ann F. Godbehere, Chief Agent. Ann F. Godbehere, Agent principal. Swiss Re Life & Health Canada Life, Accident and sickness, Voir-Suisse de Réassurances Vie et Santé 161 Bay Street, Suite 3000 limited to the business of Canada. Canada Trust Tower reinsurance. Toronto, Ontario M5J 2T6 Ann F. Godbehere, Chief Executive Officer. Swiss Reinsurance Company Life, Property, Accident and Swiss Reinsurance Company Vie, biens, accidents et maladie, Life Branch sickness, Aircraft, Automobile, Vie accidents d’aviation, automobile, 161 Bay Street, Suite 3000 Boiler and machinery, Credit, 161, rue Bay, Bureau 3000 chaudières et machines, crédit, Canada Trust Tower Fidelity,Hail,Legal expense, Canada Trust Tower abus de confiance, grêle, frais Toronto, Ontario M5J 2T6 Liability and Surety, limited to Toronto (Ontario) M5J 2T6 juridiques, responsabilité et Ann F. Godbehere, Chief Agent. the business of reinsurance. Ann F. Godbehere, Agent principal. caution, limitée aux affaires de Property and Casualty Branch Biens et risques divers réassurance. 150 King Street West 150, rue King Ouest P.O. Box 50, Suite 2200 C. P. 50, Bureau 2200 Toronto, Ontario M5H 1J9 Toronto (Ontario) M5H 1J9 Patrick Mailoux, Chief Agent. Patrick Mailoux, Agent principal. Swiss Reinsurance Company Canada Property, Accident and sickness, Voir-Compagnie Suisse de Réassurance 150 King Street West Aircraft, Automobile, Boiler and Canada. P.O. Box 50, Suite 2200 machinery, Credit, Fidelity,Hail, Toronto, Ontario M5H 1J9 Legal expense, Liability, Patrick Mailoux, President and Chief Mortgage and Surety, limited to Executive Officer. the business of reinsurance. TBD Life Insurance Company Life, Accident and sickness, TBD Compagnie d’Assurance Vie Vie, accidents et maladie, limitée à 200 Bloor Street East limited to the servicing of 200, rue Bloor Est la gestion des polices émises Toronto, Ontario M4W 1E5 policies issued prior to Toronto (Ontario) M4W 1E5 avant le 1er janvier 1995. Peter S. Hutchison, Vice-President and January 1, 1995. Peter S. Hutchison, Vice-président et Chief Financial Officer. chef des services financiers. 38 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement Temple Insurance Company Property, Accident and sickness, Voir-La compagnie d’assurance Temple 390 Bay Street, Suite 2300 Aircraft, Automobile, Boiler and Toronto, Ontario M5H 2Y2 machinery, Credit, Fidelity,Hail, John P. Phelan, President and Legal expense, Liability and Chief Executive Officer. Surety. Terra Nova Insurance Company Limited Property, Accident and sickness, Terra Nova Insurance Company Limited Biens, accidents et maladie, c/o Cassels, Brock & Blackwell Automobile, Boiler and a/s Cassels, Brock & Blackwell automobile, chaudières et Scotia Plaza, Suite 2100 machinery, Fidelity, Liability, Scotia Plaza, Bureau 2100 machines, détournements, 40 King St. West Hail and Surety, limited to the 40, rue King Ouest responsabilité, grêle et caution, Toronto, Ontario M5H 3C2 business of reinsurance. Toronto (Ontario) M5H 3C2 limitée aux affaires de J. Brian Reeve, Chief Agent. J. Brian Reeve, Agent principal. réassurance. TIG Insurance Company Property, Accident and sickness, Voir-Société d’Assurance TIG c/o Canadian Insurance Consultants Inc. Automobile, Boiler and 133 Richmond St. West, Suite 600 machinery, Fidelity, Liability and Toronto, Ontario M5H 2L3 Surety. Donald G. Smith, Chief Agent. The Toa Reinsurance Company of America Property, Accident and sickness, Voir-La Compagnie de réassurance Toa One Queen Street East, Suite 2606, Automobile, Boiler and d’Amérique. Toronto, Ontario M5C 2W5 machinery, Credit, Fidelity,Hail, David E. Wilmot, Chief Agent Liability and Surety, limited to the business of reinsurance, and on the condition that, if in the transaction of its business in Canada, the company uses a French form of name, that name shall be “La Compagnie de réassurance Toa d’Amérique”. The Tokio Marine and Fire Insurance Property, Automobile, Aircraft, The Tokio Marine and Fire Insurance Biens, automobile, aériennes Company, Limited Boiler and machinery, Fidelity, Company, Limited chaudières et machines, 105 Adelaide Street West, 3rd Floor Liability and Surety. 105, rue Adelaide Ouest, 3e étage détournements, responsabilité et Toronto, Ontario M5H 1P9 Toronto (Ontario) M5H 1P9 caution. Byron G. Messier, Chief Agent. Byron G. Messier, Agent principal. Toronto Dominion General Insurance Property, Automobile and Toronto Dominion Compagnie d’Assurance Biens, automobile et Company Liability. Générale responsabilité. P.O. Box 1, Toronto Dominion Centre C.P. 1, Centre Toronto Dominion 55 King Street West, 12th Floor 55, rue King Ouest, 12e étage Toronto, Ontario M5K 1A2 Toronto (Ontario) M5K 1A2 Nick Stitt, President and Chief Nick Stitt, Président et chef Executive Officer. de la direction. Toronto Dominion Life Insurance Company Life, Accident and sickness. Toronto Dominion, Compagnie Vie, accident et maladie. Commercial Union Tower, 28th Floor d’assurance-vie Toronto, Ontario M5K 1A2 Tour Commercial Union, 28e étage H. Dunbar Russel, President and Chief Toronto (Ontario) M5K 1A2 Executive Officer. H. Dunbar Russel, Président et chef de la direction. Toronto Mutual Life Insurance Company Life, Accident and sickness. Toronto Mutual Life Insurance Company Vie, accident et maladie. 112 St. Clair Ave. West 112, av. St. Clair Ouest Toronto, Ontario M4V 2Y3 Toronto (Ontario) M4V 2Y3 Van M. Campbell, President and Chief Van M. Campbell, Président et chef Executive Officer. de la direction. Trade Indemnity P.L.C. Credit, limited to the servicing of Voir-Assurances Trade Indemnity 320 March Road, Suite 103 existingpolicies. Kanata, Ontario K2K 2D3 Ian Douglas Miller, Chief Agent. Traders General Insurance Company Property, Accident and sickness, Voir-Compagnie d’Assurance Traders 2206 Eglinton Ave. East, Suite 500 Aircraft, Automobile, Boiler and Générale Scarborough, Ontario M1L 4S8 machinery, Fidelity,Hail,Legal Mark Webb, Executive Vice President and expense, Liability and Surety. Chief Operating Officer. Trafalgar Insurance Company of Canada Property, Accident and sickness, Voir-Compagnie d’Assurance Trafalgar 10 York Mills Road, Suite 700 Automobile, Boiler and du Canada Toronto, Ontario M2P 2G5 machinery and Liability. Robert E. Maynard, President and Chief Executive Officer. Transamerica Life Insurance Company Life, Accident and sickness. Voir-Compagnie d’Assurance-Vie of Canada Transamerica du Canada 300 Consilium Place Scarborough, Ontario M1H 3G2 GeorgeA.Foegele, President and Chief Executive Officer. Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 39

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement Transatlantic Reinsurance Company Property, Accident and sickness, Transatlantic Reinsurance Company Biens, accidents et maladie, 145 Wellington St. West Aircraft, Automobile, Boiler and 145, rue Wellington Ouest accidents d’aviation, automobile, Toronto, Ontario M5J 1H8 machinery, Fidelity,Hail, Toronto (Ontario) M5J 1H8 chaudières et machines, abus de Gary A. McMillan, Chief Agent. Liability and Surety, limited to Gary A. McMillan, Agent principal. confiance, grêle, responsabilité et the business of reinsurance. caution, limitée aux affaires de réassurances. Transit Insurance Company Property, Automobile and Voir-La Compagnie d’Assurance Transit 5310 Explorer Drive, Suite 201 Liability, limited to the servicing Mississauga, Ontario L4W 5H9 of existingpolicies. William Star, President. Travelers Casualty & Surety Company Property, Aircraft, Automobile, Travelers, Compagnie d’assurance Biens, aériennes, automobile, of Canada Boiler and machinery, Fidelity, dommages et de cautionnement chaudières et machines, 36 Toronto Street, Suite 1070 Liability and Surety. du Canada détournements, responsabilité et Toronto, Ontario M5C 2C5 36, rue Toronto, Bureau 1070 caution. Brian E. Divell, President and Toronto (Ontario) M5C 2C5 Chief Executive Officer. Brian E. Divell, Président et chef de la direction. The Travelers Indemnity Company Property, Accident and sickness, The Travelers Indemnity Company Biens, accidents et maladie, 36 Toronto Street, Suite 1070 Aircraft, Automobile, Boiler and 36, rue Toronto, Bureau 1070 accidents d’aviation, automobile, Toronto, Ontario M5C 2C5 machinery, Fidelity,Hail, Toronto (Ontario) M5C 2C5 chaudières et machines, abus de Brian E. Divell, Chief Agent. Liability and Surety. Brian E. Divell, Agent principal. confiance, grêle, responsabilité et caution. The Travelers Insurance Company Life, Accident and sickness. The Travelers Insurance Company Vie, accidents et maladie. 1145 Nicholson Road, Unit 2 1145, chemin Nicholson, Unité 2 Newmarket, Ontario L3Y 7V1 Newmarket (Ontario) L3Y 7V1 Colleen Sexsmith, Chief Agent. Colleen Sexsmith, Agent principal. UAP-NewRotterdam Insurance Property, Automobile, Fidelity, UAP-NewRotterdam Insurance Biens, automobile, détournements, Company N.V. Hail, Liability and Surety, Company N.V. grêle, responsabilité et caution, 649 North Service Road West limited to the servicing of 649, chemin North Service Ouest limitée à l’écoulement des Burlington, Ontario L7R 4L5 existingpolicies. Burlington (Ontario) L7R 4L5 polices existantes. John Conway Stradwick, Chief Agent. John Conway Stradwick, Agent principal. Underwriters Insurance Company Property, Aircraft, Automobile, Underwriters Insurance Company Biens, accidents d’aviation, c/o Fasken Campbell Godfrey Boiler and machinery, Fidelity, a/s Fasken Campbell Godfrey automobile, chaudières et Toronto-Dominion Centre Liability and Surety. Toronto-Dominion Centre, C.P. 20 machines, abus de confiance, P.O. Box 20 Toronto (Ontario) M5K 1N6 responsabilité et caution. Toronto, Ontario M5K 1N6 Robert W. McDowell, Agent principal. Robert W. McDowell, Chief Agent. Unifund Assurance Company Property, Accident and sickness, Unifund, Compagnie d’Assurance Biens, accidents et maladie, 95 Elizabeth Ave. Automobile and Liability. 95, av. Elizabeth automobile et responsabilité. St. John’s, Newfoundland A1B 1R7 St. John’s (Terre-Neuve) A1B 1R7 Paul Johnson, Chief Executive Officer. Paul Johnson, Administrateur principal. Unigard Security Insurance Company Property, Accident and sickness, Unigard Security Insurance Company Biens, accidents et maladie, c/o Price Waterhouse & Company Aircraft, Automobile, Boiler and a/s Price Waterhouse & Company accidents d’aviation, automobile, 601 West HastingsSt. machinery, Fidelity, Liability and 601, rue West Hastings chaudières et machines, abus de Vancouver, British Columbia V6B 5A5 Surety, limited to the servicing of Vancouver (Colombie-Britannique) confiance, responsabilité et John D. Sapinsky, Chief Agent. existingpolicies. V6B 5A5 caution, limitée à John D. Sapinsky,Agent principal. l’administration des polices existantes. Union Fidelity Life Insurance Company Life, Accident and sickness, Voir-Compagnie d’Assurance-Vie Union 200 Wellington St. West limited to the servicing of Fidelity P.O. Box 166, Suite 400 policies issued prior to Toronto, Ontario M5V 3C7 January 1, 1999. Alan K. Ryder, Chief Agent. United American Insurance Company Life, Personal accident and United American Insurance Company Vie, accidents corporels et 145 King St. West Sickness. 145, rue King Ouest maladie. Toronto, Ontario M5H 3X6 Toronto (Ontario) M5H 3X6 Connie Vaccaro, Chief Agent. Connie Vaccaro, Agent principal. United States Fidelity and Guaranty Property, Accident and sickness, United States Fidelity and Guaranty Biens, accidents et maladie, Company Aircraft, Automobile, Boiler and Company accidents d’aviation automobile, c/o John Milnes & Associates machinery, Fidelity,Hail, a/s John Milnes & Associates chaudières et machines, abus de 68 Scollard St., 2nd Floor Liability and Surety, limited to 68, rue Scollard, 2e étage confiance, grêle, responsabilité et Toronto, Ontario M5R 1G2 the servicing of existingpolicies. Toronto (Ontario) M5R 1G2 caution, limitée à John Milnes, Chief Agent. John Milnes, Agent principal. l’administration des polices existantes. 40 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement UNUM Life Insurance Company of America Life, Accident and sickness, on the L’UNUM d’Amérique, Compagnie Vie, accidents et maladie, à la 5420 North Service Road condition that if in the d’Assurance-vie condition que lorsque la P.O. Box 5044 transaction of its business in 5420, chemin North Service compagnie utilise un nom Burlington, Ontario L7R 4C1 Canada the Company uses a C.P. 5044 français dans l’exercice de ses George A. Shell, Chief Agent. French name, that name shall be Burlington (Ontario) L7R 4C1 activités au Canada, ce nom soit “L’UNUM d’Amérique, George A. Shell, Agent principal. « L’UNUM d’Amérique, Compagnie d’Assurance-vie”. Compagnie d’Assurance-vie ». Utica Mutual Insurance Company Property, Automobile, Boiler and Utica Mutual Insurance Company Biens, automobile, chaudières et c/o CAS Accounting for Insurance Inc. machinery, Fidelity and Liability. a/s CAS Accounting for Insurance Inc. machines, abus de confiance et Unit 2, 1145 Nicholson Road 1145, chemin Nicholson, Unité 2 responsabilité. Newmarket, Ontario L3Y 7V1 Newmarket (Ontario) L3Y 7V1 Colleen Anne Sexsmith, Chief Agent. Colleen Anne Sexsmith, Agent principal. Virginia Surety Company,Inc. Property, Automobile, Boiler and Voir-Compagnie de sûreté Virginia Inc. 7300 Warden Avenue, Suite 300 machinery and Liability Markham, Ontario L3R 0X3 insurance, on the condition that Dan C. Evans, Chief Agent. if in the transaction of its business in Canada the company uses a French form of name, that name shall be “Compagnie de sûreté Virginia Inc.”. Voyageur Insurance Company Property, Accident and sickness. Voir-Compagnie d’Assurance Voyageur 44 Peel Centre Dr., Suite 300 Brampton, Ontario L6T 4M8 Walter Schutte, President and Chief Operating Officer. Waterloo Insurance Company Property, Aircraft, Automobile, Waterloo, Compagnie d’Assurance Biens, aériennes, automobile, 111 Westmount Rd. South, P.O. Box 2000 Boiler and machinery, Fidelity, 111, chemin Westmount Sud chaudières et machines, Waterloo, Ontario N2J 4S4 Liability and Surety. C.P. 2000, Waterloo (Ontario) N2J 4S4 détournements, responsabilité et Noel G. Walpole, President and Chief Noel G. Walpole, Président et chef caution. Executive Officer. de la direction. The Wawanesa Mutual Insurance Company Property, Automobile, Boiler and The Wawanesa Mutual Insurance Company Biens, automobile, chaudières et 191 Broadway machinery, Fidelity,Hail, 191, Broadway machines, abus de confiance, Winnipeg, Manitoba R3C 3P1 Liability and Surety. Winnipeg (Manitoba) R3C 3P1 grêle, responsabilité et caution. G. J. Hanson, President and Chief G. J. Hanson, Président et chef Executive Officer. de la direction. The Wawanesa Life Insurance Company Life, Accident and sickness. Voir-La Compagnie d’Assurance-vie 191 Broadway Wawanesa Winnipeg, Manitoba R3C 3P1 G. J. Hanson, President and Chief Executive Officer. Wellington Insurance Company Property, Accident and sickness, Voir-Compagnie d’Assurance Wellington One Concord Gate Aircraft, Automobile, Boiler and Don Mills, Ontario M3C 3N6 machinery, Fidelity, Hail, Loss of Yves Brouillette, President and Chief employment, Liability and Executive Officer. Surety. Westbury Canadian Life Insurance Company Life, Accident and sickness. Westbury Canadienne, Compagnie Vie, accidents et maladie. P.O. Box 2918, 21 King St. West d’Assurance-Vie Hamilton, Ontario L8N 3R5 C.P. 2918, 21, rue King Ouest W. Grant Hardy, President and Hamilton (Ontario) L8N 3R5 Chief Executive Officer. W. Grant Hardy, Président et chef de la direction. Western Assurance Company Property, Accident and sickness, Western Assurance Company Biens, accidents et maladie, 10 Wellington St. East Aircraft, Automobile, Boiler and 10, rue Wellington Est accidents d’aviation, automobile, Toronto, Ontario M5E 1L5 machinery, Fidelity,Hail, Toronto (Ontario) M5E 1L5 chaudières et machines, abus de Robert John Gunn, President. Liability and Surety. Robert John Gunn, Président. confiance, grêle, responsabilité et caution. The Western Life Assurance Company Life, Accident and sickness limited Western Compagnie d’Assurance-Vie Vie, accidents et maladie limitée 112 St. Clair Ave. West to the servicing of policies issued 112, av. St. Clair Ouest au service des polices délivrées Toronto, Ontario M4V 2Y3 prior to January 31, 1975. Toronto (Ontario) M4V 2Y3 avant le 31 janvier 1975. Van M. Campbell, President and Chief Van M. Campbell, Président et chef Executive Officer. de la direction. Western Surety Company Fidelity and Surety. Voir-La Compagnie de Sûreté de l’Ouest P.O. Box 527, 1874 Scarth Street 20th Floor Regina, Saskatchewan S4P 2G8 L. C. Ell, President. Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 41

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement Winterthur Life Insurance Company Life, limited to the servicing of Winterthur Société d’Assurance sur la Vie Vie, limitée à l’administration des 1075 Bay St. reinsurance contracts entered 1075, rue Bay contrats de réassurance conclus Toronto, Ontario M5S 2W5 into prior to January 15, 1996, on Toronto (Ontario) M5S 2W5 avant le 15 janvier 1996, à la Ernst Notz, Chief Agent. the condition that if in the Ernst Notz, Agent principal. condition que si la compagnie transaction of its business in utilise un nom anglais dans les Canada the company uses an affaires au Canada, ce nom serait anglicized name, that name shall « Winterthur Life Insurance be “Winterthur Life Insurance Company ». Company”. The Yasuda Fire and Marine Insurance Property, Automobile, Boiler and The Yasuda Fire and Marine Insurance Biens, automobile, chaudières et Company, Limited machinery, Fidelity, Liability and Company, Limited machines, détournements, Exchange Tower, 2 First Canadian Place Surety. 2 First Canadian Place responsabilité et caution. 12th Floor, P.O. Box 185 Exchange Tower, C.P. 185, 12e étage Toronto, Ontario M5X 1A8 Toronto (Ontario) M5X 1A8 Cynthia Santiago, Chief Agent. Cynthia Santiago, Agent principal. Zenith Insurance Company Property, Automobile, and Voir-Compagnie d’assurance Zenith c/o Lombard Canada Ltd. Liability. 105 Adelaide Street West Toronto, Ontario M5H 1P9 Byron G. Messier, President and Chief Executive Officer. Zurich Insurance Company Property, Accident and sickness, Zurich Compagnie d’Assurances Biens, accidents et maladie, (Zurich Versicherungs-Gesellschaft) Aircraft, Automobile, Boiler and (« Zurich » Versicherungs-Gesellschaft) aériennes, automobile, 400 University Ave. machinery, Fidelity, Liability and 400, av. University détournements, caution, Toronto, Ontario M5G 1S7 Surety, and the company may Toronto (Ontario) M5G 1S7 chaudières et machines et Barry Gilway, Chief Agent. use in the transacting of its Barry Gilway,Agent principal. responsabilité, et la compagnie business in Canada its name in peut utiliser dans les affaires au English “Zurich Insurance Canada son nom en anglais Company” or its name in French « Zurich Insurance Company » “Zurich Compagnie ou son nom en français « Zurich d’Assurances”. Compagnie d’Assurances ». Zurich Life Insurance Company of Canada Life, Accident and sickness. Zurich du Canada compagnie Vie, accidents et maladie. 400 University Ave., Suite 2500 d’assurance-vie Toronto, Ontario M5G 1S7 400, av. University, Bureau 2500 Barry J. Gilway, President and Toronto (Ontario) M5G 1S7 Chief Executive Officer. Barry J. Gilway, Président et chef de la direction.

ACA ASSURANCE Life, Accident and sickness, to the ACA ASSURANCE Vie, accident et maladie dans la 898 Sainte-Julie St. extent authorized by its Articles 898, rue Sainte-Julie mesure autorisée par sa loi Trois-Rivières, Quebec G9A 1Y2 of incorporation, Constitution Trois-Rivières (Québec) G9A 1Y2 constitutive, sa constitution et Diane Lachance, Chief Agent. and Laws. Diane Lachance, Agent principal. ses règlements. ACTRA Fraternal Benefit Society Life, Accident and sickness to the Voir-La Société Fraternelle ACTRA 1000 YongeSt. extent authorized by its Toronto, Ontario M4W 2K2 instrument of incorporation and Robert M. Underwood, President and by-laws. Chief Executive Officer. See-Sons of Scotland Benevolent Association Bénévole des Fils de l’Écosse Vie et maladie dans la mesure Association 90, av. Eglinton Est, 7e étage autorisée par sa loi constitutive, Toronto (Ontario) M4P 2Y3 sa constitution et ses règlements. Mme Effie MacFie, Grand secrétaire- trésorière. Canadian Professional Sales Association Life insurance to the extent L’Association Canadienne des Vie dans la mesure autorisée par sa 145 Wellington Street West, Suite 310 authorized by its Act of professionnels de la vente loi constitutive, sa constitution et Toronto, Ontario M5J 1H8 incorporation, Constitution and 145, rue Wellington Ouest, Bureau 310 ses règlements. T. J. Ruffell, President. Laws. Toronto (Ontario) M5J 1H8 T. J. Ruffell, Président. Canadian Slovak Benefit Society Life, Personal accident and Voir-Société de Secours Mutuels des 55 Barron Street Sickness to the extent authorized Slovaques du Canada Welland, Ontario L3C 2K4 by its Act of incorporation, Joseph Mamros, Secretary. Constitution and Laws. Canadian Slovak League Life to the extent authorized by its Canadian Slovak League Vie dans la mesure autorisée par sa 1736 Dundas St. West Act of incorporation, 1736, rue Dundas Ouest loi constitutive, sa constitution et Toronto, Ontario M6K 1V5 Constitution and Laws. Toronto (Ontario) M6K 1V5 ses règlements. Branislav Galat, Secretary. Branislav Galat, Secrétaire. Croatian Catholic Union of U.S.A. Life, Accident and sickness to the Croatian Catholic Union of U.S.A. Vie, accidents et maladie dans la and Canada extent authorized by its Articles and Canada mesure autorisée par sa loi 3009 Dundas Street West of incorporation, Constitution 3009, rue Dundas Ouest constitutive, sa constitution et Toronto, Ontario M6P 1Z4 and By-Laws. Toronto (Ontario) M6P 1Z4 ses règlements. Ante M. Nikolic, Chief Agent. Ante M. Nikolic, Agent principal. 42 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement Croatian Fraternal Union of America Life, Accident and sickness to the Croatian Fraternal Union of America Vie, accidents et maladie dans la c/o Deloitte and Touche extent authorized by its Articles a/s Deloitte & Touche mesure autorisée par sa loi 181 Bay Street, Suite 1400 of incorporation, Constitution 181, rue Bay, Bureau 1400 constitutive, sa constitution et Toronto, Ontario M5J 2V1 and Laws. Toronto (Ontario) M5J 2V1 ses règlements. P. Wayne Musselman, Chief Agent. P. Wayne Musselman, Agent principal. The First Catholic Slovak Ladies Life insurance to the extent The First Catholic Slovak Ladies Vie dans la mesure autorisée par sa Association of the United States authorized by its Articles of Association of the United States loi constitutive, sa constitution et of America incorporation, Constitution and of America ses règlements, limitée à la c/o John Milnes and Associates By-Laws, limited to the servicing a/s John Milnes and Associates gestion des polices émises avant 68 Scollard St., 2nd Floor of policies issued prior to 68, rue Scollard, 2e étage le 1er janvier 1999. Toronto, Ontario M5R 1G2 January 1, 1999. Toronto (Ontario) M5R 1G2 John R. Milnes, Chief Agent. John R. Milnes, Agent principal. The First Catholic Slovak Union of the Life insurance to the extent The First Catholic Slovak Union of the Vie dans la mesure autorisée par sa United States of America and Canada authorized by its Articles of United States of America and Canada loi constitutive, sa constitution et c/o John Milnes and Associates incorporation, Constitution and a/s John Milnes and Associates ses règlements. 68 Scollard St., 2nd Floor Laws. 68, rue Scollard, 2e étage Toronto, Ontario M5R 1G2 Toronto (Ontario) M5R 1G2 John R. Milnes, Chief Agent. John R. Milnes, Agent principal. The Grand OrangeLodge of British America Life and Sickness to the extent The Grand OrangeLodge of British America Vie et maladie dans la mesure 94 Sheppard Ave. West authorized by its Act of 94, av. Sheppard Ouest autorisée par sa loi constitutive, Willowdale, Ontario M2N 1M5 incorporation, Constitution and Willowdale (Ontario) M2N 1M5 sa constitution et ses règlements. D. A. Griffin, Secretary-Treasurer. Laws. D. A. Griffin, Secrétaire-trésorier. The Independent Order of Foresters Life, Accident and sickness to the Voir-L’Ordre Indépendant des Forestiers 789 Don Mills Rd. extent authorized by its Don Mills, Ontario M3C 1T9 instrument of incorporation, William J. Valiquette, Senior Vice- Constitution and Laws. President - Corporate Governance. Knights of Columbus Life insurance to the extent Knights of Columbus Vie dans la mesure autorisée par sa 257 Pinnacle Street authorized by its Act of 257, rue Pinnacle loi constitutive, sa constitution et Belleville, Ontario K8N 3B2 incorporation, Constitution and Belleville (Ontario) K8N 3B2 ses règlements. Kerry J. Soden, Chief Agent. Laws. Kerry J. Soden, Agent principal. Lutheran Life Insurance Society of Canada Life, Accident and sickness to the Lutheran Life Insurance Society of Canada Vie, accidents et maladie dans la 470 Weber St. North extent authorized by its 470, rue Weber Nord mesure autorisée par son acte de Waterloo, Ontario N2J 4G4 instrument of incorporation and Waterloo (Ontario) N2J 4G4 constitution en corporationetses James R. Widdecombe, Secretary. by-laws. James R. Widdecombe, Secrétaire. règlements. The North West Commercial Travellers’ Life insurance to the extent The North West Commercial Travellers’ Vie dans la mesure autorisée par sa Association of Canada authorized by its Act of Association of Canada loi constitutive, sa constitution et 28 Main Street South, 2nd Floor incorporation, Constitution and 28, rue Main Sud, 2e étage, C.P. 336 ses règlements. P.O. Box 336 Laws. Winnipeg (Manitoba) R3C 2H6 Winnipeg, Manitoba R3C 2H6 Terry D. Carruthers, Directeur général Terry D. Carruthers, General Manager et secrétaire. and Secretary. The Order of Italo-Canadians Life and Sickness to the extent The Order of Italo-Canadians Vie et maladie dans la mesure 5613 Arthur Chevrier St. authorized by its Act of 5613, rue Arthur Chevrier autorisée par sa loi constitutive, Montréal North, Quebec H1G 1P7 incorporation, Constitution and Montréal-Nord (Québec) H1G 1P7 sa constitution et ses règlements. L. A. Bortolotti, Director. Laws. L. A. Bortolotti, Administrateur. The Order of United Commercial Travelers Life, Accident and sickness The Order of United Commercial Travelers Vie, accidents et maladie dans la of America insurance to the extent of America mesure autorisée par sa loi 901 Centre St. North, Room 300 authorized by its Articles of 901, rue Centre Nord, Pièce 300 constitutive, sa constitution et Calgary, Alberta T2E 2P6 Incorporation, constitution and Calgary (Alberta) T2E 2P6 ses règlements. Lindsay B. Maxwell, Chief Agent. by-laws. Lindsay B. Maxwell, Agent principal. See-The Independent Order of Foresters L’Ordre Indépendant des Forestiers Vie, accidents et maladie dans la 789, chemin Don Mills mesure autorisée par son acte de Don Mills (Ontario) M3C 1T9 constitution en corporation, sa William J. Valiquette, Vice-président constitution et ses règlements. principal, Régie d’entreprise. Serb National Federation Life, Accident and Sickness to the Serb National Federation Vie, accidents et maladie dans la c/o John Milnes and Associates extent authorized by its Articles a/s John Milnes and Associates mesure autorisée par sa loi 68 Scollard St., 2nd Floor of incorporation, Constitution 68, rue Scollard, 2e étage constitutive, sa constitution et Toronto, Ontario M5R 1G2 and Laws, and is limited to the Toronto (Ontario) M5R 1G2 ses règlements, et limitée à la John R. Milnes, Chief Agent. servicing of policies issued prior John R. Milnes, Agent principal. gestion des polices émises avant to July 15, 1998. le 15 juillet 1998. See-ACTRA Fraternal Benefit Society La Société Fraternelle ACTRA Vie, accidents et maladie dans la 1000, rue Yonge mesure autorisée par son acte de Toronto (Ontario) M4W 2K2 constitution et ses règlements. Robert M. Underwood, Président et chef de la direction. Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 43

Name, Address and Official Representative Classes of Insurance for which Nom, adresse et mandataire officiel Catégories d’assurance prévues à of the Company in Canada Registered de la société au Canada l’enregistrement See-Canadian Slovak Benefit Society Société de Secours Mutuels des Slovaques Vie, accidents corporels et maladie du Canada dans la mesure autorisée par sa 55, rue Barron loi constitutive, sa constitution et Welland (Ontario) L3C 2K4 ses règlements. Joseph Mamros, Secrétaire. Sons of Norway Life, Disability and Sickness to the Sons of Norway Vie, invalidité et maladie dans la c/o Deloitte & Touche extent authorized by its Articles a/s Deloitte & Touche mesure autorisée par sa loi 2500 Scotia Centre of incorporation, Constitution 2500 Scotia Centre constitutive, sa constitution et 700-2nd Street S.W. and Laws. 700, 2e Rue Sud-ouest ses règlements. Calgary, Alberta T2P 0S7 Calgary (Alberta) T2P 0S7 R. Ross Nelson, Chief Agent. R. Ross Nelson, Agent principal. Sons of Scotland Benevolent Association Life and Sickness to the extent Voir-Association Bénévole des Fils 90 Eglinton Ave. East, 7th Floor authorized by its Act of de l’Écosse Toronto, Ontario M4P 2Y3 incorporation, Constitution and Mrs. Effie MacFie, Grand Secretary- Laws. Treasurer. Supreme Council of the Royal Arcanum Life, Personal accident and Supreme Council of the Royal Arcanum Vie, accidents corporels et maladie 1030 Standard Life Bldg. Sickness to the extent authorized 1030 Standard Life Building dans la mesure autorisée par sa 120 King St. West, P.O. Box 990 by its Certificate of 120, rue King Ouest, C.P. 990 loi constitutive, sa constitution et Hamilton, Ontario L8N 3R1 incorporation. Constitution and Hamilton (Ontario) L8N 3R1 ses règlements. J. B. Simpson, Chief Agent. By-Laws. J. B. Simpson, Agent principal. Ukrainian Fraternal Association Life, to the extent authorized by its Ukrainian Fraternal Association Vie, dans la mesure autorisée par (of America) Articles of Association, (of America) sa loi constitutive, sa constitution 2800-14th Avenue, Suite 406 constitution and laws, and on the 2800, 14e Avenue, Bureau 406 et ses règlements, et à la Markham, Ontario L3R 0E4 condition that the words “of Markham (Ontario) L3R 0E4 condition que les mots « of Bohdan M. Mocherniak, Chief Agent. America” will be used in Bohdan M. Mocherniak, Agent principal. America » figurent bien conspicuous relation to the name visiblement près du nom “Ukrainian Fraternal « Ukrainian Fraternal Association” wherever it appears Association » partout où paraît le in the Association’s contracts, nom de l’Association dans les application forms, contrats, les formules de advertisements or other demande de police, la publicité published material used in ou les autres documents Canada. imprimés utilisés au Canada. Ukrainian Fraternal Society of Canada Life, Personal accident and Ukrainian Fraternal Society of Canada Vie, accidents corporels et maladie 235 McGregor St. Sickness to the extent authorized 235, rue McGregor dans la mesure autorisée par sa Winnipeg, Manitoba R2W 4W5 by its Act of incorporation and Winnipeg (Manitoba) R2W 4W5 loi constitutive et ses règlements M. J. Bugera, President. by-laws and by The Canadian M. J. Bugera, Président. et par la loi sur les compagnies and British Insurance Companies d’assurance canadiennes et Act, 1932. britanniques 1932. Ukrainian Mutual Benefit Association of Life, Disability and Sickness to the Ukrainian Mutual Benefit Association of Vie, invalidité et maladie dans la Saint Nicholas of Canada extent authorized by its Act of Saint Nicholas of Canada mesure autorisée par sa loi 804 Selkirk Ave. incorporation, Constitution and 804, av. Selkirk constitutive, sa constitution et Winnipeg, Manitoba R2W 2N6 Laws. Winnipeg (Manitoba) R2W 2N6 ses règlements. Gene Hazen, Manager. Gene Hazen, Directeur. Ukrainian National Aid Association Life insurance to the extent Ukrainian National Aid Association Vie dans la mesure autorisée par sa of America authorized by its charter, of America charte, sa constitution et ses 83 Christie Street Constitution and By-laws. The 83, rue Christie règlements. La société étrangère Toronto, Ontario M6G 3B1 foreigncompany is limited to the Toronto (Ontario) M6G 3B1 est limitée à la gestion des Irene Mycak, Chief Agent. servicing of policies issued prior Irene Mycak, Agent principal. polices émises avant le to May 25, 1999. 25 mai 1999. Ukrainian National Association Life, Personal accident and Ukrainian National Association Vie, accidents corporels et maladie 2800-14th Avenue, Suite 406 Sickness to the extent authorized 2800, 14e Avenue, Bureau 406 dans la mesure autorisée par sa Markham, Ontario L3R 0E4 by its Certificate of Markham (Ontario) L3R 0E4 loi constitutive, sa constitution et Bohdan M. Mochernial, Chief Agent. incorporation, Constitution and Bohdan M. Mochernial, Agent principal. ses règlements. By-laws. Woman’s Life Insurance Society Life insurance to the extent Woman’s Life Insurance Society Vie dans la mesure autorisée par sa 1455 Lakeshore Road, P.O. Box 234 authorized by its Articles of 1455, chemin Lakeshore, C.P. 234 loi constitutive et ses règlements. Sarnia, Ontario N7T 7H9 Incorporation and Laws. Sarnia (Ontario) N7T 7H9 Joseph Haselmayer, Chief Agent. Joseph Haselmayer, Agent principal. Workers Benevolent Association of Canada Life, Accident and sickness to the Workers Benevolent Association of Canada Vie, accidents et maladie dans la 595 Pritchard Ave. extent authorized by its Act of 595, av. Pritchard mesure autorisée par sa loi et ses Winnipeg, Manitoba R2W 2K4 incorporation and By-Laws. Winnipeg (Manitoba) R2W 2K4 règlements. Zenovy H. Nykolyshyn, National Zenovy H. Nykolyshyn, Président President. national. 44 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

NOTE (A)— REMARQUE (A)— Abbey Life Insurance Company of Canada changed its name to ITT Hartford Life L’AbbayeCompagnie d’Assurance-Vie du Canada a modifié sa dénomination Insurance Company of Canada effective July 1, 1994. sociale à celle de ITT Hartford du Canada, Compagnie d’Assurance-Vie à compter du 1er juillet 1994. Abeille Réassurances amalgamated its property and business with that of AXA Abeille Réassurances a fusionné ses biens et son entreprise avec ceux de AXA Réassurance effective April 18, 1996, the continuing or combined company Réassurance depuis le 18 avril 1996, la compagnie issue de la fusion étant AXA being AXA Réassurance. Réassurance. Adriatic Insurance Company of Canada amalgamated its property and business Advocat Général Compagnie d’Assurance du Canada: Un décret a été émis le with that of Canadian Home Assurance Company effective January 1, 1991, the 5 juillet 1989 en vertu de la Loi sur les liquidations. continuing or combined company being Canadian Home Assurance Company. Advocate General Insurance Company’s certificate of registry was withdrawn The Ætna Casualty and Surety Company: les obligations de la compagnie ayant effective July 15, 1989, and the company is being wound up under the été transférées à Aetna, compagnie d’assurance dommages et de cautionnement provisions of the Winding-up Act. du Canada, la compagnie a cessé d’être enregistrée à compter du 1er mars 1993. The Ætna Casualty and Surety Company,having transferred its Canadian Ætna Casualty du Canada, Compagnie d’Assurance a changé son nom en celui de liabilities to Aetna Casualty & Surety Company of Canada, ceased to be Laurentienne Compagnie d’Assurance de Dommages du Canada à compter du registered effective March 1, 1993. 1er novembre 1987. Aetna Casualty & Surety Company of Canada changed its name to Travelers Aetna, compagnie d’assurance dommages et de cautionnement du Canada a Casualty and Surety Company of Canada, effective July 1, 1997. modifié sa dénomination sociale à celle de Travelers, Compagnie d’assurance dommages et de cautionnement du Canada à compter du 1er juillet 1997. Ætna Casualty Company of Canada changed its name to Laurentian Casualty Aetna, Compagnie d’Assurance-Vie du Canada et La Maritime Compagnie Company of Canada effective November 1, 1987. d’Assurance-vie ont été fusionnées et prorogées en une société fonctionnant sous la dénomination sociale La Maritime Compagnie d’Assurance-vie à compter du 1er janvier 2000. Ætna Insurance Company changed its name to CIGNA Property and Casualty Ætna Insurance Company achangé son nom en celui de CIGNA Property and Insurance Company effective April 29, 1988. Casualty Insurance Company àcompter du 29 avril 1988. Aetna Life Insurance Company of Canada and the Maritime Life Assurance Com- A.G.F. Réassurances, ayant fusionné ses biens et affaires avec les biens et affaires pany amalgamated and were continued as one company under the name of The de la Société Anonyme Française de Réassurances en vertu des lois de la Maritime Life Assurance Company effective January 1, 2000. France, la compagnie a cessé d’être enregistrée à compter du 31 décembre 1991. A.G.F. Réassurances, having amalgamated its property and business with that of Aktieselskabet Nordisk Gjenforsikrings Selskab a changé son nom en celui de Société Anonyme Française de Réassurances pursuant to the laws of France, Baltica-Nordisk Reinsurance Company A/S à compter du 8 décembre 1986. ceased to be registered effective December 31, 1991. Aktieselskabet Nordisk Gjenforsikrings Selskab changed its name to Allendale Mututal Insurance Company a modifié sa dénomination sociale à celle Baltica-Nordisk Reinsurance Company A/S effective December 8, 1986. de Factory Mutual Insurance Company àcompter du 1er juillet 1999, la date de la fusion de Allendale Mututal Insurance Company, Arkwright Mututal Insurance Company et Protection Mututal Insurance Company, en vertu des lois des États-Unis d’Amérique. The Albion Insurance Company of Canada changed its name to Metropolitan Allianz Insurance Company : les obligations de la compagnie ayant été transférées General Insurance Company effective February 16, 1988. àlaCompagnie d’Assurance du Home Canadien, la compagnie a cessé d’être enregistrée à compter du 31 mars 1991. Allendale Mutual Insurance Company changed its name to Factory Mutual American Credit Indemnity Company of New York a changé son nom en celui de Insurance Company effective July 1, 1999, the date of the amalgamation of American Credit Indemnity Company àcompter du 17 avril 1985. Allendale Mutual Insurance Company, Arkwright Mutual Insurance Company, and Protection Mutual Insurance Companypursuant to the laws of the United States of America. Allianz Insurance Company,having transferred its Canadian liabilities to American Credit Indemnity Company a modifié sa dénomination sociale à celle de Canadian Home Assurance Company, ceased to be registered effective EULER American Credit Indemnity Company àcompter du 4 octobre 1999. March 31, 1991. Allianz Insurance Company of Canada amalgamated its property and business American Health and Life Insurance Company a cessé d’exercer des opérations au with that of Cornhill Insurance Company of Canada effective November 1, Canada. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le 1993, the continuing or combined company being Allianz Insurance Company 21 décembre 1993. of Canada. American Credit Indemnity Company of New York changed its name to American The American Insurance Company a cessé d’exercer des opérations au Canada le Credit Indemnity Company effective April 17, 1985. 31 décembre 1982; son passif canadien a été prisencharge par Fireman’s Fund Insurance Company. American Credit Indemnity Company changed its name to EULER American L’American Insurance Company a obtenu un nouveau certificat d’enregistrement Credit Indemnity Company effective October 4, 1999. lui permettant de souscrire des polices d’assurance au Canada à compter du 8 janvier 1990. American Health and Life Insurance Company ceased transacting business in The American Insurance Company a cessé d’exercer des opérations au Canada. Canada. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effective L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le 19 mars December 21, 1993. 1997. The American Insurance Company,having transferred its Canadian liabilities to American Mutual Liability Insurance Company : le certificat d’enregistrement de Fireman’s Fund Insurance Company, ceased to be registered effective la compagnie a été retiré le 30 mai 1989 et la compagnie sera liquidée en vertu December 31, 1982. des dispositions de la Loi sur les liquidations. Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 45

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite) The American Insurance Company was re-registered to transact the business of American Reserve Insurance Company le certificat d’enregistrement a été retiré le insurance in Canada effective January 8, 1990. 19 juin 1979 et la compagnie est maintenant en voie de liquidation en vertu des dispositions de la Loi sur les liquidations.Le9juillet 1984, avec l’approbation de la Cour suprême de l’Ontario, le passif canadien de la compagnie a été pris en charge par INA du Canada Compagnie d’assurance. The American Insurance Company ceased transacting business in Canada. The AMEX Life Assurance Company a cessé d’exercer des opérations au Canada. company’s order to insure in Canada risks was revoked effective L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le March 19,1997. 10 octobre 1997. American International Assurance Life Company Ltd. changed its name to AIG Ancienne Mutuelle Réassurance a adopté une nouvelle raison sociale, Axa Ré, le Life Insurance Company of Canada effective April 1, 1998. 26 mars 1990. American Life Insurance Company ceased transacting business in Canada and L’Ancienne République, Compagnie d’Assurance : Conformément à la demande transferred its remaining Canadian policies to American International de la société, l’ordonnance portant garantie des risques au Canada par Assurance Life Company Ltd. The company’s order to insure in Canada risks L’Ancienne République, Compagnie d’Assurance a été annulée le 22 décembre was revoked effective December 31, 1996. 1995. American Mutual Liability Insurance Company’s certificate of registry was L’Ancienne République, Compagnie d’Assurance-Vie a cessé d’exercer des withdrawn effective May 30, 1989, and the company is being wound up under opérations au Canada. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a the provisions of the Winding-up Act. été annulée le 1er septembre 1993. American Reserve Insurance Company’s certificate of registry was withdrawn Argonaut Insurance Company : Conformément à la demande de la compagnie, effective June 19, 1979, and the company is being wound up under the l’ordonnance portant garantie des risques au Canada par Argonaut Insurance provisions of the Winding-up Act.TheSupreme Court of Ontario approved the Company a été annulée le 23 novembre 1993. transfer of the company’s remaining Canadian liabilities to INA Insurance Company of Canada effective July 9, 1984. AMEX Life Assurance Company ceased transacting business in Canada. The Arkwright-Boston Manufacturers Mutual Insurance Company a fusionné ses biens company’s order to insure in Canada risks was revoked effective October 10, et opérations avec les biens et opérations de Philadelphia Manufacturers Mutual 1997. Insurance Company le 7 septembre 1984; la compagnie fusionnée ou la compagnie prenant suite des opérations est Arkwright-Boston Manufacturers Mutual Insurance Company. Ancienne Mutuelle Réassurance changed its name to Axa Ré effective March 26, Arkwright-Boston Manufacturers Mutual Insurance Company achangésonnom 1990. en celui de Arkwright Mutual Insurance Company àcompter du 14 avril 1987. Argonaut Insurance Company’s order to insure in Canada risks was revoked, at Arkwright Mututal Insurance Company a fusionné ses entreprise avec ceux de the company’s request, effective November 23, 1993. Allendale Mututal Insurance Company et ceux de Protection Mututal Insurance Company,etenvertudesloisdesÉtats-Unis d’Amérique, son certificat d’enregistrement a été retiré le 1er juillet 1999. Les sociétés fusionnées ont été prorogées en une société mutuelle fonctionnant sous la dénomination Factory Mutual Insurance Company,1er juillet 1999. Arkwright-Boston Manufacturers Mutual Insurance Company amalgamated its The Associated Canadian Travellers a cessé d’exercer des opérations au Canada. property and business with Philadelphia Manufacturers Mutual Insurance Lettres patentes de dissolution avec une date d’effet du 16 novembre 1994 ont Company effective September 7, 1984, the continuing or combined Company été émises. being Arkwright-Boston Manufacturers Mutual Insurance Company. Arkwright-Boston Manufacturers Mutual Insurance Company changed its name to Association Canado-Américaine a modifié sa dénomination sociale à celle de Arkwright Mutual Insurance Company effective April 14, 1987. ACA ASSURANCE à compter du 19 décembre 1997. Arkwright Mutual Insurance Company,having amalgamated its property and Assurances Continental limitée a modifié sa dénomination sociale pour celle de business with that of Allendale Mutual Insurance Company and Protection Compagnie d’assurance Lombard, à compter du 8 décembre 1995. Mutual Insurance Company, pursuant to the laws of the United States of America, ceased to be registered effective July 1, 1999. The foreigncompanies were continued as one mutual company under the name Factory Mutual Insurance Company, effective July 1, 1999. The Associated Canadian Travellers ceased transacting business in Canada. Assureurs-groupes Compagnie Canadienne d’Assurances a modifié sa dénomina- Letters patent of dissolution were issued effective November 16, 1994. tion sociale à celle de ING Novex Compagnie d’assurance du Canada à compter du 31 janvier 2000. Association Canado-Américaine changed its name to ACA ASSURANCE AXA Ré a modifié sa dénomination sociale à AXA Réassurance, le 21 décembre effective December 19, 1997. 1990. AXA Ré changed its name to AXA Réassurance effective December 21, 1990. AXA Réassurance a fusionné ses biens et son entreprise avec ceux de Abeille Réassurances depuis le 18 avril 1996, la compagnie issue de la fusion étant AXA Réassurance. AXA Réassurance amalgamated its property and business with that of Abeille La Baloîse, Compagnie d’Assurances a cessé d’exercer des opérations au Canada. Réassurances effective April 18, 1996, the continuing or combined company Lordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le 1er novem- being AXA Réassurance. bre 1999. The Baloise Insurance Company Limited ceased transacting business in Canada. Baltica-Nordisk Reinsurance Company A/S a changé son nom en celui de Nordisk The company’s order to insure in Canada risks was revoked effective Novem- Reinsurance Company A/S à compter du 24 mai 1988. ber 1, 1999. Baltica-Nordisk Reinsurance Company A/S changed its name to Nordisk Beneficial Standard Life Insurance Company a cessé d’exercer des opérations au Reinsurance Company A/SeffectiveMay 24, 1988. Canada. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le 10 octobre 1995. Baltica-Skandinavia Reinsurance Company of Canada changed its name to Boréal Compagnie d’assurances de dommages a modifié sa dénomination sociale Primmum Insurance Company effective July 20, 1988. pour celle de AXA Pacifique Compagnie d’Assurance, à compterdu23octobre 1995. 46 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite) Beneficial Standard Life Insurance Company ceased transacting business in Le Bouclier Laurentien Compagnie d’Assurances a fusionné ses biens et Canada. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effective opérations avec les biens et opérations de Laurentienne Casualty Compagnie October 10, 1995. d’Assurance de Dommages du Canada et avec les biens et opérations de La Laurentienne du Pacifique Compagnie d’Assurance le 27 février 1992; la compagnie résultant de cette fusion est la Laurentienne Compagnie d’Assurance de Dommages. Boreal Property & Casualty Insurance Company changed its name to AXA Pacific Buffalo Insurance Company achangé son nom en Underwriters Insurance Insurance Company effective October 23, 1995. Company àcompter du 9 novembre 1988. Buffalo Insurance Company changed its name to Underwriters Insurance Business Men’s Assurance Company of America a cessé d’exercer des opérations Company effective November 9, 1988. au Canada. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le 12 novembre 1999. Business Men’s Assurance Company of America ceased transacting business in CGU, Compagnie D’Assurance du Canada a fusionné ses biens et son entreprise Canada. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effective avec GAN General Insurance Company àcompter du 31 décembre 1999. La November 12, 1999. compagnie issue de la fusion est CGU, Compagnie D’Assurance du Canada. Cabot Insurance Company Limited, formerly a provincial insurer based in Cabot Insurance Company Limited, société d’assurances constituée sous le régime Newfoundland, was issued letters patent continuing it as a company under the des lois de Terre-Neuve, a reçu des lettres patentes la prorogeant sous le régime Insurance Companies Act, and concurrently amalgamated property and de la Loi sur les sociétés d’assurances et a fusionné ses éléments d’actif et ses business with Canadian General Insurance Company effective June 16, 1997, activités avec celles de la Compagnie d’Assurance Canadienne Générale le the continuing company being Canadian General Insurance Company. 16 juin 1997. La société issue de la fusion aura pour désignation sociale la Compagnie d’Assurance Canadienne Générale. The Canada Accident and Fire Insurance Company amalgamated its property and Canada Uni, Compagnie d’Assurance : le certificat d’enregistrement n’a pas été business with that of the Stanstead and Sherbrooke Insurance Company and renouvelé le 1er mars 1986 et la compagnie est maintenant en voie de that of Commercial Union Assurance Company of Canada effective January 1, liquidation en vertu des dispositions de la Loi sur les liquidations. 1989; the continuing or combined company being Commercial Union Assurance Company of Canada. The Canada Life Assurance Company amalgamated its property and business with Canners Exchange Subscribers at Warner Inter-Insurance Bureau : les obligations that of Crown Life Insurance Company of Canada effective July 1, 1999, the de la compagnie ayant été transférées à Employers Insurance of Wausau a continuing company being the Canada Life Assurance Company. Mutual Company àcompter du 31 décembre 1991, la compagnie a cessé d’être enregistrée à compter du 5 février 1993. Canada Security Assurance Company changed its name to Scotia General The Capitol Life Insurance Company a cessé d’exercer des opérations au Canada. Insurance Company effective January 10 , 1996. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le 16 juin 1994. The Canadian Commerce Insurance Company amalgamated its property and Central Mutual Insurance Company a cédé son passif canadien. Le certificat business with that of Trafalgar Insurance Company of Canada effective d’enregistrement de la compagnie n’a pas été renouvelé au 31 mars 1986. January 1, 1993, the continuing or combined company being Trafalgar Insurance Company of Canada. Canadian Direct Insurance Incorporated changed its name to HSBC Canadian Château Compagnie d’Assurance a fusionné ses biens et son entreprise avec ceux Direct Insurance Incorporated effective October 1, 1999. de La Citadelle, Compagnie d’Assurances Générales et Chateau Insurance Management Inc. à compter du 1er octobre 1994, la compagnie issue de la fusion étant La Citadelle, Compagnie d’Assurances Générales. Canadian Foresters Life Insurance Society,having amalgamated its property and Christiania General Insurance Corporation a cessé d’exercer des opérations au business with that of The Independent Order of Foresters, ceased to be Canada et tout son passif canadien a été prisencharge par Folksamerica registered on February 26, 1992. Reinsurance Company. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le 6 mai 1997 Canadian General Insurance Company amalgamated its property and business CIGNA du Canada Compagnie d’assurance a modifié sa dénomination sociale à with that of USF&G Insurance Company of Canada effective June 30, 1990, the celle d’ Assurance ACE INA à compter du 1er september 1999. continuing or combined company being Canadian General Insurance Company. Canadian General Insurance Company amalgamated its property and business CIGNA Property and Casualty Insurance Company : les obligations de la with that of Toronto General Insurance Company as of January 1, 1994, the compagnie ayant été transférée à CIGNA Insurance Company of Canada, la continuing company being Canadian General Insurance Company. compagnie a cessé d’être enregistrée à compter du 24 décembre 1990. Canadian General Insurance Company amalgamated its property and business La Citadelle, Compagnie d’Assurance-Vie a changé son nom en celui de la with that of Cabot Insurance Company Limited effective June 16, 1997, the Compagnie d’assurance-vie Première du Canada à compter du 1er janvier 1994. continuing company being Canadian General Insurance Company. Canadian General Insurance Company amalgamated its property and business College Retirement Equities Fund a cessé d’exercer des opérations au Canada et with that of The General Accident Assurance Company of Canada effective tout son passif canadien a été prisencharge par Sun Life du Canada, January 1, 1998, the continuing company being The General Accident compagnie d’assurance-vie. L’ordonnance portant garantie des risques au Assurance Company of Canada. Canada a été annulée le 6 avril 1998. Canadian Group Underwriters Insurance Company changed its name to ING Cologne Life Reinsurance Company a modifié sa dénomination sociale à celle de Novex Insurance Company of Canada effective January 31, 2000. General & Cologne Life Re of America à compter du 25 février 2000. Canadian Home Assurance Company amalgamated its property and business with Colonia Compagnie d’Assurance-Vie a modifié sa dénomination sociale à celle de that of The Canadian Provincial Insurance Company effective December 31, Concordia compagnie d’assurance-vie à compter du 30 décembre 1998. 1992, the continuing or combined company being Allianz Insurance Company of Canada. The Canadian Indemnity Company amalgamated its property and business with The Commercial Travellers’ Association of Canada a changé son nom en celui de that of The Casualty Company of Canada and that of The Dominion of Canada L’Association Canadienne des professionnels de la vente à compter du 1er juin General Insurance Company effective May 31, 1989, the continuing or 1991. combined company being The Dominion of Canada General Insurance Company. Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 47

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite) Canadian Northern Shield Insurance Company changed its French name to Le Commercial Union Assurance Companyplc a modifié sa dénomination sociale à Bouclier du Nord Canadien, Compagnie d’Assurance effective August 11, celle de CGU International Insurance plcàcompter du 1er octobre 1999. 1986. The Canadian Provincial Insurance Company amalgamated its property and La Compagnie d’Assurances Adriatique du Canada a fusionné ses biens et son business with that of Canadian Home Assurance Company effective Decem- entreprise avec ceux de la Compagnie d’Assurance du Home Canadien à ber 31, 1992, the continuing or combined company being Allianz Insurance compter du 1er janvier 1991, la compagnie issue de la fusion étant la Company of Canada. Compagnie d’Assurance du Home Canadien. Canadian Reassurance Company changed its name to Swiss Re Life Canada La Compagnie d’Assurance Albion du Canada a changé son nom en celui de La effective June 5, 1995. Métropolitaine Générale, Compagnie d’Assurance à compter du 16 février 1988. Canadian Reinsurance Company changed its name to Swiss Reinsurance Compagnie d’Assurance Allianz du Canada a fusionné ses biens et son entreprise Company Canada effective June 5, 1995. avec ceux de la Compagnie d’Assurance Cornhill du Canada à compter du 1er novembre 1993, la compagnie issue de la fusion étant la Compagnie d’Assurance Allianz du Canada. The Canadian Surety Company Amalgamated its property and business with that La Compagnie D’Assurance American Life a cessé d’exercer des opérations au of Allianz Insurance Company of Canada effective April 1, 1999, the Canada et son passif canadien a été prise en charge par La Compagnie continuing company being Allianz Insurance Company of Canada. D’Assurance-Vie American International Ltée. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le 31 décembre 1996. Canners Exchange Subscribers at Warner Inter-Insurance Bureau, having La Compagnie d’Assurance Bouclier Canadien Nord a changé son nom en celui transferred its Canadian liabilities to Employers Insurance of Wausau a Mutual de Le Bouclier du Nord Canadien, Compagnie d’Assurance à compter du Company effective December 31, 1991, ceased to be registered February 5, 11 août 1986. 1993. The Capitol Life Insurance Company ceased transacting business in Canada. The La Compagnie d’Assurance du Canada contre l’Incendie a changésa company’s order to insure in Canada risks was revoked effective June 16, 1994. dénomination sociale à Compagnie d’assurances générales Legacy àcompter du 1er janvier 1994. Cardinal Insurance Company’s certificate of registry was withdrawn effective La Compagnie D’Assurance Canada Security a modifié sa dénomination sociale à February 19, 1982, and the company is being wound up under the provisions of celle de Scotia Générale, compagnie d’assurance à compter du 10 janvier 1996. the Winding-up Act. The Casualty Company of Canada amalgamated its property and business with Compagnie D’Assurances Canadian Surety a fusionné ses biens et son entreprise that of The Canadian Indemnity Company and that of The Dominion of Canada avec Compagnie d’Assurance Allianz du Canada, à compter du 1er avril 1999. General Insurance Company effective May 31, 1989, the continuing or La compagnie issue de la fusion est Compagnie d’Assurance Allianz du combined company being The Dominion of Canada General Insurance Canada. Company. Central Mutual Insurance Company,having disposed of its liabilities in Canada, Compagnie d’Assurance Canadienne Commerce a fusionné ses biens et son ceased to be registered effective March 31, 1986. entreprise avec ceux de la Compagnie d’Assurance Trafalgar du Canada à compter du 1er janvier 1993, la compagnie issue de la fusion étant la Compagnie d’Assurance Trafalgar du Canada. Century Insurance Company of Canada: An order was issued December 1, 1989, La Compagnie d’Assurances Canadienne Directe Incorporée a modifié sa whereby the property and business of Century Insurance Company of Canada dénomination sociale à celle de La Compagnie d’Assurances HSBC was to be wound up into the Dominion Insurance Corporation. Canadienne Directe Incorporéeàcompter du 1er octobre 1999. CGU Insurance Company of Canada amalgamated its property and business with La Compagnie d’Assurance Canadienne Générale a fusionné avec la Compagnie that of GAN General Insurance Company effective December 31, 1999, the d’Assurance USF&G du Canada le 30 juin 1990; les activités se poursuivent continuing company being CGU Insurance Company of Canada sous la raison sociale Compagnie d’Assurance Canadienne Générale. Chateau Insurance Company amalgamated its property and business with that of Compagnie d’Assurance Canadienne Générale a fusionné ses biens et son The Citadel General Assurance Company and Chateau Insurance Management entreprise avec ceux de la Compagnie d’Assurance Toronto Générale à compter Inc. effective October 1, 1994, the continuing company being The Citadel du 1er janvier 1994, la compagnie issue de la fusion étant la Compagnie General Assurance Company. d’Assurance Canadienne Générale. Chequers Insurance Company,having transferred its Canadian liabilities to Compagnie d’Assurance Canadienne Générale a fusionné ses biens et son Markel Insurance Company of Canada, ceased to be registered effective entreprise avec Cabot Insurance Company Limited, à compter du 16 juin 1997. May 31, 1992. La compagnie issue de la fusion est Compagnie d’Assurance Canadienne Générale. Christiania General Insurance Corporation ceased transacting business in Canada Compagnie d’Assurance Canadienne Générale a fusionné ses biens et son and transferred its remaining Canadian policies to Folksamerica Reinsurance entreprise avec General Accident, Compagnie d’Assurance du Canada, à Company. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effective compter du 1er janvier 1998. La compagnie issue de la fusion est General May 6, 1997. Accident, Compagnie d’Assurance du Canada. CIBC General Group Insurance Company Limited amalgamated its property and La Compagnie d’Assurance Canadienne Provinciale a fusionné ses biens et son business with that of CIBC General Insurance Company Limited effective entreprise avec ceux de la Compagnie d’Assurance du Home Canadien à November 1, 1994, the continuing or combined company being CIBC General compter du 31 décembre 1992, la compagnie issue de la fusion étant la Insurance Company Limited. Compagnie d’Assurance Allianz du Canada. CIGNA Insurance Company of Canada changed its name to ACE INA Insurance La Compagnie d’Assurance Cardinal le certificat d’enregistrement a été retiré le effective September 1, 1999. 19 février 1982 et la compagnie est maintenant en voie de liquidation en vertu des dispositions de la Loi sur les liquidations. CIGNA Property and Casualty Insurance Company,having transferred its La Compagnie d’assurance Casualty du Canada a fusionné ses biens et son liabilities to CIGNA Insurance Company of Canada, ceased to be registered entreprise avec ceux de L’Indemnité Compagnie Canadienne et ceux de la effective December 24, 1990. Compagnie d’assurance générale Dominion du Canada à compter du 31 mai 1989, la compagnie issue de la fusion étant la Compagnie d’assurance générale Dominion du Canada. 48 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite) The Citadel Life Assurance Company changed its name to Canadian Premier Life Les biens et opérations de la Compagnie d’Assurance Century du Canada ont été Insurance Company effective January 1, 1994. cédés à La Dominion Corporation d’Assurance et un décret a été émis en vertu de la Loi sur les liquidations pourlaCompagnie d’Assurance Century du Canada au 1er décembre 1989. College Retirement Equities Fund ceased transacting business in Canada and Les obligations de La Compagnie d’Assurance Chequers ayant été transférées à la transferred its Canadian policies to Sun Life Assurance Company of Canada. Markel Compagnie d’Assurance du Canada, la Compagnie a cessé d’être The company’s order to insure in Canada risks was revoked effective April 6, enregistrée à compter du 31 mai 1992. 1998. Cologne Life Reinsurance Company changed its name to General & Cologne Life La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie a fusionné ses biens et son Re of America effective February 25, 2000. entreprise avec Crown, compagnie d’assurance vie du Canada, à compter du 1er juillet 1999. La compagnie issue de la fusion est La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. Colonia Life Insurance Company changed its name to Concordia Life Insurance La Compagnie d’Assurance Consolidated Générale a modifié sa dénomination Company effective December 30, 1998. sociale pour celle de Compagnie d’assurance GE Capital Casualty, Canada, à compter du 17 juillet 1996. The Commercial Travellers’ Association of Canada changed its name to Canadian La Compagnie d’Assurance Continental du Canada a cessé ses opérations sous la Professional Sales Association effective June 1, 1991. Loi sur les sociétés d’assurances,etareçu un certificat de prorogation en vertu de la Loi sur les sociétés par actions,endatedu6septembre 1995, sous la dénomination sociale CICAN I Investment Holding Corp. Commercial Union Assurance Companyplc changed its name to CGU La compagnie d’assurances Continental du Canada inc. a modifié sa dénomination International Insurance plc effective October 1, 1999. sociale pour celle de Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard, à compter du 8 décembre 1995. Commercial Union Assurance Company of Canada amalgamated its property and La Compagnie d’Assurance contre les Accidents et l’Incendie du Canada a business with that of CGU Insurance Company of Canada, effective October 1, fusionné ses biens et opérations avec les biens et opérations de la Compagnie 1999. The continuing or combined company is CGU Insurance Company of d’Assurance Stanstead & Sherbrooke et avec les biens et opérations de la Canada. Compagnie d’Assurance Union Commerciale du Canada le 1er janvier 1989; la compagnie fusionnée ou la compagnie prenant suite des opérations est La Compagnie d’Assurance Union Commerciale du Canada. Compagnie Transcontinentale de Réassurance ceased transacting business in Compagnie d’Assurance Cornhill du Canada a fusionné ses biens et son entreprise Canada. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effective avec ceux de la Compagnie d’Assurance Allianz du Canada à compter du December 16, 1998. 1er novembre 1993, la compagnie issue de la fusion étant la Compagnie d’Assurance Allianz du Canada. Consolidated General Insurance Company Limited changed its name to GE Compagnie d’Assurances Dominion a cessé ses opérations sous la Loi sur les Capital Casualty Company, Canada effective July 17, 1996. sociétés d’assurances, et a reçu un certificat de prorogationenvertudelaLoi sur les sociétés par actions,endatedu6septembre 1995, sous la dénomination sociale CICAN II Investment Holding Corp. Consolidated Life Assurance Company Limited ceased transacting business in La Compagnie d’Assurance Eaton: un décret a été émis en vertu de la Loi sur les Canada and transferred its Canadian policies to American Bankers Life liquidations pourlacompagnie le 19 décembre 1989. Assurance Company of Florida. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effective October 13, 1995. The Continental Insurance Company of Canada was discontinued under the Compagnie d’assurance Fidélité du Canada a changé son nom en celui de Insurance Companies Act and was issued a certificate of continuance under the Compagnie d’Assurance USF&G du Canada à compter du 1er juin 1985. Canada Business Corporations Act on September 6, 1995 under the name CICAN I Investment Holding Corp. The Continental Insurance Company of Canada Inc. changed its name to Lombard La Compagnie d’assurance Forteresse d’Amérique : les obligations de la General Insurance Company of Canada effective December 8, 1995. compagnie ayant été transférées à Marine Indemnity Insurance Company of America, la compagnie a cessé d’être enregistrée à compter du 10 décembre 1993. Continental Insurance Limited changed its name to Lombard Insurance Company Compagnie d’assurance générale de la Banque Royale du Canada a modifié sa effective December 8, 1995. dénomination sociale à celle de Compagnie d’assurance générale RBC à compter du 16 août 1999. The Contingency Insurance Company Limited, having transferred its Canadian Compagnie d’Assurance générale de groupes CIBC Limitée a fusionné ses biens liabilities to Gan Canada Insurance Company, ceased to be registered effective et son entreprise avec ceux de la Compagnie d’assurance générale CIBC January 1, 1988. Limitée à compter du 1er novembre 1994, la compagnie issue de la fusion étant la Compagnie d’assurance générale CIBC Limitée. Cornhill Insurance Company of Canada amalgamated its property and business La Compagnie d’Assurance Générale Kansa International S.A. : le 8 mars 1995, la with that of Allianz Insurance Company of Canada effective November 1, 1993, cour a demandé la liquidation de Kansa General International Insurance the continuing or combined company being Allianz Insurance Company of Company Limitedsouslesprovisions de la Loi sur les liquidations, nommant Canada. Ferdinand Alfieri, 1, place Ville Marie, Bureau 2115, Montréal (Québec) H3B 2C6, au titre de liquidateur provisoire de la société, de se charger des procédures canadiennes de liquidation de la société. The Credit Life Insurance Company changed its name to Union Fidelity Life La Compagnie d’Assurance Générale Kent a fusionné ses biens et son entreprise Insurance Company effective June 13, 1994. avec La Citadelle, Compagnie d’Assurances Générales, à compter du 30 novembre 1997. La compagnie issue de la fusion est La Citadelle, Compagnie d’Assurances Générales. Crown Life Insurance Company of Canada and The Canada Life Assurance La Compagnie d’Assurance Générale Strathcona a fusionné ses biens et opéra- Company amalgamated and were continued as one mutual company under the tions avec les biens et opérations de Northumberland, Compagnie Générale name The Canada Life Assurance Company effective July 1, 1999 at 12:01 a.m. d’Assurances le 31 août 1983; la compagnie fusionnée ou la compagnie prenant suite des opérations est la Northumberland, Compagnie Générale d’Assurances. Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 49

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite) CUMIS Insurance Society, Inc. ceased transacting business in Canada. The Com- La Compagnie d’Assurance Great Eastern a fusionné ses biens et opérations avec pany’s order to insure in Canada risks was revoked effective January 1, 2000. les biens et opérations de London-Canada Insurance Company le 31 décembre 1987; la compagnie fusionnée ou la Compagnie prenant suite des opérations est Compagnie d’Assurance Hartford du Canada. The Dominion Insurance Corporation was discontinued under the Insurance Compagnie d’Assurance Guardian du Canada a modifié sa dénomination sociale à Companies Act and was issued a certificate of continuance under the Canada celle de La Nordique compagnie d’assurance du Canada à compter du Business Corporations Act on September 6, 1995 under the name CICAN II 1er février, 1999. Investment Holding Corp. Eaton Insurance Company: An order was issued December 19, 1989 winding up La Compagnie d’Assurances Herald : Conformément à la demande de la Eaton Insurance Company. compagnie, l’ordonnance d’autorisation de fonctionnement de La Compagnie d’Assurances Herald a été annulée le 17 décembre 1992. Electrical Workers’ Benefit Association ceased to exist as at December 31, 1991. La Compagnie d’Assurance du Home Canadien a fusionné ses biens et son entreprise avec ceux de La Compagnie d’Assurance Canadienne Provinciale à compter du 31 décembre 1992, la compagnie issue de la fusion étant la Compagnie d’Assurance Allianz du Canada. Emmco Insurance Company changed its name to Associates Insurance Company Compagnie d’Assurance Longroup a modifié sa dénomination sociale à celle de effective October 30, 1986. Compagnie d’Assurance London Garantie à compter du 12 juin 1995. English & American Insurance Company Limited’s order to insure in Canada La Compagnie d’Assurance Missisquoi et Rouville a modifié sa raison sociale le 6 risks was revoked effective October 6, 1993, and the company is being wound novembre 1989 et se nomme maintenant La compagnie d’Assurance up under the provisions of the Winding-Up Act. Missisquoi. Ennia Insurance Company (U.K.) Limited changed its name to Aegon Insurance Compagnie d’assurances New York Life du Canada et La Compagnie d’Assurance Company (U.K.) Limited effective May 3, 1985. du Canada sur la Vie ont été fusionnées et prorogées en une société fonctionnant sous la dénomination sociale de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie le 1er avril 1994. Federated Mutual Insurance Company’s order to insure in Canada risks was La Compagnie D’Assurance OTIP/RAEO Inc. a modifié sa dénomination sociale à revoked, at the company’s request, December 31, 1992. celle de La Compagnie d’Assurance Everest du Canada à compter du 31 décembre 1996. Fidelity Insurance Company of Canada changed its name to USF&G Insurance La Compagnie d’Assurance Pohjola Ltée. (Vakuutusosakeyhtio Pohjola) a modifié Company of Canada effective June 1, 1985. sa dénomination sociale à celle de Pohjola Group Insurance Corporation à compter du 31 août 1998. The Fire Insurance Company of Canada changed its name to Legacy General La Compagnie d’Assurance Stanstead & Sherbrooke a fusionné ses biens et Insurance Company effective January 1, 1994. opérations avec les biens et opérations de la Compagnie d’Assurance contre les Accidents et l’Incendie du Canada et avec les biens et opérations de la Compagnie d’Assurance Union Commerciale du Canada le 1er janvier 1989; la compagnie fusionnée ou la compagnie prenant suite des opérations est La Compagnie d’Assurance Union Commerciale du Canada. Fireman’s Fund Insurance Company of Canada changed its name to Wellington La Compagnie d’Assurance Sun Alliance & London (Canada) a modifié sa Insurance Company effective March 1, 1985. dénomination sociale à celle de TBD Compagnie d’Assurance Vie à compter du 1er août 1995. Fireman’s Fund Insurance Company ceased transacting business in Canada. The Compagnie d’Assurance Toronto Générale a fusionné ses biens et son entreprise company’s order to insure in Canada risks was revoked effective March 19, avec ceux de la Compagnie d’Assurance Canadienne Générale à compter du 1997. 1er janvier 1994, la compagnie issue de la fusion étant la Compagnie d’Assurance Canadienne Générale. Folksamerica National Reinsurance Company ceased transacting business in Compagnie d’Assurance Traders Générale a fusionné ses biens et son entreprise Canada. The Company’s order to insure in Canada risks was revoked effective avec GAN Canada Compagnie d’Assurances à compter du 31 décembre 1999. December 31, 1996. La compagnie issue de la fusion est Compagnie d’Assurance Traders Générale. Foremost Insurance Company Grand Rapids, Michigan’s order to insure in Compagnie d’Assurance Trafalgar du Canada a fusionné ses biens et son Canada risks was revoked, at the company’s request, effective August 31, 1995. entreprise avec ceux de la Compagnie d’Assurance Canadienne Commerce à compter du 1er janvier 1993, la compagnie issue de la fusion étant la Compagnie d’Assurance Trafalgar du Canada. Fortress Insurance Company of America, having transferred its Canadian La Compagnie d’Assurance Union Commerciale du Canada a fusionné ses biens liabilities to Marine Indemnity Insurance Company of America, ceased to be et son entreprise avec ceux de CGU, Compagnie D’Assurance du Canada à registered effective December 10, 1993. compter du 1er octobre 1999, la compagnie issue de la fusion étant CGU, Compagnie D’Assurance du Canada. The Franklin Life Insurance Company ceased transacting business in Canada and La Compagnie d’Assurance USF&G du Canada a fusionné avec la Compagnie transferred its remaining Canadian policies to Colonia Life Insurance Company. d’Assurance Canadienne Générale le 30 juin 1990; les activités se poursuivent The company’s order to insure in Canada risks was revoked effective Decem- sous la raison sociale Compagnie d’Assurance Canadienne Générale. ber 31, 1996. Frankona Rückversicherungs-Aktien-Gesellschaft changed its name to ERC Compagnie d’Assurances Victoria du Canada a fusionné ses biens et son Frankona Rückversicherungs-Aktien-Gesellschaft effective April 1, 1999. entreprise avec Compagnie d’Assurance Traders Générale, à compter du 1er janvier 1996. La compagnie issue de la fusion est la Compagnie d’Assurance Traders Générale. GAN Canada Insurance Company amalgamated its property and business with La Compagnie d’Assurance-Vie American International Ltée a modifié sa that of Traders General Insurance Company effective December 31, 1999, the dénomination sociale à celle de La Compagnie d’Assurance-Vie AIG du continuing company being Traders General Insurance Company. Canada à compter du 1er avril 1998. 50 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite) GAN General Insurance Company, formerly a provincial insurer based in Ontario, Compagnie d’assurance-vie de la Banque Royale du Canada a modifié sa was issued letters patent continuing it as a company under the Insurance Com- dénomination sociale à celle de Compagnie d’assurance vie RBC à compter du panies Act, and concurrently amalgamated its property and business with CGU 4 octobre 1999. Insurance Company of Canada effective December 31, 1999, the continuing company being CGU Insurance Company of Canada Gan Incendie Accidents Compagnie Française, having transferred its Canadian La Compagnie d’Assurance-Vie Glacier National a modifié sa dénomination liabilities to Gan Canada Insurance Company, ceased to be registered effective sociale à celle de Scotia-Vie compagnie d’assurance à compter du 16 décembre January 1, 1988. 1994. The General Accident Assurance Company of Canada changed its name to CGU Compagnie d’Assurance-Vie Laurier et L’Impériale, compagnie d’assurance-vie Insurance Company of Canada effective March 31,1999. ont été fusionnées et prorogées en une société fonctionnant sous la dénomination sociale de L’Impériale, compagnie d’assurance-vie le 1er janvier 1998. General Accident Indemnity Company amalgamated its property and business Compagnie d’assurances-vie La Métropolitaine du Canada et La Mutuelle du with that of Prudasco Assurance Company effective January 1, 1994, the Canada, compagnie d’assurance sur la vie ont été fusionnées et prorogées en continuing or combined company being General Accident Indemnity Company. une société mutuelle fonctionnant sous la dénomination sociale de La Mutuelle du Canada, compagnie d’assurance sur la vie le 31 décembre 1998 à 23 h 59. The General Accident Indemnity Company amalgamated its property and business La Compagnie d’Assurance-Vie Primerica a cessé d’exercer des opérations au with that of The General Accident Assurance Company of Canada effective Canada et tout son passif canadien a été prisencharge par La Compagnie December 31, 1994, the continuing or combined company being The General d’Assurance-Vie Primerica du Canada. L’ordonnance portant garantie des Accident Assurance Company of Canada. risques au Canada a été annulée le 19 août 1994. General American Life Reinsurance Company of Canada changed its name to La Compagnie d’assurance-vie Transamerica Occidental a cessé d’exercer des RGA Life Reinsurance Company of Canada effective September 18, 1995. opérations au Canada et tout son passif canadien a été prisencharge par la Compagnie d’Assurance-Vie Transamerica du Canada. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le 12 avril 1995. General Insurance Company of changed its name to RBC La Compagnie d’Assurance Wellington a changé son nom en celui de Compagnie General Insurance Company effective August 16, 1999. d’Assurance Wellington à compter du 11 août 1986. General Reassurance Corporation changed its name to Life Reassurance La Compagnie Canadienne de Réassurance a modifié sa dénomination sociale à Corporation of America effective August 3, 1989. celle de Suisse de Réassurance Vie Canada à compter du 5 juin 1995. General Security Assurance Corporation of New York changed its name to SCOR Compagnie de Garantie Seaboard du Canada a fusionné ses biens et son entreprise Reinsurance Company effective March 31, 1994. avec La Compagnie d’Indemnité du Nord, Inc. à compter du 1er janvier 2000. La compagnie issue de la fusion est La Compagnie d’Indemnité du Nord, Inc. General Security Insurance Company of Canada, following the passageofa La Compagnie d’Indemnité du Nord, Inc. a fusionné ses biens et son entreprise Special Act by the Senate of Canada, was continued by Letters Patent of avec Compagnie de Garantie Seaboard du Canada à compter du 1er janvier Continuation as an insurance company under the laws of the Province of 2000. La compagnie issue de la fusion est La Compagnie d’Indemnité du Nord, Quebec effective December 1, 1994, under the name General Security Inc. Insurance Company of Canada Inc. Glacier National Life Assurance Company changed its name to Scotia Life La Compagnie Mutuelle d’Assurance-vie Wawanesa a changé son nom en celui de Insurance Company effective December 16, 1994. La Compagnie d’Assurance-vie Wawanesa à compter du 1er octobre 1993. Globe Life Insurance Company ceased transacting business in Canada. The La Compagnie de Réassurances Baltica-Skandinavia du Canada a changésonnom company’s order to insure in Canada risks was revoked effective May 19, 1995. en celui de Primmum Compagnie d’Assurance à compter du 20 juillet 1988. The Great Eastern Insurance Company amalgamated its property and business La Compagnie de Réassurance Kanata a changé son nom en celui de Trygg-Hansa with that of London-Canada Insurance Company effective December 31, 1987, Reinsurance Company of Canada le 28 janvier 1991. the continuing or combined company being Hartford Insurance Company of Canada. The Great Lakes Reinsurance Company changed its name to Temple Insurance La Compagnie de Réassurance Mercantile et Générale du Canada a fusionné ses Company, effective April 2, 1998. biens et son entreprise avec Compagnie Suisse de Réassurance Canada, à compter du 1er juillet 1997. La compagnie issue de la fusion est Compagnie Suisse de Réassurance Canada. Guardian Insurance Company of Canada changed its name to The Nordic La Compagnie de Réassurance Sphère du Canada a modifié sa dénomination Insurance Company of Canada effective February 1, 1999. sociale pourLaCompagnie d’Assurance Chequers au 31 août 1989. Guildhall Insurance Company’s order to insure in Canada risks was revoked, at La Compagnie de Réassurance TIG a modifié sa dénomination sociale à celle de the company’s request, effective October 23, 1995. Odyssey America Reinsurance Corporation à compter du 26 janvier 2000. Hartford Life Insurance Company of Canada and AIG Life Insurance Company of La Compagnie de Réassurance Vie Mercantile et Générale du Canada et Suisse de Canada amalgamated and were continued as one company under the name AIG Réassurances Vie et Santé Canada ont été fusionnées et prorogées en une Life Insurance Company of Canada effective September 30, 1999. société fonctionnant sous la dénomination sociale de Suisse de Réassurances Vie et Santé Canada le 1er juillet 1997. The Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Company,having transferred Compagnie Transcontinentale de Réassurance a cessé d’exercer des opérations au it Canadian liabilities to The Boiler Inspection and Insurance Company of Canada. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le Canada, ceased to be registered effective December 31, 1988. 16 décembre 1998. Helvetia Swiss Fire Insurance Company, Limited changed its name to Helvetia Consolidated Life Assurance Company Limited a cessé d’exercer des opérations Swiss Insurance Company, Limited effective June 19, 1989. au Canada et tout son passif canadien a été prisencharge par American Bankers Compagnie d’Assurances-Vie de la Floride. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le 13 octobre 1995. Herald Insurance Company’s order to commence and carry on business of Herald The Contingency Insurance Company Limited a cessé d’exercer des opérations au Insurance Company was revoked, at the request of the company, effective Canada et tout son passif canadien a été prisencharge par GAN Canada December 17, 1992. Compagnie d’Assurances le 1er janvier 1988. Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 51

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite) The Hungarian Reformed Federation of America ceased transacting business in Corporation de Garantie RoyNat le certificat d’enregistrement a été retiré le Canada and transferred its Canadian policies to Toronto Mutual Life Insurance 21 juin 1984, conformément à la demande de la compagnie. Company. The society’s order to insure in Canada risks was revoked effective May 28, 1996. Ideal Mutual Insurance Company’s certificate of registry was withdrawn effective The Credit Life Insurance Company a modifié sa dénomination sociale à celle de February 15, 1985, and the company is being wound up under the provisions of Union Fidelity Life Insurance Company àcompter du 13 juin 1994. the Winding-Up Act. The Imperial Life Assurance Company of Canada and its wholly-owned Crown, compagnie d’assurance vie du Canada et La Compagnie d’Assurance du subsidiary, Laurentian Life Insurance Company of Canada, amalgamated and Canada sur la Vie ont été fusionnées et prorogées en une société mutuelle were continued as one company under the name The Imperial Life Assurance fonctionnant sous la dénomination sociale de La Compagnie d’Assurance du Company of Canada effective January 1, 1993. Canada sur la Vie le 1er juillet 1999 à 00 h 01. INA Insurance Company of Canada changed its name to CIGNA Insurance CUMIS Insurance Society, Inc. a cessé d’exercer des opérations au Canada. Company of Canada effective September 1, 1985. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le 1er janvier 2000. Industrial Credit Insurance Company: At the request of the company, its certificate Electrical Workers’ Benefit Association a cessé d’exister le 31 décembre 1991. of registry was discontinued effective October 5, 1984. Insurance Company of North America, having transferred its Canadian liabilities Emmco Insurance Company achangé son nom en celui de Associates Insurance to CIGNA Insurance Company of Canada, ceased to be registered effective Company àcompter du 30 octobre 1986. February 28, 1993. The Insurance Corporation of Ireland Limited changed its name to ICAROM La English & American Insurance Company Limited s’est vue annuler son Public Limited Company effective December 20, 1991. Ordonnance portant garantie des risques au Canada le 6 octobre 1993 et la compagnie est maintenant en voie de liquidation en vertu des dispositions de la Loi sur les liquidations. ITT Hartford Life Insurance Company of Canada changed its name to Hartford Ennia Insurance Company (U.K.) Limited a changé son nom en celui de Aegon Life Insurance Company of Canada effective October 1, 1997. Insurance Company (U.K.) Limited à compter du 3 mai 1985. John Deere Insurance Company of Canada changed its name to Echelon General La Federated, Compagnie Mutuelle d’Assurances : Conformément à la demande Insurance Company, effective March 5, 1998. de la compagnie, l’ordonnance portant garantie des risques au Canada par La Federated, Compagnie Mutuelle d’Assurances a été annulée le 31 décembre 1992. John Hancock Mutual Life Insurance Company changed its name to John Hancock Fireman’s Fund du Canada Compagnie d’Assurance a changé son nom en celui de Life Insurance Company effective February 1, 2000. La Compagnie d’Assurance Wellington à compter du 1er mars 1985. Kanata Reinsurance Company changed its name to Trygg-Hansa Reinsurance Fireman’s Fund Insurance Company a cessé d’exercer des opérations au Canada. Company of Canada effective January 28, 1991. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le 19 mars 1997. Kansa General Insurance Company Limited changed its name to Kansa General Folksamerica National Reinsurance Company a cessé d’exercer des opérations au International Insurance Company Limited effective March 30, 1990. Canada. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le 31 décembre 1996. Kansa General International Insurance Company Limited: On March 8, 1995 the Forestiers Canadiens, Société d’Assurance-Vie, ayant fusionné ses biens et court ordered the winding-up of Kansa General International Insurance affaires avec les biens et affaires de L’Ordre Indépendant des Forestiers, la Company Limited under the provisions of the Winding Up Act,appointing société a cessé d’être enregistrée le 26 février 1992. Ferdinand Alfieri, 1 Place Ville Marie, Suite 2115, Montréal, Quebec H3B 2C6, as provisional liquidator of the company to proceed with the winding-up of the business in Canada of the company. Kemper Reinsurance Company changed its name to GE Reinsurance Corporation Foremost Insurance Company Grand Rapids, Michigan : Conformément à la effective May 19, 1999. demande de la société, l’ordonnance portant garantie des risques au Canada par Foremost Insurance Company Grand Rapids, Michigan a été annulée le 31 août 1995. Kent General Insurance Corporation amalgamated its property and business with The Franklin Life Insurance Company a cessé d’exercer des opérations au Canada that of The Citadel General Assurance Company effective November 30, 1997, et son passif canadien a été prisencharge par Colonia Compagnie the continuing company being The Citadel General Assurance Company. d’Assurance-Vie. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le 31 décembre 1996. Laurentian Casualty Company of Canada changed its French name to Frankona Rückversicherungs-Aktien-Gesellschaft a modifié sa dénomination Laurentienne Casualty Compagnie d’Assurance de Dommages du Canada sociale à celle de ERC Frankona Rückversicherungs-Aktien-Gesellschaft à effective February 21, 1990. compter du 1er avril 1999. Laurentian Casualty Company of Canada amalgamated its property and business GAN Canada Compagnie d’Assurances a fusionné ses biens et son entreprise avec with that of Laurentian Pacific Insurance Company and that of The Laurentian Compagnie d’Assurance Traders Générale à compter du 31 décembre 1999. La Shield Insurance Company effective February 27, 1992, the continuing or compagnie issue de la fusion est Compagnie d’Assurance Traders Générale. combined company being Laurentian P&C Insurance Company. Laurentian P&C Insurance Company changed its name to Boreal Property & GAN General Insurance Company, société d’assurances constituée sous le régime Casualty Insurance Company effective December 9, 1993. des lois de l’Ontario, a reçu des lettres patentes la prorogeant sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances et a fusionné ses éléments d’actif et ses ac- tivités avec celles de CGU, Compagnie D’Assurance du Canada le 31 décembre 1999. La société issue de la fusion aura pour désignation sociale CGU, Compa- gnie D’Assurance du Canada. Laurentian Pacific Insurance Company amalgamated its property and business Gan Incendie Accidents Compagnie Française a cessé d’exercer des opérations au with that of Laurentian Casualty Company of Canada and that of The Canada et tout son passif canadien a été pris en charge par Gan Canada Laurentian Shield Insurance Company effective February 27, 1992, the Compagnie d’Assurances le 1er janvier 1988. continuing or combined company being Laurentian P&C Insurance Company. 52 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite) The Laurentian Shield Insurance Company amalgamated its property and business General Accident, Compagnie d’Assurance du Canada a modifié sa dénomination with that of Laurentian Casualty Company of Canada and that of Laurentian sociale à celle de CGU, Compagnie D’Assurance du Canada à compter du Pacific Insurance Company effective February 27, 1992, the continuing or 31 mars 1999. combined company being Laurentian P&C Insurance Company. Laurier Life Insurance Company and The Imperial Life Assurance Company of Général Accident Indemnité Compagnie d’Assurance a fusionné ses biens et son Canada amalgamated and were continued as one company under the name The entreprise avec ceux de La Prudasco, Compagnie d’Assurance à compter du Imperial Life Assurance Company of Canada effective January 1, 1998. 1er janvier 1994, la compagnie issue de la fusion étant la Général Accident Indemnité Compagnie d’Assurance. Life Insurance Company of Royal Bank of Canada changed its name to RBC Life Général Accident Indemnité Compagnie d’Assurance a fusionné ses biens et son Insurance Company effective October 4, 1999. entreprise avec ceux de la General Accident, Compagnie d’Assurance du Canada à compter du 31 décembre 1994, la compagnie issue de la fusion étant General Accident, Compagnie d’Assurance du Canada. The London Assurance ceased transacting business in Canada. The company’s General American, Compagnie de réassurance-vie du Canada a modifié sa order to insure in Canada risks was revoked effective December 1, 1997. dénomination sociale à celle de RGA Compagnie de réassurance-vie du Canada àcompterdu18septembre 1995. London-Canada Insurance Company amalgamated its property and business with General Reassurance Corporation a changé son nom en celui de Life Reassurance that of The Great Eastern Insurance Company effective December 31, 1987, the Corporation of America à compter du 3 août 1989. continuing or combined company being Hartford Insurance Company of Canada. Longroup Insurance Company changed its name to London Guarantee Insurance General Security Assurance Corporation of New York a changé sa raison sociale à Company effective June 12, 1995. SCOR, Compagnie de Réassurance à compter du 31 mars 1994. Marine Indemnity Insurance Company of America ceased transacting business in Globe Life Insurance Company a cessé d’exercer des opérations au Canada. Canada. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effective L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le 19 mai December 31, 1997. 1995. The Maritime Life Assurance Company, a company incorporated under The Les Grands Lacs, Compagnie de Réassurance a modifié sa dénomination sociale à Maritime Life Assurance Company Act, Statutes of Nova Scotia, 1986, c.96 was celle de La compagnie d’assurance Templeàcompter du 2 avril 1998. continued as a company under the Insurance Companies Act effective Decem- ber 24, 1999. Massachusetts General Life Insurance Company ceased transacting business in Guildhall Insurance Company : Conformément à la demande de la société, Canada. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effective l’ordonnance portant garantie des risques au Canada par Guildhall Insurance October 18, 1993. Company a été annulée le 23 octobre 1995. Massachusetts Indemnity and Life Insurance Company changed its name to Hartford du Canada, Compagnie d’Assurance-Vie et La Compagnie d’Assurance- Primerica Life Insurance Company effective July 1, 1992. Vie AIG du Canada ont été fusionnées et prorogées en une société fonctionnant sous la dénomination sociale de La Compagnie d’Assurance-Vie AIG du Cana- da le 30 septembre 1999. The Mercantile and General Life Reassurance Company of Canada and Swiss Re The Hartford Steam Boiler and Inspection Company a cessé d’exercer des Life & Health Canada amalgamated and were continued as one company under opérations au Canada et tout son passif canadien a été prisencharge par La the name Swiss Re Life & Health Canada effective July 1, 1997. Compagnie d’Inspection et d’Assurance Chaudières et Machinerie le 31 décembre 1988. The Mercantile and General Reinsurance Company of Canada amalgamated its Helvetia Swiss Fire Insurance Company, Limited a changésonnompour Helvetia property and business with that of Swiss Reinsurance Company Canada Compagnie Suisse d’Assurances à compter du 19 juin 1989. effective July 1, 1997, the continuing company being Swiss Reinsurance Company Canada. The Mercantile and General Reinsurance Companyplc: At the company’s request, The Hungarian Reformed Federation of America a cessé d’exercer des opérations its order to insure in Canada risk was revoked effective December 31, 1992. au Canada et tout son passif canadien a été pris en charge par Toronto Mutual Life Insurance Company. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le 28 mai 1996. Metropolitan General Insurance Company, following the passageofaSpecial Act Ideal Mutual Insurance Company le certificat d’enregistrement a été retiré le by the Senate of Canada, was continued by Letters Patent of Continuation as an 15 février et la compagnie est maintenant en voie de liquidation en vertu des insurance company under the laws of the Province of Quebec effective dispositions de la Loi sur les liquidations. December 19, 1991. Metropolitan Insurance Company amalgamated its property and business with that L’Impériale, compagnie d’assurance-vie et sa filiale en propriété exclusive, of Metropolitan Life Insurance Company of Canada effective December 30, Laurentienne-Vie du Canada, Compagnie d’Assurance, ont été fusionnées et 1992, the continuing or continued company being Metropolitan Life Insurance prorogées en une société fonctionnant sous la dénomination sociale de Company of Canada. L’Impériale, compagnie d’assurance-vie le 1er janvier 1993. Metropolitan Life Insurance Company of Canada and The Mutual Life Assurance INA du Canada Compagnie d’Assurance a changé son nom en celui de CIGNA du Company of Canada amalgamated and were continued as one mutual company Canada Compagnie d’assurance à compter du 1er septembre 1985. under the name The Mutual Life Assurance Company of Canada effective December 31, 1998 at 11:59 p.m. Midland Insurance Company’s certificate of registry was withdrawn effective L’Indemnité Compagnie Canadienne a fusionné ses biens et son entreprise avec April 10, 1986, and the company is being wound up under the provisions of the ceuxdelaCompagnie d’assurance Casualty du Canada et ceux de la Winding Up Act. Compagnie d’assurance générale Dominion du Canada à compter du 31 mai 1989, la compagnie issue de la fusion étant la Compagnie d’assurance générale Dominion du Canada. The Minnesota Mutual Life Insurance Company changed its name to Minnesota Les obligations de Insurance Company of North America ayant été transférées à Life Insurance Company effective April 30, 1999. CIGNA du Canada Compagnie d’assurance, la compagnie a cessé d’être enregistrée à compter du 28 février 1993. Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 53

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite) Mission American Insurance Company,having disposed of its liabilities in The Insurance Corporation of Ireland Limited a changé son nom en celui de Canada, ceased to be registered effective March 31, 1991. ICAROM Public Limited Company àcompter du 20 décembre 1991. The Missisquoi and Rouville Insurance Company changed its name to the ITT Hartford du Canada, Compagnie d’Assurance-Vie a modifié sa dénomination Missisquoi Insurance Company effective November 6, 1989. sociale à celle de Hartford du Canada, Compagnie d’Assurance-Vie à compter du 1er octobre 1997. MONY Reinsurance Corporation changed its name to Folksamerica National John Deere, Compagnie D’Assurance du Canada a modifié sa dénomination Reinsurance Company effective September 24, 1992. sociale à celle de Échelon, Compagnie D’Assurances Générale à compter du 5 mars 1998. The Mutual Life Assurance Company of Canada changed its name to Clarica Life John Hancock Mutual Life Insurance Company a modifié sa dénomination sociale Insurance Company, effective July 21, 1999 at 12:01 a.m., as part of the à celle de John Hancock Life Insurance Company àcompter du 1er février 2000. conversion of the company into a company with common shares. Mutuelle Générale Française Accidents changed its name to Les Mutuelles du La Kansa General Insurance Company Limited a changé sa raison sociale le Mans I.A.R.D. effective March 4, 1988. 30 mars 1990. Elle s’appelle maintenant la Compagnie d’Assurance Générale Kansa International S.A. Les Mutuelles du Mans I.A.R.D. changed its name to La Mutuelle Du Mans Kemper Reinsurance Company a modifié sa dénomination sociale à celle de GE Assurances I.A.R.D. effective March 5, 1991. Reinsurance Corporation à compter du 19 mai 1999. National Employers’ Mutual General Insurance Association, Limited’s certificate La Laurentienne, Compagnie d’Assurance de Dommages du Canada a modifié sa of registry was withdrawn effective December 11, 1990, and the company is raison sociale le 21 février 1990; elle s’appelle maintenant Laurentienne being wound up under the provisions of the Winding Up Act. Casualty,Compagnie d’Assurance de Dommages du Canada. National Fraternal Society of the Deaf ceased transacting business in Canada. The Laurentienne Casualty Compagnie d’Assurance de Dommages du Canada a society’s order to insure in Canada risks was revoked effective April 30, 1996. fusionné ses biens et opérations avec les biens et opérations de La Laurentienne Policies were either surrendered or transferred to Croatian Fraternal Union of du Pacifique Compagnie d’Assurance et avec les biens et opérations de Le America. Bouclier Laurentien Compagnie d’Assurances le 27 février 1992; la compagnie résultant de cette fusion est la Laurentienne Compagnie d’Assurance de Dommages. The National Reinsurance Company of Canada was discontinued under the Laurentienne Compagnie d’Assurance de Dommages a changé sa dénomination Insurance Companies Act and was issued a certificate of continuance under the sociale à Boréal Compagnie d’assurances de dommages à compter du Canada Business Corporations Act effective December 22, 1994 under the 9 décembre 1993. name 3100715 Canada Inc. New England Insurance Company (formerly New England Reinsurance La Laurentienne du Pacifique Compagnie d’Assurance a fusionné ses biens et Corporation), having transferred its Canadian policies to New England opérations avec les biens et opérations de Laurentienne Casualty Compagnie Reinsurance Corporation, formerly Tower Insurance Company of Connecticut, d’Assurance de Dommages du Canada et avec les biens et opérations de Le as of January 1, 1984. Bouclier Laurentien Compagnie d’Assurances le 27 février 1992; la compagnie résultant de cette fusion est la Laurentienne Compagnie d’Assurance de Dommages. New England Mutual Life Insurance Company ceased transacting business in The London Assurance a cessé d’exercer des opérations au Canada. L’ordonnance Canada. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effective portant garantie des risques au Canada a été annulée le 31 décembre 1997. November 1, 1995. New England Reinsurance Corporation changed its name to New England London-Canada Insurance Company a fusionné ses biens et opérations avec les Insurance Company effective February 29, 1984. biens et opérations de La Compagnie d’Assurance Great Eastern le 31 décembre 1987; la compagnie fusionnée ou la compagnie prenant suite des opérations est la Compagnie d’Assurance Hartford du Canada. New England Reinsurance Corporation, having transferred its Canadian liabilities Marine Indemnity Insurance Company of America a cessé d’exercer des to The Hartford Fire Insurance Company, ceased to be registered effective opérations au Canada. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a December 31, 1988. été annulée le 31 décembre 1997. New Rotterdam Insurance Company changed its name to UAP-NewRotterdam La Maritime Compagnie d’Assurance-vie, une société constituée aux termes de Insurance Company N.V. effective October 28, 1997. The Maritime Life Assurance Company Act, Statutes of Nova Scotia, 1986, c.96, a été prorogée comme une société sous le régimedelaLoi sur les sociétés d’assurances àcompter du 24 décembre 1999. New York Life Insurance Company of Canada and The Canada Life Assurance Massachusetts General Life Insurance Company a cessé d’exercer des opérations Company amalgamated and were continued as one company under the name au Canada. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée The Canada Life Assurance Company effective April 1, 1994. le 18 octobre 1993. The New Zealand Insurance Company Limited, having transferred its Canadian Massachusetts Indemnity and Life Insurance Company achangé son nom en celui liabilities to Christiania General Insurance Corporation, ceased to be registered de La Compagnie d’Assurance-Vie Primerica à compter du 1er juillet 1992. effective March 31, 1991. The Non-Marine Underwriters, Members of Lloyd’s, London, England changed its The Mercantile and General Reinsurance Companyplc a cessé d’exercer des name to Lloyd’s Underwriters effective October 1, 1999. opérations au Canada et a cédé son passif canadien. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le 31 décembre 1992. Norman Insurance Company Limited: At the company’s request, the order to Metropolitan Insurance Company a fusionné ses biens et opérations avec les biens insure in Canada risks of Norman Insurance Company Limited was revoked et opérations de la Compagnie d’assurances-vie La Métropolitaine du Canada le effective December 31, 1992. 30 décembre 1992; la compagnie fusionné ou la compagnie prenant suite des opérations est la Compagnie d’assurances-vie La Métropolitaine du Canada. North American Benefit Association changed its name to Woman’s Life Insurance La Métropolitaine Générale, Compagnie d’Assurance, après l’adoption d’une Loi Society effective January 1, 1996. d’intérêt privé par le Sénat du Canada, a été prorogée par lettres patentes de continuation comme compagnie d’assurance de la province de Québec, en date du 19 décembre 1991. 54 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite) North American Company for Property and Casualty changed its name to NAC Midland Insurance Company le certificat d’enregistrement a été retiré le 10 avril Reinsurance Corporation effective July 29, 1989. 1986 et la compagnie est maintenant en voie de liquidation en vertu des dispositions de la Loi sur les liquidations. The North American General Insurance Company’s certificate of registry was The Minnesota Mutual Life Insurance Company a modifié sa dénomination withdrawn effective December 15, 1966, and the company is being wound up sociale à celle de Compagnie d’Assurance-vie Minnesota à compterdu30avril under the provisions of the Winding-up Act. 1999. North American Life and Casualty Company changed its name to Allianz Life Mission American Insurance Company ayant aliéné son passif au Canada, elle a Insurance Company of North America as at March 31, 1993. cessé d’être enregistrée à compter du 31 mars 1991. North American Life Assurance Company and The Manufacturers Life Insurance MONY Reinsurance Corporation a changé sa dénomination sociale pour Company amalgamated and were continued as one mutual company under the Folksamerica National Reinsurance Company àcompterdu24septembre 1992. name The Manufacturers Life Insurance Company effective January 1, 1996. North American Reassurance Company changed its name to Swiss Re Life La Mutuelle du Canada, compagnie d’assurance sur la vie a modifié sa Company America effective December 19, 1996. dénomination sociale à celle de Clarica, compagnie d’assurance sur la vie, à compter du 21 juillet 1999 à 00 h 01, suite à sa transformation en société par actions. North American Reinsurance Corporation, having transferred its Canadian liabili- Mutuelle Générale Française Accidents a changé son nom en Les Mutuelles du ties to Canadian Reinsurance Company, ceased to be registered effective De- Mans I.A.R.D. à compter du 4 mars 1988. cember 27, 1991. Northern Indemnity, Inc. amalgamated its property and business with that of Les Mutuelles Du Mans I.A.R.D. a changé son nom en celui de La Mutuelle Du Seaboard Surety Company of Canada effective January 1, 2000, the continuing Mans Assurances I.A.R.D. le 5 mars 1991. company being Northern Indemnity,Inc. Northumberland General Insurance Company amalgamated its property and La National Employers’ Mutual General Insurance Association, Limited s’est vue business with that of The Strathcona General Insurance Company effective retirer son certificat d’enregistrement le 11 décembre 1990 et la compagnie est August 31, 1983, the continuing or combined company being Northumberland maintenant en voie de liquidation en vertu des dispositions de la Loi sur les General Insurance Company. liquidations. Northumberland General Insurance Company’s certificate of registry was not National Fraternal Society of the Deaf a cessé d’exercer des opérations au Canada. renewed effective July 5, 1985, and the company is being wound up under the L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le 30 avril provisions of the Winding-up Act. 1996. Les polices ont soit été rachetées ou prises en charge par Croatian Fraternal Union of America. Northwestern National Life Insurance Company changed its name to ReliaStar La Nationale, Compagnie de Réassurance du Canada a cessé ses opérations sous Life Insurance Company effective August 1, 1996. la Loi sur les sociétés d’assurances,etareçu un certificat de prorogation en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, en date du 22 décembre 1994, sous la dénomination sociale 310071-5 CANADA INC. Norwich Union Fire Insurance Society Limited ceased transacting business in New England Insurance Company,auparavant New England Reinsurance Canada. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effective Corporation, a cessé d’exercer des affaires au Canada. Son passif canadien a été June 24, 1998. pris en charge par New England Reinsurance Corporation, auparavant Tower Insurance Company of Connecticut, le 1er janvier 1984. The Norwich Union Life Insurance Society ceased transacting business in Canada New England Mutual Life Insurance Company a cessé d’exercer des opérations au and transferred its Canadian policies to Norwich Union Life Insurance Canada. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le Company (Canada). The company’s order to insure in Canada risks was 1er novembre 1995. revoked effective September 30, 1997. Norwich Winterthur Reinsurance Corporation Limited changed its name to NW New England Reinsurance Corporation a changé son nom en celui de New Reinsurance Corporation Limited effective November 5, 1992. England Insurance Company àcompter du 29 février 1984. Nova Scotia General Insurance Company changed its name to Toronto Dominion New England Reinsurance Corporation a retiré son certificat d’enregistrement le General Insurance Company effective February 7, 1995. 31 décembre 1988 et tout son passif canadien a été prisencharge par The Hartford Fire Insurance Company. NRG London Reinsurance Company Limited: At the company’s request, its order New Rotterdam Insurance Company a modifié sa dénomination sociale à celle de to insure in Canada risks was revoked effective December 31, 1992. UAP-NewRotterdam Insurance Company N.V. à compter du 28 octobre 1997. NRG Victory Reinsurance Limited ceased transacting life insurance and accident Les obligations de The New Zealand Insurance Company Limited ayant été and sickness insurance in Canada effective April 1, 1992. transférées à la Christiania General Insurance Corporation, la compagnie a cessé d’être enregistrée à compter du 31 mars 1991. Old Republic Insurance Company: At the company’s request, the order to insure The Non-Marine Underwriters, Members of Lloyd’s, London, England a modifié in Canada risks of Old Republic Insurance Company was revoked effective sa dénomination sociale à celle de les Souscripteurs du Lloyd’s à compter du December 22, 1995. 1er octobre 1999. Old Republic Life Insurance Company ceased transacting business in Canada. The La Nord-américaine, compagnie d’assurance-vie et La Compagnie d’Assurance- company’s order to insure in Canada risks was revoked effective September 1, Vie Manufacturers ont été fusionnées et prorogées en une société mutuelle 1993. fonctionnant sous la dénomination sociale de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers le 1er janvier 1996. The Omaha Indemnity Company: At the company’s request, the order to insure in Norman Insurance Company Limited : Conformément à la demande de la Canada risks of The Omaha Indemnity Company was revoked effective compagnie, l’ordonnance portant garantie des risques au Canada par Norman January 25, 1994. Insurance Company Limited a été annulée le 31 décembre 1992. The Orion Insurance Company Limited changed its name to The Orion Insurance North American Benefit Association a modifié sa dénomination sociale à celle de Company PLC effective September 11, 1990. Woman’s Life Insurance Society àcompter du 1er janvier 1996. Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 55

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite) The Orion Insurance Company PLC: On October 27, 1994 the Superintendent of La North American Company for Property and Casualty a modifié sa Financial Institutions took control of The Orion Insurance Company PLC and dénomination sociale pour NAC Reinsurance Corporationau29juillet 1989. on February 10, 1995 the court ordered the winding-up of The Orion Insurance Company PLC under the provisions of the Winding Up Act,appointing the Superintendent as liquidator of the company. Deloitte & Touche Inc., acting as agent for the liquidator, is proceeding with the winding up of the company’s affairs. OTIP/RAEO Insurance Company Inc. changed its name to Everest Insurance The North American General Insurance Company : le certificat d’enregistrement a Company of Canada, effective December 31, 1996. été retiré le 15 décembre 1966 et la compagnie est maintenant en voie de liquidation en vertu des dispositions de la Loi sur les liquidations. Pacific Employers Insurance Company,having transferred its Canadian liabilities North American Life and Casualty Company achangé son nom en celui de Allianz to CIGNA Insurance Company of Canada, ceased to be registered effective Life Insurance Company of North America à compter du 31 mars 1993. October 27, 1993. Pafco International Insurance Company changed its name to Granite Insurance North American Reassurance Company a modifié sa dénomination sociale à celle Company effective June 25, 1991. de Swiss Re Life Company America à compter du 19 décembre 1996. Paragon Insurance Company of Canada changed its name to Laurentian Pacific Les obligations de North American Reinsurance Corporation ayant été transférées Insurance Company effective May 3, 1984. à la Société Canadienne de Réassurance, la compagnie a cessé d’être enregistrée à compter du 27 décembre 1991. The Patriot Life Insurance Company was the name assumed by Balboa Life Northumberland, Compagnie Générale d’Assurances a fusionné ses biens et Insurance Company to transact business in Canada. Effective January 9, 1992, opérations avec les biens et opérations de la Compagnie d’Assurances the company has been transacting business under its own name. Générales Strathcona le 31 août 1983; la compagnie fusionnée ou la compagnie prenant suite des opérations est la Northumberland, Compagnie Générale d’Assurances. The Penn Mutual Life Insurance Company ceased transacting business in Canada. Northumberland, Compagnie Générale d’Assurances : le certificat d’enregistre- The company’s order to insure in Canada risks was revoked effective July 9, ment n’a pas été renouvelé le 5 juillet 1985 et la compagnie est maintenant en 1999. voiedeliquidation en vertu des dispositions de la Loi sur les liquidations. Philadelphia Manufacturers Mutual Insurance Company amalgamated its property Northwestern National Life Insurance Company a modifié sa dénomination sociale and business with Arkwright-Boston Manufacturers Mutual Insurance à celle de Compagnie D’Assurance-Vie ReliaStar à compter du 1er août 1996. Company effective September 7, 1984, the continuing or combined company being Arkwright-Boston Manufacturers Mutual Insurance Company. The Phoenix Assurance Company Limited changed its name to the Phoenix Norwich Union Fire Insurance Society Limited a cessé d’exercer des opérations au Assurance Public Limited Company effective December 1, 1989. Canada. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le 24 juin 1998. Phoenix Assurance Company of Canada: An order was issued December 1, 1989, Norwich Winterthur Reinsurance Corporation Limited a changé son nom en celui whereby the property and business of Phoenix Assurance Company of Canada de NW Reinsurance Corporation Limited à compter du 5 novembre 1992. was to be wound up into the Dominion Insurance Corporation. Phoenix Assurance Public Limited Company,having transferred its Canadian Nova Scotia General Insurance Company a modifié sa dénomination sociale à liabilities to Sun Alliance Insurance Company, ceased to be registered effective celle de Toronto Dominion Compagnie d’Assurance Générale à compter du December 31, 1991. 7 février 1995. Phoenix Mutual Life Insurance Company changed its name to Phoenix Home Life NRG London Reinsurance Company Limited a cessé d’exercer des opérations au Mutual Insurance Company effective July 1, 1992. Canada et a cédé son passif canadien. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le 31 décembre 1992. Pitts Insurance Company’s certificate of registry was withdrawn effective NRG Victory Reinsurance Limited a cesser d’exercer des opérations d’assurance- October 19, 1981, and the company is being wound up under the provisions of vie et accidents et maladie à compter du 1er avril 1992. the Winding-up Act. Pohjola Insurance Company Ltd. (Vakuutusosakeyhtio Pohjola) changed its name The Omaha Indemnity Company : Conformément à la demande de la compagnie, to Pohjola Group Insurance Corporation effective August 31, 1998. l’ordonnance portant garantie des risques au Canada par The Omaha Indemnity Company a été annulée le 25 janvier 1994. Préservatrice Foncière T.I.A.R.D., having transferred its Canadian policies to The Orion Insurance Company Limited a changé son nom à The Orion Insurance National Reinsurance Company of Canada, ceased to be registered effective Company PLCàcompterdu11septembre 1990. January 1, 1988. La Préservatrice Société Anonyme d’Assurances contre les Accidents, l’Incendie The Orion Insurance Company PLC : le 27 octobre 1994, le surintendant des et les Risques Divers, having transferred all of its Canadian liabilities to institutions financières a pris le contrôle de The Orion Insurance Company PLC Préservatrice Foncière T.I.A.R.D., ceased transacting business in Canada et le 10 février 1995 la cour a demandé la liquidation de The Orion Insurance effective August 9, 1982. Company PLC sous les provisions de la Loi sur les liquidations, nommant le surintendant au titre de liquidateur de la société. Deloitte & Touche Inc., le mandataire du liquidateur, se chargedesprocédures de liquidation de la société. Primerica Life Insurance Company ceased transacting business in Canada and Les obligations de Pacific Employers Insurance Company ayant été transférées à transferred its Canadian policies to Primerica Life Insurance Company of CIGNA du Canada Compagnie d’assurance, la compagnie a cessé d’être Canada. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effective enregistrée à compter du 27 octobre 1993. August 19, 1994. Primmum Insurance Company changed its name to CT Direct Insurance Company Pafco Compagnie Internationale d’Assurances a changé son nom à Granite effective March 10, 1998. Compagnie d’Assurances à compter du 25 juin 1991. Principal Mutual Life Insurance Company changed its name to Principal Life Paragon, Compagnie d’Assurance du Canada a changé son nom en celui de la Insurance Company effective March 26, 1999. Laurentienne du Pacifique Compagnie d’Assurance à compter du 3 mai 1984. 56 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite) Protection Mutual Insurance Company,having amalgamated its property and La Patriote Compagnie d’Assurance-Vie est le nom adopté par La Balboa, business with that of Allendale Mutual Insurance Company and Arkwright compagnie d’assurance-vie pour exercer des affaires au Canada. Depuis le Mutual Insurance Company, pursuant to the laws of the United States of 9 janvier 1992, la compagnie utilise son propre nom pour exercer des affaires. America, ceased to be registered effective July 1, 1999. The foreigncompanies were continued to be registered as one mutual company under the name Factory Mutual Insurance Company, effective July 1, 1999. Prudasco Assurance Company amalgamated its property and business with that of The Penn Mutual Life Insurance Company a cessé d’exercer des opérations au General Accident Indemnity Company effective January 1, 1994, the continuing Canada. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le or combined company being General Accident Indemnity Company. 9 juillet 1999. Prudential Assurance Company of England Property and Casualty (Canada) Philadelphia Manufacturers Mutual Insurance Company a fusionné ses biens et changed its name to General Accident Indemnity Company effective August 31, opérations avec les biens et opérations de Arkwright-Boston Manufacturers 1993. Mutual Insurance Company le 7 septembre 1984; la compagnie fusionnée ou la compagnie prenant suite des opérations est Arkwright-Boston Manufacturers Mutual Insurance Company. The Prudential Group Assurance Company of England (Canada) changed its name La Phoenix Assurance Company Limited a modifié sa raison sociale le to Sun Life of Canada Group Assurance Company effective March 31, 1995. 1er décembre 1989 et se nomme maintenant Phoenix Assurance Public Limited Company. The Prudential Life Assurance Company of England (Canada) and The Mutual Les obligations de Phoenix Assurance Public Limited Company ayant été Life Assurance Company of Canada amalgamated and were continued as one transférées à Sun Alliance Compagnie d’Assurance, la compagnie a cessé d’être mutual company under the name The Mutual Life Assurance Company of enregistrée à compter du 31 décembre 1991. Canada effective April 1, 1995. Prudential of America General Insurance Company (Canada) changed its name to Les biens et opérations de la Phoenix Compagnie d’Assurance du Canada ont été Liberty Insurance Company of Canada, effective January 1, 1997. cédés à La Dominion Corporation d’Assurance et un décret a été émis en vertu de la Loi sur les liquidations pour La Dominion Corporation d’Assurance au 1er décembre 1989. Prudential Reinsurance Company (of America) changed its name to Everest Phoenix Mutual Life Insurance Company achangé son nom en celui de Phoenix Reinsurance Company effective May 21, 1996. Home Life Mutual Insurance Company àcompter du 1er juillet 1992. QBE Insurance Limited, having disposed of its liabilities in Canada, ceased to be Pitts Compagnie d’Assurance : le certificat d’enregistrement a été retiré le registered effective March 31, 1987. 19 octobre 1981 et la compagnie est maintenant en voie de liquidation en vertu des dispositions de la Loi sur les liquidations. The Reinsurance Corporation of New York changed its name to The Insurance Préservatrice Foncière T.I.A.R.D. a cessé d’exercer des opérations au Canada et Corporation of New York effective January 31, 1997. tout son passif canadien a été prisencharge par La Nationale, Compagnie de Réassurance du Canada le 1er janvier 1988. Retail Lumbermen’s Inter-Insurance Exchangehaving disposed of its liabilities in La Préservatrice Société Anonyme d’Assurances contre les Accidents, l’Incendie Canada ceased to be registered as at March 31, 1985. et les Risques Divers a cessé d’exercer des opérations au Canada le 9 août 1982; son passif canadien a été pris en charge par la Préservatrice Foncière T.I.A.R.D. Royal Exchange Assurance of America Inc. changed its name to Fortress Primmum Compagnie D’Assurance a modifié sa dénomination sociale à celle de Insurance Company of America effective December 15, 1992. CT assurance directe inc. à compter du 10 mars 1998. Royal Insurance Company of Canada amalgamated its property and business with Principal Mutual Life Insurance Company a modifié sa dénomination sociale à that of Sun Alliance Insurance Company effective January 1, 1994, the celle de Compagnie d’assurance-vie Principal à compter du 26 mars 1999. continuing or combined company being Royal Insurance Company of Canada. Royal Insurance Company of Canada changed its name to Royal & Sun Alliance Protection Mutual Insurance Company a fusionné ses entreprise avec ceux de Insurance Company of Canada effective March 23, 1998. Allendale Mututal Insurance Company et ceux de Arkwright Mututal Insurance Company,etenvertudesloisdesÉtats-Unis d’Amérique, son certificat d’enregistrement a été retiré le 1er juillet 1999. Les sociétés fusionnées ont été prorogées en une société mutuelle fonctionnant sous la dénomination Factory Mutual Insurance Company,1er juillet 1999. Royal Life Insurance Company of Canada ceased transacting business in Canada La Prudasco, Compagnie d’Assurance a fusionné ses biens et son entreprise avec and transferred all of its policies to Royal Life Insurance Company of Canada ceux de la Général Accident Indemnité Compagnie d’Assurance à compter du Limited, effective December 31, 1994. Royal Life Insurance Company of 1er janvier 1994, la compagnie issue de la fusion étant la Général Accident Canada’s order to commence and carry on business was revoked effective Indemnité Compagnie d’Assurance. December 31, 1994 and its property was amalgamated with that of Royal Insurance Company of Canada, the continuing company being Royal Insurance Company of Canada. Royal Life Insurance Company of Canada Limited changed its name to Royal & Prudential Reinsurance Company (of America) a modifié sa dénomination sociale Sun Alliance Life Insurance Company of Canada effective March 23, 1998. à celle de Everest Reinsurance Company depuis le 21 mai 1996. Royal Life Insurance Limited ceased transacting business in Canada and disposed Prudentielle d’Amérique, Compagnie d’Assurance Générale (Canada) a modifié of its liabilities in Canada. The company’s order to insure in Canada risks was sa dénomination sociale à celle de Compagnie d’Assurance Liberté du Canada, revoked effective November 24, 1992. àcompter du 1er janvier 1997. Royal Reinsurance Company Limited, having transferred its Canadian liabilities to La Prudentielle d’Angleterre, Compagnie d’Assurance Générale (Canada) a Royal Insurance Company of Canada, ceased to be registered effective changé sa dénomination sociale pour Général Accident Indemnité Compagnie December 31, 1993. d’Assurance du 31 août 1993. RoyNat Guarantee Corporation: At the company’s request, the certificate of La Prudentielle d’Angleterre Compagnie d’Assurance Collective (Canada) a registry of RoyNat Guarantee Corporation was discontinued effective June 21, modifié sa dénomination sociale à celle de Sun Life du Canada, compagnie 1984. d’assurance groupeàcompter du 31 mars 1995. Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 57

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite) SAFECO Life Insurance Company,having disposed of its liabilities in Canada, La Prudentielle d’Angleterre, Compagnie d’assurance-vie (Canada) et La Mutuelle ceased to be registered as at December 20, 1991. du Canada, compagnie d’assurance sur la vie ont été fusionnées et prorogées en une société mutuelle fonctionnant sous la dénomination sociale de La Mutuelle du Canada, compagnie d’assurance sur la vie le 1er avril 1995. SAFR Société Anonyme Française de Réassurances changed its name to SAFR QBE Insurance Limited a cédé son passif canadien. Le certificat d’enregistrement effective April 7, 1998. de la compagnie n’a pas été renouvelé au 31 mars 1987. SAFR changed its name to SAFR PartnerRe effective January 26, 2000. The Reinsurance Corporation of New York a modifié sa dénomination sociale à celle de The Insurance Corporation of New York à compter du 31 janvier 1997. SCOR Reinsurance Company of Canada amalgamated its property and business Retail Lumbermen’s Inter-Insurance Exchange a cédé son passif canadien. Le with that of two non-insurance entities, SCORFIN Inc. and SCOR Services certificat d’enregistrement de la compagnie n’a pas été renouvelé au 31 mars Canada Inc., effective December 31, 1995, the continuing or combined 1985. company being SCOR Canada Reinsurance Company. The Scottish Dominion Insurance Company Limited ceased transacting business Royal Exchange Assurance of America Inc. a changé sa dénomination sociale in Canada. The company’s order to insure in Canada risks was revoked pour Compagnie d’assurance Forteresse d’Amériqueàcompter du 15 décembre effective December 1, 1998. 1992. Seaboard Surety Company: At the company’s request, the order to insure in Royal Life Insurance Limited a cessé d’exercer des opérations au Canada et a cédé Canada risks of Seaboard Surety Company was revoked effective June 13, son passif canadien. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été 1995. annulée le 24 novembre 1992. Seaboard Surety Company of Canada amalgamated its property and business with Les obligations de Royal Reinsurance Company Limited ayant été transférées à La that of Northern Indemnity, Inc. effective January 1, 2000, the continuing com- Royale du Canada, Compagnie d’Assurance, la compagnie a cessé d’être pany being Northern Indemnity,Inc. enregistrée à compter du 31 décembre 1993. Security National Insurance Company changed the french version of its name to La Royale du Canada, Compagnie d’Assurance a fusionné ses biens et opérations La Sécurité Nationale Compagnie d’Assurance, effective October 21, 1997. avec les biens et opérations de Sun Alliance Compagnie d’Assurance le 1er janvier 1994; la compagnie résultant de cette fusion est La Royale du Canada, Compagnie d’Assurance. Security National Insurance Company changed the french version of its name to La Royale du Canada, Compagnie d’Assurance a modifié sa dénomination sociale Sécurité Nationale Compagnie d’Assurance, effective April 6, 1998. à celle de Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances à compter du 23 mars 1998. Skandia Canada Reinsurance Company changed its name to Odyssey Reinsurance La Royale Vie du Canada, Compagnie d’Assurance a cessé d’exercer des Company of Canada, effective November 5, 1996. opérations au Canada et tout son passif canadien a été prisencharge par La Royale Vie du Canada, compagnie d’assurance limitée. L’ordonnance de fonctionnement de La Royale Vie du Canada, Compagnie d’Assurance a été annulée le 31 décembre 1994, et ses biens ont été fusionné avec ceux de La Royale du Canada, Compagnie d’Assurance, la compagnie issue de la fusion étant La Royale du Canada, Compagnie d’Assurance. Skandia Group Insurance Company Ltd. changed the name under which it insures La Royale Vie du Canada, compagnie d’assurance limitée a modifié sa risks in Canada to Skandia Insurance Company Ltd. effective December 23, dénomination sociale à celle de Royal & Sun Alliance du Canada, société 1993. d’assurance-vie à compter du 23 mars 1998. Skandia Insurance Company changed its name in English to Skandia Group Insur- SAFECO Life Insurance Company a cédé son passif canadien. Le certificat ance Company Ltd. effective December 17, 1990. d’enregistrement de la compagnie a été retiré le 20 décembre 1991. Skandia International Insurance Corporation ceased transacting business in Can- SAFR a modifié sa dénomination sociale à celle de SAFR PartnerRe à compter du ada. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effective 26 janvier 2000. March 31, 2000. Société Anonyme Française de Réassurances changed its name to SAFR Société SAFR Société Anonyme Française de Réassurances a modifié sa dénomination Anonyme Française de Réassurances effective June 17, 1996. sociale à celle de SAFR à compter du 7 avril 1998. Société Commerciale de Réassurance: At the company’s request, the order to SCOR Compagnie de Réassurance du Canada a fusionné ses biens et son insure in Canada risks of Société Commerciale de Réassurance was revoked entreprise avec SCORFIN Inc. et Les Services SCOR Canada Inc., à compter du effective December 24, 1992. 31 décembre 1995. La compagnie issue de la fusion est SCOR Canada Compagnie de Réassurance. Société de Réassurance des Assurances Mutuelles Agricoles ceased transacting The Scottish Dominion Insurance Company Limited a cessé d’exercer des business in Canada. The company’s order to insure in Canada risks was opérations au Canada. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a revoked effective July 8, 1998. été annulée le 1er décembre 1998. Sphere Reinsurance Company of Canada changed its name to Chequers Insurance Seaboard Surety Company : Conformément à la demande de la compagnie, Company effective August 31, 1989. l’ordonnance portant garantie des risques au Canada par Seaboard Surety Company a été annulée le 13 juin 1995. The Stanstead and Sherbrooke Insurance Company amalgamated its property and La Sécurité Nationale Compagnie d’Assurances a modifié la version française de business with that of The Canada Accident and Fire Assurance Company,and sa dénomination sociale à celle de La Sécurité Nationale Compagnie that of Commercial Union Assurance Company of Canada effective January 1, d’Assurance à compter du 21 octobre 1997. 1989, the continuing or combined company being Commercial Union Assurance Company of Canada. State Mutual Life Assurance Company of America changed its name to First La Sécurité Nationale Compagnie d’Assurance a modifié la version française de sa Allmerica Financial Life Insurance Company effective May 13, 1996. dénominationa sociale à celle de Sécurité Nationale Compagnie d’Assurance à compter du 6 avril 1998. 58 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite) Stonewall Insurance Company,having disposed of its liabilities in Canada, ceased La Sécurité, Compagnie d’Assurances générales du Canada, après l’adoption to be registered effective March 27, 1990. d’une Loi d’intérêt privé par le Sénat du Canada, a été prorogée par lettres patentes de continuation comme compagnie d’assurance de la province de Québec, en date du 1er décembre 1994, sous la dénomination sociale de LA SÉCURITÉ, COMPAGNIE D’ASSURANCES GÉNÉRALES DU CANADA INC. Storebrand International Insurance A/S changed its name to UNI Storebrand Skandia Canada Compagnie de Réassurance a modifié sa dénomination sociale à International Insurance A/S effective October 30, 1991. celle de Odyssey, société canadienne de réassurance, à compter du 5 novembre 1996. Storebrand Reinsurance Company Ltd. changed its name to Storebrand Skandia Groupe, Société Anonyme d’Assurances a changé sa raison sociale au International Insurance A/S effective March 12, 1991. Canada à Skandia Société Anonyme d’Assurances à compter du 23 décembre 1993. The Strathcona General Insurance Company amalgamated its property and Skandia Insurance Company a modifié sa dénomination sociale à Skandia Groupe, business with that of Northumberland General Insurance Company effective Société Anonyme d’Assurances, le 17 décembre 1990. August 31, 1983, the continuing or combined company being Northumberland General Insurance Company; Sun Alliance and London Assurance Company Limited, having transferred its Skandia International Insurance Corporation a cessé d’exercer des opérations au Canadian liabilities to Sun Alliance and London Assurance Company (Canada), Canada. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le had its order to insure in Canada risks revoked effective November 24, 1992. 31 mars 2000. Sun Alliance and London Assurance Company (Canada) changed its name to TBD Société Anonyme Française de Réassurances a modifié sa dénomination sociale à Life Insurance Company effective August 1, 1995. celle de SAFR Société Anonyme Française de Réassurances à compter du 17 juin 1996. Sun Alliance Insurance Company amalgamated its property and business with that Société D’Assurance-Crédit Industriel : le certificat d’enregistrement a été retiré le of Royal Insurance Company of Canada effective January 1, 1994, the 5 octobre 1984, conformément à la demande de la compagnie. continuing or combined company being Royal Insurance Company of Canada. Swiss Re Life Company America changed its name to Swiss Re Life & Health La Société d’Assurance-Vie Norwich Union a cessé d’exercer des opérations au America Inc. effective January 27, 1998. Canada et son passif canadien a été prisencharge par Norwich Union du Canada, Compagnie d’assurance-vie. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le 30 septembre 1997. Swiss Re Life Canada changed its name to Swiss Re Life & Health Canada Société Canadienne de Réassurance a modifié sa dénomination sociale à celle de effective June 2, 1997. Compagnie Suisse de Réassurance Canada à compter du 5 juin 1995. Swiss Union General Insurance Company Limited ceased transacting business in Société Commerciale de Réassurance : Conformément à la demande de la Canada. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effective compagnie, l’ordonnance portant garantie des risques au Canada par Société December 22, 1998. Commerciale de Réassurance a été annulée le 24 décembre 1992. Switzerland General Insurance Company, Limited: At the company’s request, the Société de Réassurance des Assurances Mutuelles Agricoles a cessé d’exercer des order to insure in Canada risks of Switzerland General Insurance Company, opérations au Canada. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a Limited was revoked effective November 21, 1995. été annulée le 8 juillet 1998. Symons General Insurance Company changed its name to Pafco International State Mutual Life Assurance Company of America a modifié sa dénomination Insurance Company effective December 22, 1988. sociale à celle de First Allmerica Financial Life Insurance Company àcompter du 13 mai 1996. Taisho Marine and Fire Insurance Company, Limited changed its name to Mitsui Stonewall Insurance Company aaliénésonpassif au Canada et n’est plus Marine and Fire Insurance Company, Limited effective May 2, 1991. enregistrée depuis le 27 mars 1990. Teachers Insurance and Annuity Association of America ceased transacting Storebrand International Insurance A/S a changé son nom en celui de UNI business in Canada and transferred its Canadian policies to Sun Life Assurance Storebrand International Insurance A/S à compter du 30 octobre 1991. Company of Canada. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effective April 6, 1998. TIG Reinsurance Company changed its name to Odyssey America Reinsurance Storebrand Reinsurance Company Ltd. a changé son nom en celui de Storebrand Corporation effective January 26, 2000. International Insurance A/S à compter du 12 mars 1991. Toa-Re Insurance Company of America changed its name to The Toa Reinsurance Suisse de Réassurance Vie Canada a modifié sa dénomination sociale à celle de Company of America effective August 16, 1999. Suisse de Réassurances Vie et Santé Canada à compter du 2 juin 1997. Toro Assicurazioni S.P.A., having transferred its Canadian liabilities to Sun Sun Alliance and London Assurance Company Limited a cessé d’exercer des Alliance Insurance Company, ceased to be registered effective December 21, opérations au Canada et tout son passif canadien a été prisencharge par La 1990. Compagnie d’Assurance Sun Alliance & London (Canada). L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le 24 novembre 1992. Toronto General Insurance Company amalgamated its property and business with Sun Alliance Compagnie d’Assurance a fusionné ses biens et opérations avec les that of Canadian General Insurance Company effective January 1, 1994, the biens et opérations de La Royale du Canada, Compagnie d’Assurance le continuing or combined company being Canadian General Insurance Company. 1er janvier 1994; la compagnie résultant de cette fusion est La Royale du Canada, Compagnie d’Assurance. Tower Insurance Company of Connecticut changed its name to New England Swiss Re Life Company America a modifié sa dénomination sociale à celle de Reinsurance Corporation effective February 29, 1984. Swiss Re Life & Health America Inc. à compter du 27 janvier 1998. Traders General Insurance Company amalgamated its property and business with Switzerland General Insurance Company, Limited : Conformément à la demande that of GAN Canada Insurance Company effective December 31, 1999, the de la société, l’ordonnance portant garantie des risques au Canada par continuing company being Traders General Insurance Company. Switzerland General Insurance Company, Limited a été annulée le 21 novembre 1995. Le 29 avril 2000 Supplément à la Gazette du Canada, Sociétés d’assurances 59

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite) Trafalgar Insurance Company of Canada amalgamated its property and business Symons Compagnie d’Assurances Générales a changé son nom en Pafco with that of The Canadian Commerce Insurance Company effective January 1, Compagnie Internationale d’Assurances à compter du 22 décembre 1988. 1993, the continuing or combined company being Trafalgar Insurance Company of Canada. Trafalgar Insurance Public Limited Company,having transferred its Canadian Taisho Marine and Fire Insurance Company, Limited a changé son nom à Mitsui liabilities to Trafalgar Insurance Company of Canada, ceased to be registered Marine and Fire Insurance Company, Limited à compter du 2 mai 1991. effective December 31, 1986. Transamerica Insurance Company changed the name under which it insures risks Teachers Insurance and Annuity Association of America a cessé d’exercer des in Canada to TIG Insurance Company effective December 29, 1993. opérations au Canada et tout son passif canadien a été prisencharge par Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le 6 avril 1998. Transamerica Occidental Life Insurance Company ceased transacting business in The Toa-Re Insurance Company of America a modifié sa dénomination sociale à Canada and transferred its Canadian policies to Transamerica Life Insurance celle de The Toa Reinsurance Company of America à compter du 16 août 1999. Company of Canada. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effective April 12, 1995. Transport Indemnity Company changed its name to Mission American Insurance Les obligations au Canada de Toro Assicurazioni S.P.A. ayant été transférées à Company effective June 16, 1986. Sun Alliance Compagnie d’Assurance, la compagnie a cessé d’être enregistrée àcompter du 21 décembre 1990. Transport Insurance Company: At the company’s request, the order to insure in Tower Insurance Company of Connecticut a changé son nom en celui de New Canada risks of Transport Insurance Company was revoked effective December England Reinsurance Corporation à compter du 29 février 1984. 31, 1994. Travelers Indemnity Company of Canada changed its name to Zurich Indemnity Trafalgar Insurance Public Limited Company a cessé d’exercer des opérations au Company of Canada effective February 9, 1989. Canada le 31 décembre 1986; son passif canadien a été prisencharge par la Compagnie d’Assurance Trafalgar du Canada. Truck Insurance Exchange: At the request of the company, the order to insure in Transamerica Insurance Company achangé sa raison sociale au Canada à Société Canada risks of Truck Insurance Exchange was revoked effective December 21, d’Assurance TIG à compter du 29 décembre 1993. 1992. Trygg-Hansa Reinsurance Company of Canada changed its name to Suecia Transport Indemnity Company achangé son nom en celui de Mission American Reinsurance Company effective January 21, 2000. Insurance Company àcompter du 16 juin 1986. Underwriters National Assurance Company’s certificate of registry was withdrawn Transport Insurance Company : Conformément à la demande de la compagnie, effective December 29, 1976. The company’s business in Canada, which was l’ordonnance portant garantie des risques au Canada par Transport Insurance being continued under a compromise arrangement sanctioned by the Supreme Company a été annulée le 31 décembre 1994. Court of Ontario, was transferred to Life Investors Insurance Company of America effective July 31, 1991. Uni Storebrand International Insurance A/S ceased transacting business in Travelers du Canada, Compagnie d’Indemnité a changé son nom en celui de Canada. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effective Zurich Du Canada, Compagnie d’Indemnité à compter du 9 février 1989. April 8, 1997. Unigard Mutual Insurance Company changed its name to Unigard Security Truck Insurance Exchange : Conformément à la demande de la compagnie, Insurance Company effective December 20, 1984. l’ordonnance portant garantie des risques au Canada par Truck Insurance Exchange a été annulée le 21 décembre 1992. Union Reinsurance Company: At the company’s request, the order to insure in Trygg-Hansa Reinsurance Company of Canada a modifié sa dénomination sociale Canada risks of Union Reinsurance Company was revoked effective June 15, à celle de Compagnie de réassurance Suecia à compter du 21 janvier 2000. 1994. Unione Italiana di Riassicurazione S.p.A. changed its name to Swiss Re Italia Underwriters National Assurance Company : le certificat d’enregistrement a été S.p.A. effective August 28, 1998. retiré le 20 décembre 1976. Les affaires au Canada qui avaient été continuées selon une proposition de concordat sanctionnée par la Cour Suprême d’Ontario ont été transférées à Life Investors Insurance Company of America le 31 juillet 1991. United Canada Insurance Company’s certificate of registry was not renewed Uni Storebrand International Insurance A/S a cessé d’exercer des opérations au effective March 1, 1986, and the company is being wound-up under the Canada. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le provisions of the Winding-up Act. 8 avril 1997. United States Fire Insurance Company: At the request of the company, the order Unigard Mutual Insurance Company achangé son nom en celui de Unigard to insure in Canada risks of United States Fire Insurance Company was revoked Security Insurance Company àcompter du 20 décembre 1984. effective December 10, 1992. United Transportation Union Insurance Association ceased transacting business in Union Reinsurance Company : Conformément à la demande de la compagnie, Canada. The society’s order to insure in Canada risks was revoked effective l’ordonnance portant garantie des risques au Canada par Union Reinsurance March 14, 1995. Company a été annulée le 15 juin 1994. The Unity Fire and General Insurance Company ceased transacting business in Union Suisse Compagnie Générale d’Assurances a cessé d’exercer des opérations Canada. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effective au Canada. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée December 31, 1998. le 22 décembre 1998. UNUM Life Insurance Company changed its name to UNUM Life Insurance Unione Italiana di Riassicurazione S.p.A. a modifié sa dénomination sociale à Company of America as at December 31, 1991. celle de Swiss Re Italia S.p.A. à compter du 28 août 1998. USF&G Insurance Company of Canada amalgamated its property and business United States Fire Insurance Company : Conformément à la demande de la with that of Canadian General Insurance Company effective June 30, 1990, the compagnie, l’ordonnance portant garantie des risques au Canada par United continuing or combined company being Canadian General Insurance Company. States Fire Insurance Company a été annulée le 10 décembre 1992. 60 Supplement to the Canada Gazette, Insurance Companies April 29, 2000

NOTE (A)—Continued REMARQUE (A)—(suite) US International Reinsurance Company ceased transacting business in Canada. United Transportation Union Insurance Association a cessé d’exercer des The company’s order to insure in Canada risks was revoked effective opérations au Canada. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a October 8, 1997. été annulée le 14 mars 1995. Victoria Insurance Company of Canada amalgamated its property and business Unity Fire and General Insurance Company a cessé d’exercer des opérations au with that of Traders General Insurance Company effective January 1, 1996, the Canada. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le continuing or combined company being Traders General Insurance Company. 31 décembre 1998. The Victory Reinsurance Company Limited changed its name to NRG Victory L’UNUM Compagnie d’Assurance-vie a changé son nom en celui de L’UNUM Reinsurance Limited effective December 18, 1991. d’Amérique, Compagnie d’Assurance-vie à compter du 31 décembre 1991. Warner Reciprocal Insurers, having disposed of its liabilities in Canada, ceased to US International Reinsurance Company a cessé d’exercer des opérations au be registered effective March 31, 1986. Canada. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le 8 octobre 1997. The Wawanesa Mutual Life Insurance Company changed its name to The The Victory Reinsurance Company Limited a changé son nom en celui de NRG Wawanesa Life Insurance Company effective at October 1, 1993. Victory Reinsurance Limited à compter du 18 décembre 1991. Wellington Insurance Company changed its French name to Compagnie Warner Reciprocal Insurers a cédé son passif canadien. Le certificat d’Assurance Wellington effective August 11, 1986. d’enregistrement de la compagnie n’a pas été renouvelé au 31 mars 1986. Western General Mutual Insurance Company amalgamated its property and Western General Mutual Insurance Company a fusionné ses biens et son business with that of Economical Mutual Insurance Company effective entreprise avec Economical, Compagnie Mutuelle d’Assurance, à compter du January 1, 1997, the continuing company being Economical Mutual Insurance 1er janvier 1997. La compagnie issue de la fusion est Economical, Compagnie Company. Mutuelle d’Assurance. Winterthur Reinsurance Corporation of America ceased transacting business in Winterthur Reinsurance Corporation of America a cessé d’exercer des opérations Canada. The company’s order to insure in Canada risks was revoked effective au Canada. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée December 22, 1999. le 22 décembre 1999. Woodmen of the World Life Insurance Society ceased transacting business in Woodmen of the World Life Insurance Society a cessé d’exercer des opérations au Canada. The society’s order to insure in Canada risks was revoked effective Canada. L’ordonnance portant garantie des risques au Canada a été annulée le December 1, 1994. 1er décembre 1994. The Workmen’s Circle ceased transacting business in Canada. The society’s order The Workmen’s Circle a cessé d’exercer des opérations au Canada. L’ordonnance to insure in Canada risks was revoked effective December 31, 1996. portant garantie des risques au Canada a été annulée le 31 décembre 1996. Zurich Indemnity Company of Canada changed its name to Peopleplus Insurance Zurich du Canada, Compagnie d’Indemnité a modifié sa dénomination sociale à Company effective February 1, 1999. celle de Omnimonde, Compagnie d’assurances à compter du 1er février 1999. Zurich Life Insurance Company of Canada and its wholly-owned subsidiary, Zurich du Canada Compagnie d’Assurance-Vie et sa filiale en propriété exclusive, Zurich Life & Health Insurance Company of Canada, amalgamated and were Zurich du Canada, Compagnie d’Assurance-Vie & Santé, ont été fusionnées et continued as one company under the name Zurich Life Insurance Company of prorogées en une société fonctionnant sous la dénomination sociale de Zurich Canada effective January 1, 1993. du Canada Compagnie d’Assurance-Vie le 1er janvier 1993. NOTE (B)— REMARQUE (B)— Additional classes referred to in classes of insurance for which registered are as Les catégories additionnelles dont il est question dans les catégories d’affaires follows— d’assurance enregistrées sont comme il suit : 1. Civil Commotion Insurance 1. L’assurance contre l’agitation civile 2. Earthquake Insurance 2. L’assurance contre les tremblements de terre 3. Falling Aircraft Insurance 3. L’assurance contre la chute d’aéronefs 4. Hail Insurance 4. L’assurance contre la grêle 5. Impact by Vehicles Insurance 5. L’assurance contre l’impact de véhicules 6. Limited or Inherent Explosion Insurance 6. L’assurance contre les explosions rattachables à l’affectation du risque 7. Sprinkler Leakage Insurance 7. L’assurance contre le coulage des extincteurs automatiques 8. Water Damage Insurance 8. L’assurance contre les dégâts des eaux 9. Weather Insurance 9. L’assurance contre les intempéries 10. Windstorm Insurance 10. L’assurance contre les tempêtes de vent and are limited to the insurance of the same property as is insured against the risk et sont limitées à l’assurance des mêmes biens qui sont assurés contre l’incendie of fire under a policy of the company. en vertu d’une police de la compagnie. Limited Personal Accident Insurance means Personal Accident Insurance, L’expression « accidents corporels restreints » désigne l’assurance accident des provided in connection with a policy of automobile insurance insuring against personnes qui est fournie de concert avec une police d’assurance automobile liability for bodily injuries, limited to expenses incurred arising from bodily assurant la responsabilité des blessures corporelles, limitée aux dépenses faites injuries suffered by driver and passengers and resulting from the ownership or en conséquence de blessures corporelles subies par le conducteur et les operation of an automobile. passagers, qui découle de la propriété ou du fonctionnement d’une automobile. OFFICE OF THE SUPERINTENDENT BUREAU DU SURINTENDANT OF FINANCIAL INSTITUTIONS, John R. Palmer DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES, Le surintendant OTTAWA. Superintendent OTTAWA. John R. Palmer © Her Majesty the Queen in Right of Canada, represented by the ©SaMajesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le Minister of Public Works and Government Services, 2000 ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, 2000 Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2000 If undelivered, return COVER ONLY to: Canadian Government Publishing Public Works and Government Services Canada Ottawa, Canada K1A 0S9

En cas de non-livraison, retourner cette COUVERTURE SEULEMENT à : Les Éditions du gouvernement du Canada Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Ottawa, Canada K1A 0S9

Available from Canadian Government Publishing En vente : Les Éditions du gouvernement du Canada Public Works and Government Services Canada Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Ottawa, Canada K1A 0S9 Ottawa, Canada K1A 0S9