The Royal Gazette Gazette royale

Fredericton Nouveau-Brunswick

ISSN 1714-9428

Vol. 175 Wednesday, March 22, 2017 / Le mercredi 22 mars 2017 295 Notice to Readers Avis aux lecteurs

The Royal Gazette is officially published on-line. La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne. Except for formatting, documents are published in The Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans Royal Gazette as submitted. la Gazette royale comme soumis. Material submitted for publication must be received by Les documents à publier doivent parvenir au coordonna- the Royal Gazette coordinator no later than noon, at least teur de la Gazette royale, à midi, au moins 7 jours ou- 7 working days prior to Wednesday’s publication. vrables avant le mercredi de publication. En cas de jour However, when there is a public holiday, please contact férié, veuillez communiquer avec le coordonnateur. the coordinator.

Proclamations Proclamations

PROCLAMATION PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2016-312, I declare that sections Conformément au décret en conseil 2016-312, je déclare le 122, 123, 158, subparagraphs 159(a)(i) and (ii) and subpara- 30 décembre 2016 date d’entrée en vigueur des articles 122, graph 194(a)(xxvi) of An Act to Amend the Securities Act, chap- 123 et 158, des sous-alinéas 159a)(i) et (ii) et du sous-alinéa ter 38 of the Acts of New Brunswick, 2007, come into force on 194a)(xxvi) de la Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobi- December 30, 2016. lières, chapitre 38 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007. This Proclamation is given under La présente proclamation est faite my hand and the Great Seal of the sous mon seing et sous le grand Province at Fredericton on Decem- sceau de la province, à Fredericton, ber 15, 2016. le 15 décembre 2016.

Serge Rousselle, Q.C. Jocelyne Roy Vienneau Le procureur général, La lieutenante-gouverneure, Attorney General Lieutenant-Governor Serge Rousselle, c.r. Jocelyne Roy Vienneau

______The Royal Gazette — March 22, 2017 296 Gazette royale — 22 mars 2017

PROCLAMATION PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2016-314, I declare that subsec- Conformément au décret en conseil 2016-314, je déclare le tion 1(10) as it relates to section 43.1, and paragraph 1(11)(c) of 31 décembre 2016 date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(10), An Act Respecting Official Languages, chapter 38 of the Acts of qui se rapporte à l’article 43.1, et de l’alinéa 1(11)c) de la Loi New Brunswick, 2013, come into force on December 31, 2016. relative aux langues officielles, chapitre 38 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013. This Proclamation is given under La présente proclamation est faite my hand and the Great Seal of the sous mon seing et sous le grand Province at Fredericton on Decem- sceau de la province, à Fredericton, ber 15, 2016. le 15 décembre 2016.

Serge Rousselle, Q.C. Jocelyne Roy Vienneau Le procureur général, La lieutenante-gouverneure, Attorney General Lieutenant-Governor Serge Rousselle, c.r. Jocelyne Roy Vienneau

Orders in Council Décrets en conseil

FEBRUARY 9, 2017 LE 9 FÉVRIER 2017 2017-25 2017-25 Under section 12 of the Public Works Act, the Lieutenant- En vertu de l’article 12 de la Loi sur les travaux publics, le Governor in Council gives approval for the Minister of Trans- lieutenant-gouverneur en conseil autorise le ministre des Trans- portation and Infrastructure to convey the property described in ports et de l’Infrastructure à céder à Forrock Construction Ltd., Attachment “A” hereto attached, known as surplus property off de Miramichi (Nouveau-Brunswick), en contrepartie de Manse Street, Miramichi, New Brunswick, to Forrock Con- 16 240 $, le bien désigné à l’annexe « A » ci-jointe, connu struction Ltd., Miramichi, New Brunswick, for the purchase comme bien excédentaire, situé à l’écart de la rue Manse, à price of $16,240. Miramichi, au Nouveau-Brunswick.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

To obtain a complete copy, please refer to the Executive Pour recevoir un exemplaire au complet, veuillez Council Office Website for Orders in Council. consulter le site Web du bureau du Conseil exécutif.

______

FEBRUARY 9, 2017 LE 9 FÉVRIER 2017 2017-30 2017-30 Under subsection 2(1) of the Municipal Capital Borrowing Act, En vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur les emprunts de capi- the Lieutenant-Governor in Council appoints Thomas Anthony taux par les municipalités, le lieutenant-gouverneur en conseil Weber, Fredericton, New Brunswick, as vice-chairman of the nomme Thomas Anthony Weber, de Fredericton (Nouveau- Municipal Capital Borrowing Board, effective February 9, Brunswick), vice-président de la Commission des emprunts de 2017. capitaux par les municipalités, à compter du 9 février 2017.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

______

FEBRUARY 9, 2017 LE 9 FÉVRIER 2017 2017-31 2017-31 Under paragraph 4(3)(b) and subsection 6(5) of the Apprentice- En vertu de l’alinéa 4(3)b) et du paragraphe 6(5) de la Loi sur ship and Occupational Certification Act, the Lieutenant- l’apprentissage et la certification professionnelle, le lieutenant- Governor in Council appoints Debra Romero, Ripples, New gouverneur en conseil nomme Debra Romero, de Ripples Brunswick, as Chairperson of the Apprenticeship and Occupa- (Nouveau-Brunswick), présidente de la Commission de l’ap- tional Certification Board, for a term of three years, effective prentissage et de la certification professionnelle, pour un man- February 9, 2017. dat de trois ans, à compter du 9 février 2017.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

______The Royal Gazette — March 22, 2017 297 Gazette royale — 22 mars 2017

FEBRUARY 9, 2017 LE 9 FÉVRIER 2017 2017-32 2017-32 Under section 12 of the Public Works Act, the Lieutenant- En vertu de l’article 12 de la Loi sur les travaux publics, le Governor in Council gives approval for the Minister of Trans- lieutenant-gouverneur en conseil autorise le ministre des Trans- portation and Infrastructure to convey the property described in ports et de l’Infrastructure à céder à Zio’s Pizza Kitchen Ltd., de Schedule “A” hereto attached, known as surplus property lo- (Nouveau-Brunswick), en contrepartie de 161 000 $, cated on Mountain Road, Moncton, New Brunswick, and le bien désigné à l’annexe « A » ci-jointe, connu comme bien Church Street, Moncton, New Brunswick, to Zio’s Pizza excédentaire, situé chemin Mountain, à Moncton, au Nouveau- Kitchen Ltd., Moncton, New Brunswick, for the purchase price Brunswick, et rue Church, à Moncton, au Nouveau-Brunswick. of $161,000.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

To obtain a complete copy, please refer to the Executive Pour recevoir un exemplaire au complet, veuillez Council Office Website for Orders in Council. consulter le site Web du bureau du Conseil exécutif.

______

FEBRUARY 9, 2017 LE 9 FÉVRIER 2017 2017-33 2017-33 Under section 12 of the Public Works Act, the Lieutenant- En vertu de l’article 12 de la Loi sur les travaux publics, le Governor in Council gives approval for the Minister of Trans- lieutenant-gouverneur en conseil autorise le ministre des Trans- portation and Infrastructure to convey property known as the ports et de l’Infrastructure à céder à EHS Corporation, de former Steeves Property (PID 01014042), Bingham Drive, Surrey (Colombie-Britannique), en contrepartie de 27 000 $, le Moncton, New Brunswick, to EHS Corporation, Surrey, British bien connu comme l’ancienne propriété Steeves Columbia, for the purchase price of $27,000. (NID 01014042), situé promenade Bingham, à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

______

FEBRUARY 16, 2017 LE 16 FÉVRIER 2017 2017-35 2017-35 Under subsections 12(2) and 12(3) of the Human Rights Act, the En vertu des paragraphes 12(2) et 12(3) de la Loi sur les droits Lieutenant-Governor in Council appoints Pierrette Bouchard, de la personne, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme St.-François, New Brunswick, as a member of the New Bruns- Pierrette Bouchard, de Saint-François (Nouveau-Brunswick), wick Human Rights Commission, for a term of three years, ef- membre de la Commission des droits de la personne du fective February 16, 2017. Nouveau-Brunswick, pour un mandat de trois ans, à compter du 16 février 2017.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

______

FEBRUARY 16, 2017 LE 16 FÉVRIER 2017 2017-38 2017-38 Under section 12 of the Public Works Act, the Lieutenant- En vertu de l’article 12 de la Loi sur les travaux publics, le Governor in Council gives approval for the Minister of Trans- lieutenant-gouverneur en conseil autorise le ministre des portation and Infrastructure to convey the property described in Transports et de l’Infrastructure à céder à Sherico Develop- Schedule “A” hereto attached, known as vacant Department of ments Ltd., de la rue McKeen, à Fredericton (Nouveau- Transportation and Infrastructure property, 450 Bowlen Street, Brunswick), en contrepartie de 165 000 $, le bien désigné à Fredericton, New Brunswick, to Sherico Developments Ltd., l’annexe « A » ci-jointe, connu comme un bien vacant du minis- McKeen Street, Fredericton, New Brunswick, for the purchase tère des Transports et de l’Infrastructure situé au 450, rue price of $165,000. Bowlen, à Fredericton, au Nouveau-Brunswick.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

To obtain a complete copy, please refer to the Executive Pour recevoir un exemplaire au complet, veuillez Council Office Website for Orders in Council. consulter le site Web du bureau du Conseil exécutif.

______The Royal Gazette — March 22, 2017 298 Gazette royale — 22 mars 2017

FEBRUARY 23, 2017 LE 23 FÉVRIER 2017 2017-39 2017-39 Under subsection 83.1(1) of the Workers’ Compensation Act En vertu du paragraphe 83.1(1) de la Loi sur les accidents du and paragraph 21(1)(b) of the Interpretation Act, the travail et de l’alinéa 21(1)b) de la Loi d’interprétation, le Lieutenant-Governor in Council reappoints Roger Gagnon, lieutenant-gouverneur en conseil nomme pour un nouveau man- Bathurst, New Brunswick, as a Worker’s Advocate, effective dat Roger Gagnon, de Bathurst (Nouveau-Brunswick), à titre de February 23, 2017. défenseur du travailleur, à compter du 23 février 2017.

Kathleen Quigg, Administrator L’administratrice, Kathleen Quigg

______

FEBRUARY 23, 2017 LE 23 FÉVRIER 2017 2017-41 2017-41 1. Under paragraph 6(2)(f) of the Université de Moncton Act, 1. En vertu de l’alinéa 6(2)f) de la Loi sur l’Université de the Lieutenant-Governor in Council appoints Sylvie Benoit- Moncton, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme Thériault, Tracadie-Sheila, New Brunswick, as a member of the Sylvie Benoit-Thériault, de Tracadie-Sheila (Nouveau- Board of Governors of the Université de Moncton, effective Brunswick), membre du Conseil des gouverneurs de l’Univer- February 23, 2017, for a term of three years. sité de Moncton, pour un mandat de trois ans, à compter du 23 février 2017. 2. Under paragraph 6(2)(f) of the Université de Moncton Act, 2. En vertu de l’alinéa 6(2)f) de la Loi sur l’Université de the Lieutenant-Governor in Council appoints Lori-Ann Cyr, Moncton, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme , New Brunswick, as a member of the Board of Lori-Ann Cyr, d’Edmundston (Nouveau-Brunswick), membre Governors of the Univeristé de Moncton, effective February 23, du Conseil des gouverneurs de l’Université de Moncton, pour 2017, for a term of three years. un mandat de trois ans, à compter du 23 février 2017. 3. Under paragraph 6(2)(g) of the Université de Moncton Act, 3. En vertu de l’alinéa 6(2)g) de la Loi sur l’Université de the Lieutenant-Governor in Council appoints Jason Alcorn, Moncton, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme Saint John, New Brunswick, as a member of the Board of Gov- Jason Alcorn, de Saint John (Nouveau-Brunswick), membre du ernors of the Université de Moncton, effective February 23, Conseil des gouverneurs de l’Université de Moncton, pour un 2017, for a term of three years. mandat de trois ans, à compter du 23 février 2017.

Kathleen Quigg, Administrator L’administratrice, Kathleen Quigg

______

FEBRUARY 23, 2017 LE 23 FÉVRIER 2017 2017-42 2017-42 1. Under subparagraph 11(1)(d)(iii) and subsection 12(1) of the 1. En vertu du sous-alinéa 11(1)d)(iii) et du paragraphe 12(1) Economic and Social Inclusion Act, the Lieutenant-Governor in de la Loi sur l’inclusion économique et sociale, le lieutenant- Council appoints Paul Levesque, Edmundston, New Bruns- gouverneur en conseil nomme Paul Levesque, d’Edmundston wick, as a member of the Board of Directors of the Economic (Nouveau-Brunswick), membre du conseil d’administration de and Social Inclusion Corporation, as a representative of a per- la Société de l’inclusion économique et sociale, à titre de per- son who has or is living in poverty, for a term of four years, ef- sonne qui vit ou a vécu dans la pauvreté, pour un mandat de fective February 23, 2017. quatre ans, à compter du 23 février 2017. 2. Under subparagraph 11(1)(d)(ii) and subsection 12(1) of the 2. En vertu du sous-alinéa 11(1)d)(ii) et du paragraphe 12(1) de Economic and Social Inclusion Act, the Lieutenant-Governor in la Loi sur l’inclusion économique et sociale, le lieutenant- Council appoints Juliette Breau, Tracadie, New Brunswick, as a gouverneur en conseil nomme Juliette Breau, de Tracadie member of the Board of Directors of the Economic and Social (Nouveau-Brunswick), membre du conseil d’administration de Inclusion Corporation, as a representative of the non-profit sec- la Société de l’inclusion économique et sociale, à titre de repré- tor, for a term of four years, effective February 23, 2017. sentante du secteur sans but lucratif, pour un mandat de quatre ans, à compter du 23 février 2017. 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii) and subsection 12(1) of the 3. En vertu du sous-alinéa 11(1)d)(iii) et du paragraphe 12(1) Economic and Social Inclusion Act, the Lieutenant-Governor in de la Loi sur l’inclusion économique et sociale, le lieutenant- Council reappoints Angel Michaud, Perth-Andover, New gouverneur en conseil nomme pour un nouveau mandat Brunswick, as a member of the Board of Directors of the Eco- Angel Michaud, de Perth-Andover (Nouveau-Brunswick), nomic and Social Inclusion Corporation, as a representative of membre du conseil d’administration de la Société de l’inclusion a person who has or is living in poverty, for a term of four years, économique et sociale, à titre de personne qui vit ou a vécu dans effective February 23, 2017. la pauvreté, pour un mandat de quatre ans, à compter du 23 février 2017. The Royal Gazette — March 22, 2017 299 Gazette royale — 22 mars 2017

4. Under subparagraph 11(1)(d)(iii) and subsection 12(1) of the 4. En vertu du sous-alinéa 11(1)d)(iii) et du paragraphe 12(1) Economic and Social Inclusion Act, the Lieutenant-Governor in de la Loi sur l’inclusion économique et sociale, le lieutenant- Council reappoints Beverly Wilcox, Bathurst, New Brunswick, gouverneur en conseil nomme pour un nouveau mandat as a member of the Board of Directors of the Economic and So- Beverly Wilcox, de Bathurst (Nouveau-Brunswick), membre cial Inclusion Corporation, as a representative of a person who du conseil d’administration de la Société de l’inclusion écono- has or is living in poverty, for a term of four years, effective mique et sociale, à titre de personne qui vit ou a vécu dans la February 23, 2017. pauvreté, pour un mandat de quatre ans, à compter du 23 février 2017. 5. Under subparagraph 11(1)(d)(i) and subsection 12(1) of the 5. En vertu du sous-alinéa 11(1)d)(i) et du paragraphe 12(1) de Economic and Social Inclusion Act, the Lieutenant-Governor in la Loi sur l’inclusion économique et sociale, le lieutenant- Council reappoints Nicholas Ganong, St. Stephen, New Bruns- gouverneur en conseil nomme pour un nouveau mandat wick, as a member of the Board of Directors of the Economic Nicholas Ganong, de St. Stephen (Nouveau-Brunswick), and Social Inclusion Corporation, as a representative of the membre du conseil d’administration de la Société de l’inclusion business sector, for a term of four years, effective February 23, économique et sociale, à titre de représentant du secteur des en- 2017. treprises, pour un mandat de quatre ans, à compter du 23 février 2017.

Kathleen Quigg, Administrator L’administratrice, Kathleen Quigg

______

FEBRUARY 23, 2017 LE 23 FÉVRIER 2017 2017-45 2017-45 1. Under paragraph 6(1)(b) and subsection 6(1.1) of the New 1. En vertu de l’alinéa 6(1)b) et du paragraphe 6(1.1) de la Loi Brunswick Liquor Corporation Act, the Lieutenant-Governor in sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, le lieutenant- Council appoints Janel Ouellet, Edmundston, New Brunswick, gouverneur en conseil nomme Janel Ouellet, d’Edmundston as a member of the Board of Directors of the New Brunswick (Nouveau-Brunswick), membre du Conseil d’administration de Liquor Corporation, effective February 23, 2017, for a term to la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, à compter du expire January 31, 2020. 23 février 2017, pour un mandat prenant fin le 31 janvier 2020. 2. Under paragraph 6(1)(b) and subsection 6(1.1) of the New 2. En vertu de l’alinéa 6(1)b) et du paragraphe 6(1.1) de la Loi Brunswick Liquor Corporation Act, the Lieutenant-Governor in sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, le lieutenant- Council appoints Wanita McGraw, Tracadie-Sheila, New gouverneur en conseil nomme Wanita McGraw, de Tracadie- Brunswick, as a member of the Board of Directors of the New Sheila (Nouveau-Brunswick), membre du Conseil d’adminis- Brunswick Liquor Corporation, effective February 23, 2017, for tration de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, à a term to expire January 31, 2020. compter du 23 février 2017, pour un mandat prenant fin le 31 janvier 2020. 3. Under paragraph 6(1)(b) and subsection 6(1.1) of the New 3. En vertu de l’alinéa 6(1)b) et du paragraphe 6(1.1) de la Loi Brunswick Liquor Corporation Act, the Lieutenant-Governor in sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, le lieutenant- Council appoints Louella Woods, Douglas, New Brunswick, as gouverneur en conseil nomme Louella Woods, de Douglas a member of the Board of Directors of the New Brunswick Li- (Nouveau-Brunswick), membre du Conseil d’administration de quor Corporation, effective February 23, 2017, for a term to ex- la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, à compter du pire January 31, 2020. 23 février 2017, pour un mandat prenant fin le 31 janvier 2020. 4. Under paragraph 6(1)(b) and subsection 6(1.1) of the New 4. En vertu de l’alinéa 6(1)b) et du paragraphe 6(1.1) de la Loi Brunswick Liquor Corporation Act, the Lieutenant-Governor in sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, le lieutenant- Council appoints Pierre LaFrance, Dieppe, New Brunswick, as gouverneur en conseil nomme Pierre LaFrance, de Dieppe a member of the Board of Directors of the New Brunswick Li- (Nouveau-Brunswick), membre du Conseil d’administration de quor Corporation, effective July 17, 2017, for a term to expire la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, à compter du July 16, 2020. 17 juillet 2017, pour un mandat prenant fin le 16 juillet 2020. 5. Under paragraph 6(1)(b) and subsection 6(1.2) of the New 5. En vertu de l’alinéa 6(1)b) et du paragraphe 6(1.2) de la Loi Brunswick Liquor Corporation Act, the Lieutenant-Governor in sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, le lieutenant- Council reappoints Arthur Doyle, Saint John, New Brunswick, gouverneur en conseil nomme pour un nouveau mandat as a member of the Board of Directors of the New Brunswick Arthur Doyle, de Saint John (Nouveau-Brunswick), membre du Liquor Corporation, effective February 23, 2017, for a term to Conseil d’administration de la Société des alcools du Nouveau- expire July 31, 2019. Brunswick, à compter du 23 février 2017, pour un mandat pre- nant fin le 31 juillet 2019. 6. Under paragraph 6(1)(b) and subsection 6(1.2) of the New 6. En vertu de l’alinéa 6(1)b) et du paragraphe 6(1.2) de la Loi Brunswick Liquor Corporation Act, the Lieutenant-Governor in sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, le lieutenant- Council reappoints Mike Jenkins, Riverview, New Brunswick, gouverneur en conseil nomme pour un nouveau mandat The Royal Gazette — March 22, 2017 300 Gazette royale — 22 mars 2017 as a member of the Board of Directors of the New Brunswick Mike Jenkins, de Riverview (Nouveau-Brunswick), membre du Liquor Corporation, effective February 23, 2017, for a term to Conseil d’administration de la Société des alcools du Nouveau- expire July 31, 2020. Brunswick, à compter du 23 février 2017, pour un mandat pre- nant fin le 31 juillet 2020. 7. Under paragraph 6(1)(b) and subsection 6(1.2) of the New 7. En vertu de l’alinéa 6(1)b) et du paragraphe 6(1.2) de la Loi Brunswick Liquor Corporation Act, the Lieutenant-Governor in sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, le lieutenant- Council reappoints Rachelle Gagnon, Irishtown, New Bruns- gouverneur en conseil nomme pour un nouveau mandat wick, as a member of the Board of Directors of the New Bruns- Rachelle Gagnon, d’Irishtown (Nouveau-Brunswick), membre wick Liquor Corporation, effective February 23, 2017, for a du Conseil d’administration de la Société des alcools du term to expire July 31, 2022. Nouveau-Brunswick, à compter du 23 février 2017, pour un mandat prenant fin le 31 juillet 2022. 8. Under paragraph 6(1)(b) and subsection 6(1.2) of the New 8. En vertu de l’alinéa 6(1)b) et du paragraphe 6(1.2) de la Loi Brunswick Liquor Corporation Act, the Lieutenant-Governor in sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, le lieutenant- Council appoints Rachelle Gagnon, Irishtown, New Brunswick, gouverneur en conseil nomme Rachelle Gagnon, d’Irishtown as Chair the Board of Directors of the New Brunswick Liquor (Nouveau-Brunswick), présidente du Conseil d’administration Corporation, effective February 23, 2017, for a term to expire de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, à compter du July 31, 2022. 23 février 2017, pour un mandat prenant fin le 31 juillet 2022.

Kathleen Quigg, Administrator L’administratrice, Kathleen Quigg

______

FEBRUARY 23, 2017 LE 23 FÉVRIER 2017 2017-46 2017-46 Under section 12 of the Public Works Act, the Lieutenant- En vertu de l’article 12 de la Loi sur les travaux publics, le Governor in Council gives approval for the Minister of Trans- lieutenant-gouverneur en conseil autorise le ministre des Trans- portation and Infrastructure to convey the property described in ports et de l’Infrastructure à céder à Beverley Joyce Schneider Schedule “A” hereto attached, known as vacant Department of et Amy Julia Schneider, de la promenade Clements, à Transportation and Infrastructure property, Corey Road, Scotch Fredericton (Nouveau-Brunswick), en contrepartie de 29 500 $, Settlement, New Brunswick, to Beverley Joyce Schneider and le bien désigné à l’annexe « A » ci-jointe, connu comme un bien Amy Julia Schneider, Clements Drive, Fredericton, New Bruns- vacant du ministère des Transports et de l’Infrastructure situé wick, for the purchase price of $29,500. chemin Corey, à Scotch Settlement, au Nouveau-Brunswick.

Kathleen Quigg, Administrator L’administratrice, Kathleen Quigg

To obtain a complete copy, please refer to the Executive Pour recevoir un exemplaire au complet, veuillez Council Office Website for Orders in Council. consulter le site Web du bureau du Conseil exécutif.

Business Corporations Act Loi sur les corporations commerciales

CORRECTION RECTIFICATION

Notice of dissolution of provincial corporations Avis de dissolution de corporations provinciales

In relation to the list appearing in the November 9, 2016, edition Sachez que, relativement à la liste apparaissant dans l’édition de of The Royal Gazette, the following corporation should not have La Gazette royale du 9 novembre 2016, la corporation suivante been set out on the list: n’aurait pas dû figurer dans cette liste :

Hanscomb Auto Sales Inc. Hanscomb Auto Sales Inc. 630418 630418 ______The Royal Gazette — March 22, 2017 301 Gazette royale — 22 mars 2017

Notice of a decision to dissolve provincial corporations and to Avis d’une décision de dissoudre les corporations provinciales cancel the registration of extra-provincial corporations et d’annuler l’enregistrement des corporations extraprovin- ciales Notice of decision to dissolve provincial corporations Avis d’une décision de dissoudre les corporations provinciales Take notice that the Director under the Business Corporations Act has Sachez que le directeur, en application de la Loi sur les corporations made a decision to dissolve the following corporations pursuant to commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations sui- paragraph 139(1)(c) of the Act, as the said corporations have been in vantes en vertu de l’alinéa 139(1)c) de la Loi, puisque lesdites corpo- default in sending to the Director fees, notices, and/or documents re- rations ont fait défaut de faire parvenir au directeur les droits, avis et/ quired by the Act. Please note that 60 days after the date of publication ou documents requis par la Loi. Soyez avisé que 60 jours après la date of this Notice in The Royal Gazette, the Director may dissolve the de la publication du présent avis dans la Gazette royale, le directeur corporations. pourra dissoudre lesdites corporations.

031781 031781 N.B. LTD. 669621 669621 N.B. Ltd. 618370 Applied Pressure Inc. 031904 031904 (N.B.) INC. 669756 669756 N.B. INC. 511824 Arthur’s Bar & Grill Ltd. 035291 035291 N.B. INC. 669929 669929 NB Ltd. 669616 ARTISAN ROOFING INC. 039135 039135 N.B. LTD. 669970 669970 N.B. Inc. 606371 Assurance Gisèle Basque Insurance Inc. 041702 041702 N.B. Ltd. 670011 670011 N.B. Inc. 030319 ATLANTIC BLUEBERRY FARMS LTD. 044444 044444 N.B. LTD. 670056 670056 NB Inc. - LES BLEUETIERES DE 047314 047314 N.B. INC. 670059 670059 N.-B. Inc. L’ATLANTIQUE LTEE. 051865 051865 NB Ltd. 675950 675950 N.B. Ltd. 606410 Atlantic Tea Merchants Limited 053934 053934 N.B. LTD. 676096 676096 NB INC. 657031 Atlantic-Navis Vessel Services Ltd. 054024 054024 N.B. LTD. 676121 676121 NB Inc. 681989 Avic1 Consulting Ltd. 054044 054044 N.B. INC. 676152 676152 NB Ltd. 676205 Aylward Holdings Inc. 502082 502082 N.B. LTD. 676155 676155 NB LTD. 612253 B.M. Marine Inc. 502140 502140 NB INC 676184 676184 N.B. Inc. 682272 Bakam Maintenance Inc. 504586 504586 N.B. INC. 676186 676186 N.B. Inc. 001408 BAR-C FARMS LTD. 509115 509115 N.B. INC. 676240 676240 NB LTD. 612166 BASTARACHE PREFAB HOME 511767 511767 N.B. Ltd. 676296 676296 NB LTD. DELIVERY LTD 511827 511827 NB LTD. 681803 681803 N.B. INC. 681892 BBMB MUSIC INC. 514279 514279 New Brunswick Inc. 681807 681807 N.B. INC. 001869 BETTLE’S STEERING SERVICE LTD. 514380 514380 N.-B. Ltée 681866 681866 N.B. Inc./681866 NB Inc. 644027 BIG IRON TRUCKING INC. 600317 600317 N. B. LTD. 681874 681874 NB INC. 675822 Black Dog Consulting Ltd. 600318 600318 N. B. LTD. 681894 681894 New Brunswick Corp. 637810 BorealOcean Inc. 600644 600644 N.B. Inc. 681897 681897 NB Inc. 051854 BOUCTOUCHE CONTRACTING LTD. 606155 603426 N.B. Ltd. 681941 681941 N.-B. Ltée 031767 BRADFORD ELECTRIC LTD. 606169 606169 N.B. Inc. 681943 681943 NB Inc. 618518 Bridgetown Auto Inc. 606171 606171 NB INC. 681982 681982 NB Ltd. 650416 Business Data Consulting Corporation 611828 611828 N.-B. INC. 681984 681984 N.B. Ltd. 676080 Buttcon East Limited 618099 618099 N.B. INC. 681990 681990 NB Ltd. 051807 C A REALTY LTD. 618385 618385 NB INC. 682050 682050 NB Inc. 650431 C. O’DONNELL-COOK INSURANCE 618647 618647 N.B. LIMITED 682077 682077 N.B. INC. INC. 624851 624851 NB Inc. 682121 682121 N.B. Inc.682121 N.-B. Inc. 681817 C.E. Clark & Sons Limited 625161 625161 N.B. INC. 682149 682149 NB Inc. 624879 CANADA EAST RENEWABLE 625168 625168 New Brunswick Ltd. 682201 682201 N.B. Ltd. ENERGY INC. 631087 631087 N.B. Ltd. 682235 682235 NB INC. 057090 CANNEBERGES DE PETIT- 631161 631161 N.B. INC. 682292 682292 NB INC. SHIPPAGAN LTÉE 631357 631357 NB INC. 682346 682346 N.B. Inc. 657180 Carber Construction Management Inc. 637633 637633 N.B. Ltd. 682348 682348 New Brunswick Inc.- 514334 CARLINGFORD FOODS LTD. 637890 637890 NB INC. 682348 Nouveau-Brunswick Inc. 669944 CASEM Enterprises Ltd. 643926 643926 NB Inc.- 643926 N.-B. Inc. 682384 682384 NB Ltd. 624771 CBJ Inspection Services Ltd 643927 643927 N.-B. INC. 682395 682395 N.B. Ltd. 650675 Céline Robichaud Fournier P.C. Inc. 643940 643940 NB Ltd. 682398 682398 NB INC. 049677 CENTRE FOR EDUCATION AND 643965 643965 N.B. Ltd. 682400 682400 NB INC. RESEARCH IN SAFETY INC. 643981 643981 N.B. Inc. 049403 A M A EQUIPMENT LTD. CENTRE D’EDUCATION ET DE 644163 644163 N.B. Inc. 631559 A Plus Properties Inc. RECHERCHE EN SECURITE INC. 644338 644338 N.B. Inc. 663552 A.L.A. Trucking inc. 663313 Century 21 Absolute Realty Inc. 650241 650241 NB Ltd. 600879 Aamps Electrical Ltd. 044041 CHAPEL DESIGNS LTD. 650285 650285 N.B. INC. 600642 AB ZEE PRODUCTION SERVICES 031728 CHAPEL FURNISHINGS LTD. 650366 650366 N.B. Ltd. INC. 502173 CHASE INSURANCE SERVICES LTD. 650472 650472 NB Inc. 681913 ACN SYSTÈMES D’EAU LTÉE 631077 Chateau Notre Dame Inc. 650668 650668 NB Inc. 600833 Active Healing Massage Therapy Clinic 682006 Chess Copyright International Inc. 657126 657126 N.B. Ltd. Inc. 669636 Chipman Garden Homes Inc. 663317 663317 N.B. Ltd. 663495 Adolphe Holdings Inc. 663362 CHL Construction Ltd. 663321 663321 NB Ltd. 681829 AGRO MARINE CANADA INC. 644065 CHLOMAX TRUCKING INC. 663396 663396 NB Inc. 643887 Alexandre Pavers and Stone Ltd. 682066 CHRISTINE DRAPEAU 663498 663498 NEW BRUNSWICK INC. 682202 ALL TEMP REFRIGERATION & AIR PROFESSIONAL CORPORATION 663522 663522 NB Inc. CONDITIONING INC. 514311 CITY ROAD BAKERY LTD. 663538 663538 NB LTD. 514344 Allen Forestry Ltd. 009711 CLAUDE S. LEBLANC CONCRETE 663540 663540 N.B. LTD. 682270 Altaris Group Inc. FORMS LTD. 669577 669577 N.B. Inc. 000497 ALTRON ELECTRONICS LTD. 509109 CLEARVIEW REALTY COMPANY 669618 669618 N.B. Inc. 617877 Ammon Developments Inc. LTD. 669619 669619 N.B. Inc. 000637 APOLLO BUILDERS LTD. 650328 Clinique d’Orthophonie Syllabe Inc. The Royal Gazette — March 22, 2017 302 Gazette royale — 22 mars 2017

675963 COCCAMP NB INC. 618513 EVOLUTION: CONSTRUCTIVE 021455 KENNY HOLDINGS LIMITED 514339 COCHRAN’S HOME AWAY FROM SOLUTIONS INC. 681938 KHC Trucking Ltd. HOME DAYCARE LTD. 600721 Fairfield Utility and Tree Trimming Ltd. 631501 KINGSTON CREEK MARINE INC. 669390 Coldwater Canadian Lobster Inc. 663367 FDL QUALITY CONSULTANTS LTD. 631304 KODYME GLASS LTD. 004136 CONCORD CONSTRUCTION LTEE. 031759 FERME SHEDIAC FARM INC. 656854 L & R Toasty Classics Ltd. 514304 Cooke’s Quik Mart Inc. 056995 FERME WADELL INC. 008447 L’INDUSTRIE MARINE DE 035280 CORMIER RENTALS LTD. 676019 First City Holdings Inc. CARAQUET LTEE. - CARAQUET 600766 Corner Salty Sea Dog Pub Ltd. 676021 First City Property Management Inc. MARINE INDUSTRY LTD. 644302 Coverdale Veterinary Hospital Ltd. 638007 Flymcfly Limited 650181 L2 - RECHERCHE & PRODUCTION 509207 CROOKED CREEK INN LTD. 051659 FONDATIONS ROUSSEL LTEE AQUACOLE INC. 504641 CROSS CREEK MINI HOME PARK & 059883 FONTAINE INSURANCE AGENCY L2 - AQUACULTURE RESEARCH & SALES LTD. LTD. PRODUCTION INC. 059960 CROSS CREEK TIMBER TRADERS 681972 Forever Green Processing Ltd. 509257 LAFFORD & WILSON FISHERIES INC. 644031 Friars Bay Motel Ltd. LTD. 682393 Crystal Beach Recreation Park Inc. 506838 FUNDY PAVING INC. 009515 LAMB’S TRUCKING LIMITED 039307 D. & L. MOTORS INC. 041715 GADDESS INDUSTRIAL 511843 Lambert Home Improvements Ltd. 682354 D. BAIRD TRUCKING LTD. PREVENTATIVE MAINTENANCE 676245 Le P’tit Paris Inc. 631315 D. LeBlanc Trading Ltée/Ltd. LTD. 059864 LE SAPINO INC. 004709 DACO CONSTRUCTION LTD. 682134 GARDERIE CABOTIN LTÉE 612148 LE STUDIO MANITOU SOUND 041618 DALHOUSIE ENTERPRISES LIMITED 033642 Georges Poirier and Sons Woodwork Ltd./ STUDIO INC. 625175 DAN DEVOST CONSTRUCTION LTD. et Fils Menuiserie Ltee. 049198 LES ENTREPRISES JGM INC. 502111 DANRON CONCRETE FOUNDATION 637718 Gestion J & L Ltée 044681 LES ENTREPRISES RENOR INC. - LTD. 514357 Gestion MR Management Inc. RENOR ENTERPRISES INC. 004779 DANTE’S HAIRSTYLING 509061 GILBERT FARM LTD. 039356 LES EQUIPEMENTS PEATY LTEE- (BROOKSIDE) LTD. 618362 Gionet Optical Inc. PEATY EQUIPMENT LTD 036804 DANTECH ENTERPRISES LTD. 031766 GOLDSBORO CONTRACTING LTD. 637943 Lil Imagination Station Daycare Inc 004858 DECO-STEPS & RAILING LTD. 612348 GORMAN’S TAXI LTD. 669880 Lincoln Landscaping Ltd. 663485 Denis Godbout Électrique Inc. 637942 Gran Medical Inc. 502063 LION D’OR (1996) LTD. - LTEE 669662 Derby Derry Enterprises Inc. 681969 Grayland Trucking Ltd. 511751 M & F LEBLANC OIL LTD. 682303 Derosei Cleaning Ltd. 631282 Graystone Quarries Inc. 669709 M.G. MORRISON TRUCKING AND 669979 DERRICK GILLESPIE TRUCKING 035288 GRETZKY REALTY LTD. DELIVERY LTD. LTD. 682210 Groupe117 Inc. 650554 MARITIME BUNGALOWS LTD. 682321 DISTRIBUTION NEWSTART INC. 007634 H & H PLUMBING & HEATING LTD. 681912 Maritime Express Transportation & 682171 DJ Tree Cutting Inc. 624795 H. GREER & SON (2006) LTD. Shipping Inc. 625146 DJM Enterprises Inc. 049657 HAB INVESTMENTS INC. 504469 Maritime Industrial Machining Inc. 644086 DOUG HUDSON TRUCKING LTD. 663333 Habitation S. Lavoie Inc. 504570 MATRIX MANAGEMENT INC. 631073 Douglas Harbour Contracting Ltd. 504581 HAMILTON CONSTRUCTION LTD. 606250 Mayday Group Inc. 681970 Dr. Catherine Boucher Professional 663300 Hamilton Specialty Bar & Coil, Inc. 643995 MBRO Canada Ltd. Corporation 007750 HANNAH CONSTRUCTION LTD. 650577 MC PROTECH INNOVATION INC. 663213 Dr. Keith G. Weber Professional 644359 Harewood Truck & Trailer Inc. 506738 MCMINN PIT LTD. Corporation 663187 HDM Logging Ltd. 675853 McMorran and Son Earth Moving and 675814 Dr. S. MacMullin Professional 682343 Hebert Eh-Lectrician Inc. Snow Removal Ltd. Corporation 681945 Higher Ground Wellness Centre Inc. 511788 MEDIDELTA INC. 663458 Dr. Solomon Ugabi Professional 059913 HILLSIDE CONVENIENCE STORE 650778 MEUBLES SAINT ARTHUR Corporation (1995) LTD. FURNITURE INC. 618044 Dr. Valerie-Anne Cyr Corporation 669575 Holistic Underwriting Inc. 682428 Mirandus Consulting Inc. Professionnelle Inc. 030307 HORIZON SPORTS LTEE 605946 MMK & ASSOCIATES INC. 502215 Dream Boat Fisheries Inc. 682386 Impera Enterprises Ltd. 682177 MowTown lawn maintenance Inc. 682362 DreamMaker Innovations Inc. 047132 J & C TATLOCK & SON TRANSPORT 663483 Muddy Boot Construction Management 600491 Dunnett Bros. Plumbing & Heating (2002) LTD. Ltd. Ltd. 502267 J. M. HOVEY HOLDINGS LTD. 618566 Multitech Trading Ltd. 681930 E-TechPool Inc. 504483 J. MCNULTY WEEKLY INC. 051780 N. BOUDREAU RENOVATIONS LTEE 039351 EAST COAST HOUSING (ST. 669634 J. THERIAULT TRUCKING INC. 033518 NATIONAL SPORTS INC. STEPHEN) LTD. 514401 J.A.J.C. Management Inc. 644071 Navaera Canada, Inc. 059929 EAST COAST PRECAST LTD. 041656 J.E.M. TRUCKING LTD. 650548 NEPC Franchise Inc. 005445 EAST COAST PRINTING LTD. 509175 J.J. ALLAIN ÉLECTRIQUE INC. 606290 NEWS-CAST.COM INC. 005464 EASTCAN PROPERTIES LTD. 624982 James McCollum Painting and Stucco 031732 NOEL ROOFING LTEE 005508 EASTERN FARM & INDUSTRIAL Ltd. 650452 NU VISTA BUILDERS INC. EQUIPMENT (1975) LTD. 606352 JBW HOLDINGS INC. 682173 Offbeat Homes Inc. LA FERME DE L’EST & EQUIPMENT 031755 JEANNETTE B.B.Q. LTEE 509089 OXFORD QUALITY FURNITURE INDUSTRIEL (1975) LTEE. 675989 Jeff’s Appliance Service & Installation RESTORATION INC. 005510 EASTERN FISHERIES LTD.-LES Ltd. 670017 P. J. MacMullin & Sons Inc. PECHERIES DE L’EST LTEE 676196 Jiahong International Culture Media 600942 PACA ENTERPRISES LTD. 047247 EASTWIND CONSTRUCTION LTD. Group Ltd. 656806 PACE Hanson Research Inc. 005570 EASTWOOD CONSTRUCTION LTD. 656905 JLH DEVELOPMENTS INC. 631148 Parking Management Systems Inc. 031786 EDDY M. LTEE 682135 JLHIM Properties Inc. 504068 PATRIMOINE THOMAS BRIDEAU 663014 Éditions Tarma Inc. 656972 JNL Properties Inc. HERITAGE INC. 606460 Elwood Cleary Investments Ltd. 682407 Joey Bossé MODR Consultant Inc. 611917 PAUL R INMAN CARPENTRY LTD 644017 EMS Enterprise Inc. 644410 John A. Farkas Dental Lab Inc. 037292 PAUL WOODLAND LOGGING LTD. 682360 Envisioned 3D Solutions Inc. 047003 JOHN LAW CORPORATION 682267 PAW & KIDS TRUCKING LTD. 509269 Epicerie Nedgar Doiron Ltée 049517 JOHN LINDSAY TRUCKING LTD. 670005 PEAK TECHNICAL SALES LTD. 637494 Eric P. Sonier c.p. Inc. 504654 JULIE PATRICK LTEE 056967 PÊCHERIES AURÈLE GUY INC 624993 Esgenoôpetitj Development Corporation 657008 K T Logging Inc. 663455 PÊCHERIES GDM CHANDARO INC. Ltd. 682004 K2B Marketing Inc. 606143 Peninsula Foods Limited/Aliments 056925 ESR CONSULTANTS INC. 663200 Katarina Holdings Corp. Péninsule Limitée 682098 EUROSTAR WINDOWS AND DOORS 631277 KBF Automotive Inc. 053984 PEPPER CREEK DEVELOPMENTS INC. 682185 Kelly Auto Glass (2015) Ltd. INC. The Royal Gazette — March 22, 2017 303 Gazette royale — 22 mars 2017

669739 Perfect Market Ltd. 682345 River City Fitness Club Inc. 631198 Summit Industries Ltd. 681948 Permission To Sell Consulting Group Ltd. 644295 RMT Distributors Ltd. 675830 Sumparkk Holdings Inc. 504609 PETERS & ASSOCIATES LTD. 675831 Roadglide Holdings Ltd. 511785 SUNSET VILLAGE CO. LTD. 638013 Phar Trucking Ltd. 631339 ROBICHAUD’S SPECIAL CARE 682268 SUPERIOR LIVING SPACES INC. 600920 PHARMACIE DONALD CHIASSON HOME INC. 637853 T & B Church Consultants Inc. LTEE 637580 ROBITAILLE SCRAP METAL LTD. 053806 T & J CONSTRUCTION LTD. 637798 PICKETT’S PORTABLE RESTROOMS 041703 ROCKICO EQUIPMENT LTD. 631515 T M Y Enterprises Inc. LTD. 637726 Rödl & Partner Ltd. 663097 T. Duke Holdings Ltd. 502074 PINE ISLAND INDUSTRIES LIMITED 036977 ROGERSVILLE HOLDINGS LTD. 511819 TERRY SAVOIE FARMS LTEE/LTD. 682257 Platinum DFX Inc. 035318 Rolly’s Holdings Ltd. 682123 The Sour Grape Inc. 041542 PORCHERIE DUROC INC. 618489 ROUSSELLE ACADIE DRYWALL 682291 TLC Home Reno Ltd. 630939 Poulet Frit Lamèque Limitée LTÉE 057030 TOBIQUE HIGH STAKES BINGO LTD. 663359 PPR FORESTRY INC. 012809 RUSSEL PARISH TRUCKING LTD. 033550 TOBIQUE LOG HOMES LTD. 682312 PREMIER CLOTHING STORES OF 037132 Rustic Builders Inc. 618197 TOPLINE CONSTRUCTION INC. CANADA CORP. 682255 RV COUNTRY LTD. 669796 Total Power Sports Inc. 682191 PrimeWebsite Inc. 663551 S.J. McLean Construction Inc. 624980 Tulk Ventures Ltd 506914 PRODUCTIONS MUSICALES MARC 631080 Sakiyik Inc. 669842 Twin Raven Consulting Inc. BEAULIEU INC. 644268 Sandell Brothers Ltd. 656953 UCAN2 Home Builders Inc. 670125 ProductWiki Inc. 504664 SAS CONSULTANTS INC 663413 Unique Enterprises by MJ Ltd. 013423 PROMOTION MARITIME LTEE. 663207 SAVVY SISTERS PROPERTY 682377 United Citizens Public Relations Inc. 682287 PT Health NB 2015 Professional INVESTMENTS INC. 097266 UNITED DEVELOPMENT COMPANY Corporation Inc. 618121 Sea Watch Tours Inc. LIMITED 670018 Quillis Family Fun Factory Inc. 650686 Seaside Grill Restaurant Ltd. 031841 VAL’S CONSTRUCTION LTD. 606145 R. J. Surette Construction Inc. 015102 SHELL CONSTRUCTION LTD. 509152 VANDE BRAND VENTURES LTD. 051908 RCTO FISH BUYER LTD. 504665 SIKORSKY CANADA INC. 682269 Velocity Solutions Corp. 511680 READY ARC WELDING (2000) INC. 657142 Silk Road Canada Inc. 053925 VICON CONTRACTORS LTD. 624645 REFLECTIONS HAIRSTYLING & 681845 Silverback Logging Ltd. 033618 VILLAGE DEVELOPMENTS LTD. TANNING SALON LTD. 039342 SIMMONS DRAINAGE & SUPPLY 663320 VisscherHolland Canada Inc. 600646 REITRAC INC. LTD. 682248 VIVA STUDIO & SPA BY TINA INC. 663051 RENU MOBILE PRESSURE WASH 675870 Simon says Bar&Grill Ltd. 681909 VN Buffet Ltd. INC. 600910 SKYDIVE MONCTON INC. 669891 VSIX Auto Inc. 656843 RÉSIDENCE THÉRAPEUTIQUE 059896 SMET TRUCKING LTD. 612127 W & P AUTO SALES LTD. CHALEUR INC 682394 Smiwaggan Loggin’ Ltd. 039256 WAMCO LTD. 506887 RESIDENCE WEST-END INC. 682061 Sonic Image Inc. 041755 WATERFRONT RESTAURANT LTD. 600363 Results planning ltd. 675986 Sonny Bubbles Mobile Washing Ltd. 506880 WATTS-UP LTD. 051675 REYNOLDS CUSTOM LUMBER 681880 Spence Custom Painting Ltd. 013785 WEBCO HOLDINGS INC. PRODUCTS INC. 015504 Stairs Building (2004) Ltd. 637572 Wee Ventures Inc. 053916 RH & SONS ELECTRICAL 015561 STEEVES BIKE SHOP LTD. 511777 WHITETAIL FISHERIES INC. CONTRACTOR INC. 502278 STERLING CONSTRUCTION LTD. 509220 Wind Song Partners Inc. 669561 Rides End Holding Inc. 015623 STILWELL FOODS LTD. 637531 Yard Guyz Inc. 681854 Ridge Side Logging Inc. 682175 StopCold Laser Saint John Inc. 644314 Your At Home Retreat Ltd. 682186 RITCHIE’S TRUCK AND TRAILER 047262 STRATEGIC VENTURES REPAIR LTD. CORPORATION

______

Notice of decision Avis d’une décision to cancel the registration of extra-provincial corporations d’annuler l’enregistrement des corporations extraprovinciales Take notice that the Director under the Business Corporations Act has Sachez que le directeur, en application de la Loi sur les corporations made a decision to cancel the registration of the following extra- commerciales, a pris la décision d’annuler l’enregistrement des corpo- provincial corporations pursuant to paragraph 201(1)(a) of the Act, as rations extraprovinciales suivantes en vertu de l’alinéa 201(1)a) de la the said corporations have been in default in sending to the Director Loi, puisque lesdites corporations ont fait défaut de faire parvenir au fees, notices, and/or documents required by the Act. Please note that directeur les droits, avis et/ou documents requis par la Loi. Soyez avisé 60 days after the publication of this Notice in The Royal Gazette, the que 60 jours après la date de la publication du présent avis dans la Director may cancel the registration. Gazette royale, le directeur pourra annuler l’enregistrement desdites corporations extraprovinciales.

670067 0962667 B.C. LTD. 682264 Fibrotic Ltd. 644145 Perceptive Financial Ltd. 650336 7231474 Canada Inc. 650538 GENBAND IRELAND LIMITED 656919 Picomole Inc. 681824 9225-4002 QUÉBEC INC. 681932 good.better inc. 637743 RTD QUALITY SERVICES INC./RTD, 663530 Ainsworth Inc. 676171 HCC Specialty Underwriters Ltd. SERVICES DE QUALITE INC. 682299 AVANT OF CANADA, LLC 637740 IKM Testing (Canada) Ltd 663361 SHOP.CA Network Inc. 624930 Baxters Ontario Inc. 681904 IMMOCOM SERVICES 631147 SPECTRA PREMIUM INDUSTRIES 017267 CANADA-ISRAEL SECURITIES INTERNATIONAL INC. LES INDUSTRIES SPECTRA LIMITED 682034 Impak media solution inc. PREMIUM INC. 669763 CANADA-REPORTS, ULC 682353 Kleinschmidt Associates Canada Inc. 676018 TAYMECH Consulting Services Inc. 017240 CBCL LIMITED 682238 MCASPHALT INDUSTRIES LIMITED / 631398 The Folkestone Properties Ltd. 682285 CYR BROTHERS INC. LES INDUSTRIES MCASPHALT 663287 The Gray Group Inc. 682265 DOMINION LENDING CENTRES LIMITEE 606330 The Prolink Insurance Group Inc. NATIONAL LTD. 682288 MITCHELL PARKS PROPERTIES INC. 631431 UXB International, Inc. 637686 DONALD CIVIL TECHNOLOGY 682048 MOREL BENEFITS CONSULTING 611991 X-RAIL SIGNALS INC./X-RAIL SERVICES INC. SERVICES LIMITED SIGNALISATION INC. 670166 Edgefront Realty Corp. 670086 Murphy Neil Financial Group Inc. 681931 Elanco Canada Limited 650398 Ouisi Enterprises Inc. The Royal Gazette — March 22, 2017 304 Gazette royale — 22 mars 2017

Companies Act Loi sur les compagnies

Notice of decision to dissolve provincial companies Avis d’une décision de dissoudre les compagnies provinciales Take notice that the Director under the Companies Act has made a de- Soyez avisé que le directeur, en application de la Loi sur les compa- cision to dissolve the following companies pursuant to paragraph gnies, a pris la décision de dissoudre les compagnies suivantes en vertu 35(1)(c) of the Act, as the said companies have been in default in send- de l’alinéa 35(1)c) de la Loi, puisque lesdites compagnies ont fait dé- ing to the Director fees, notices, and/or documents required by the Act. faut de faire parvenir au directeur les droits, avis et/ou documents re- Please note that 60 days after the date of publication of this Notice in quis par la Loi. Soyez avisé que 60 jours après la date de la publication The Royal Gazette, the Director may dissolve the companies. du présent avis dans la Gazette royale, le directeur pourra dissoudre lesdites compagnies.

681954 Aboriginal Peoples Council of Acadia Inc. 023141 FREDERICTON HORSEMAN’S 024594 OAK HILL CHRISTIAN CENTRE INC. 682189 ACADÉMIE DU LEADERSHIP DU ASSOCIATION INC. 650201 RADARTS INC. NOUVEAU-BRUNSWICK INC. 020937 FREDERICTON LOYALIST RUGBY 014131 RIVERVIEW KINSMEN COMMUNITY 023388 ASSOCIATION OF NEW BRUNSWICK CLUB INC. CENTRE INCORPORATED LICENSED PRACTICAL NURSES 006682 FUNDY CURLING CLUB LIMITED 623627 Rockland Cemetery Company TRAINING TRUST FUND INC. 637682 FUNDY PADDLERS CLUB INC. 024923 SENTIERS BATHURST-NB TRAILS 001528 BATHURST LIONS CLUB INC. 669655 FUSION FREDERICTON INC. INC. 001820 BERRY MILLS HEIGHTS 682281 HOMESTEADERS ASSOCIATION 631289 SHEPODY FOOD BANK INC. NEIGHBORHOOD SOCIETY INC. INC. 663365 Shibata Meadows Iba Shambhala Retreat 637894 Business & Professional Women of 612062 Intersection Nord-Sud Inc. Center Inc. Greater Moncton Inc. 022363 KESWICK RECREATION 014711 ST. STEPHEN DEVELOPMENT 002869 CAMPOBELLO LIBRARY ASSOCIATION INC. BOARD INCORPORATED ASSOCIATION INCORPORATED 009308 KIWANIS CLUB OF PETITCODIAC, 669882 STUDENT LEADERSHIP 024182 CAP BIMET RESIDENTS’ INC. MOVEMENT OF GREATER ASSOCIATION INC. 022542 L’ASSOCIATION ACADIENNE DES MONCTON INC. 024935 CAPE ENRAGE INTERPRETIVE JOURNALISTES 024592 THE ARCHITECTS’ ASSOCIATION CENTRE INCORPORATED 022130 LA FOIRE BRAYONNE INC. OF NEW BRUNSWICK MEMORIAL 023734 CARLETON-VICTORIA TOURIST 022138 LANCASTER MINOR HOCKEY FOUNDATION INC./ ASSOCIATION INC. ASSOCIATION, INC. LA FONDATION 003273 CENTRAL NEW BRUNSWICK 650737 LES RÉSIDENCES JODIN INC. COMMÉMORATIVE DE NURSING HOME INC. 094001 LEWIS MOUNTAIN CEMETERY LTD. L’ASSOCIATION DES 650714 CENTRE FAMILIAL CHALEUR DE 600789 Lindsay Cemetery Association Inc. ARCHITECTES DU L’AUTISME ET ASPERGER INC. 024922 LOCKSTEAD CITIZENS NOUVEAU-BRUNSWICK LTÉE CHALEUR FAMILY CENTER FOR RECREATION AND 004003 THE COLLEGE HILL SOCIAL CLUB, AUTISM AND ASPERGER INC. ENVIRONMENTAL ASSOCIATION, INC. 657000 Chaleur Canine Club Inc. INC. 010092 THE LOWER TURTLE CREEK 650586 CHALEUR SPORTS FOUNDATION 021834 MARITIME GEETA BHAWAN INC. LADIES AID INC. LTD. 022349 MINLAK TRAINING PROGRAMS 631093 THE WESTSIDE PACT INC. 682044 Chess Copyright Association Inc. INC. 016529 UNITARIAN UNIVERSALIST 024739 Chipman Christian Life Center Inc. 022352 MINTO BUSINESS ASSOC. INC. CHURCH OF SAINT JOHN INC. 023960 CHURCH OF CHRIST AT ST. GEORGE 663436 Moncton Firefighters Benevolent Fund 016556 UNITED WAY OF GREATER SAINT INC. Inc. JOHN INC 003748 CLARENDON COMMUNITY 012003 NELSON CITIZENS COMMITTEE 676102 VOLLEYBALL PÉNINSULE ASSOCIATION INC. INC. ACADIENNE INC. 675825 CLUB 4X4 LES BOYS INC. 656990 NEW BRUNSWICK ASSOCIATION 004172 CONSEIL RECREATIF DE BOIS FOR SPIRITUAL CARE (NBASC) BLANC INC. INC. 025419 FONDATION DU BACCALAURÉAT ASSOCIATION NÉO- INTERNATIONAL/ÉCOLE BRUNSWICKOISE DE SOINS MATHIEU-MARTIN INC. SPIRITUELS (ANBSS) INC. The Royal Gazette — March 22, 2017 305 Gazette royale — 22 mars 2017

Partnerships and Business Loi sur l’enregistrement des Names Registration Act sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

TAKE NOTICE that, pursuant to sections 12.3 and 12.31 of the Part- SACHEZ QUE, conformément aux articles 12.3 et 12.31 de la Loi sur nerships and Business Names Registration Act R.S.N.B., 1973, c. P-5, l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations com- the Registrar under the said Act intends to cancel the registration of the merciales, L.R.N.-B. de 1973, ch. P-5, le registraire a l’intention, en certificates of partnership of the firms set forth in Schedule “A” an- vertu de ladite loi, d’annuler l’enregistrement des certificats de sociétés nexed hereto and the certificates of business names of the businesses en nom collectif indiquées à l’annexe « A » ci-jointe et des certificats set forth in Schedule “B” annexed hereto by reason of the fact the said d’appellations commerciales des commerces indiqués à l’annexe « B » firms and businesses have failed to register certificates of renewal in ci-jointe, en raison du fait que ces firmes ou commerces ont négligé de accordance with paragraph 3(1)(b) or (c) or subsection 3.1(2) or 9(7), faire enregistrer des certificats de renouvellement conformément à as the case may be applicable, of the said Act. l’alinéa 3(1)b) ou c) ou au paragraphe 3.1(2) ou 9(7) de ladite loi, selon le cas.

FURTHER TAKE NOTICE that at any time after the expiration date of SACHEZ AUSSI qu’en tout temps après la date d’expiration de trente thirty (30) days from the date of publication of this Notice, the Regis- (30) jours à partir de la date de publication du présent avis, le registraire trar may cancel the registration of the said certificates of partnerships peut annuler l’enregistrement desdits certificats de sociétés en nom and certificates of business names. collectif et certificats d’appellations commerciales.

Schedule “A” / Annexe « A » Certificates of Partnerships / Certificats de sociétés en nom collectif

623719 Bet-Ter Buys Sports 656712 McLaughlin Brothers Farms 661999 Studio 925 348858 Chignecto Research 630857 Pine Ridge Campground 662066 Terry & Son Tires 624152 Connell’s Grocery 656688 Restaurant Racines 662240 The Lazy Farmer Hostel 661747 DHS Investment 662187 ROADS TWO SAFETY SERVICES 662349 THE NAKED PAINTER 659956 GESTION DER-LO 630945 SAMARITAN FIRST AID AND 623384 Hockey Acadie Chaleur SAFETY TRAINING

Schedule “B” / Annexe « B » Certificates of Business Names / Certificats d’appellations commerciales

662261 A Chalet in Paradise 662242 Centre éducatif chez Joëlle 624281 DOWN HOME HEATING & 661972 Adam Richardson Trucking 600128 Century Sales & Service VENTILATION 341294 AGLINE 624638 Charles LeBlanc Counselling Services 662231 DWD Wedding Decor & Rentals 624649 AGRO NOR 662011 Chaussures JolyDame 662218 Dynasty Technology Sales 624324 AJMV Renovations 348835 CHI & MOUVEMENT 656490 E.M. DIOTTE CONSTRUCTION 662282 AL MAGOON CONTRACTING 662222 Chowder Catering SJ 662063 East Coast Electronics 662272 ARMOIRE DE CLAIR 661987 Christopher Doucette Painting 322098 EASTWOOD INSTRUMENTS 662252 Asymetric Renovations 630913 Chute Technology and Engineering 662276 ECO CAB 624398 Atlantic Beer Festival 662223 Clearview Equipment Sales 662162 ECO GUARDS - Innovative Eco 662136 Atlantic Chimney Repair & Restoration 325678 CLOW CANADA Solutions 662217 Atlantic Goaltending Academy / 662356 COASTAL ALUMINUM 662019 EDM Fire & Safety Specialists Académie de Gardien Atlantique MANUFACTURING 624712 Education - Jeunes aux Volants de Saint- 662110 ATLANTIC WELDING QAQC 662410 Coastal Fish Health Services Léonard CONSULTING 662072 Cocagne Lighthouse Takeout 624652 Elite Dog Grooming & Academy 624648 AU CHALET BED AND BREAKFAST 662315 Cocoro Patisserie 662113 Encan Auction Beresford 353484 AVW-TELAV 662154 Construction Navale Atlantique/Atlantic 662314 ESSER EUROPEAN STYLE BAKERY 353485 AVW-TELAV AUDIO VISUAL Boat Builders 661984 ET (Erik Theriault) Professional Painting SOLUTIONS 624198 Craig Allen Agency 661968 ExecYou Services 662427 Awesome Kids Day Care 662392 CROOKED CREEK ADVENTURES 624476 Exit Realty Platinum 662196 B WILSON TRUCKING 662120 D&D Bannister Trucking 340867 FABULON PRODUCTS 662084 BATH ADVANTAGE SYSTEMS 662319 Daksa Creators 662127 FLEETINC CONSULTING AND 662250 Betty Fitzpatrick Realty 662038 DAZZLE CAKES COFFEE 624146 Boiseries Atlantica Mouldings enr. 662052 Dealectronics Online 662112 FORFITNESS.CA 624481 Bruce’s Auto Inspection & Repair 662321 DiCarlo Auto Sales 662363 Forté Communication 662238 business-connect.ca 348819 DIGITAL HYBRID SOLUTIONS 662159 FREDDIE’S PIZZA 662322 C. Comeau Marketing 630307 Discount Plumbing 662186 FRESH STOP LUNCH STOP 656713 Cambridge-Narrows Campground 624687 Divine Wines 662275 G. Geldart Trucking 662426 CANOOSE OUTPOST 662247 DJ KLuZ 656737 Garnett Augustine Lounge 662134 Célébrité Cabinets and Woodworking 656721 Doll Dressed Up Clothing 662047 GAUTHIER MARINE 662423 Centre Chrétien de Clair 624526 Dou Rod & Gun 624711 Giffin Artworks 662034 Centre de remboursement de 662138 Down Home Bakery 335895 GOLDEN ARROWS SPORTS BAR Memramcook 656706 GSS’ Seniors and others Handyman The Royal Gazette — March 22, 2017 306 Gazette royale — 22 mars 2017

600129 H&A Supplies 662434 London Loc’s Hairstyling 624524 RAY’S SAW SHARPENING 662418 HANK’S CONSULTING 662241 Loose Auto Repair 662174 RAYMOND GOULD TRUCKING 662130 Hanwell Firewood and Works 340868 M.L. CAMPBELL 624129 RESTAURANT CHEZ NIC 662334 Harvey Studios 643431 M.R.S. 624528 Resti-Log Homes 624532 Heritage Cleaners 656708 Madam Mimi Adult Boutique 351370 RIVER VALLEY FOOTWEAR 662202 Hicks Berry Patch 662254 Majestic Moon 662032 S. D. EXCAVATING 661978 Hidro Trading Materials 661835 MALPEC PEAT MOSS 662263 SAINT CHARLES BEEKEEPING 624232 HOLICAN 662368 Manship & Sons Transit 662093 Saint John Youth Orchestra/Orchestre des 624233 HOLICAN INDUSTRIES 662195 Maritime Hang Gliding Academy jeunes de Saint John 348934 HONEYWELL 600131 Materials Management Services 624491 Salon Creation Unique chez Adele 662035 Hub City Landscaping International Canada 662307 SANTE ET CETERA 662306 HUNTER’S HI-TEK AUTO 656738 MAXMUZIK PRODUCTIONS 643769 Sapphire Global Services 662087 I LOVE SAINT JOHN POTTERY 662235 MBR HOLDINGS 662225 Second Chance Antiques & Collectibles 353487 I.S.T.S. THE SIMULTANEOUS 624222 McIlveen Medical Insurance 662233 securityconsult4u INTERPRETATION SPECIALISTS 661960 McKenzie Corner Outfitters 662125 Select Granite & Kitchens 662128 In-Source Technical Solutions 662001 MCL Loan Insure 662336 SERVICES ADM OUIMET 656702 INGALLS HEAD COTTAGES 661996 McQuinn Media 661986 Services d’ingénierie FR Engineering 351278 Irishtown Cycle 353518 MIKE HAMM JEWELLERY REPAIR Services 662061 Island Satellite & Security 662376 Mike’s Prestige Auto & Detailing 662288 Shari’s Office Solutions 662043 Islandview Special Care Home 662403 Mike’s Snow & Mow & More 662211 Sheffield Bio-Science 662304 J & T TOURS 662333 Miscou Blueberry Reg. 662030 Shooting Sprouts 662054 J-MART LIQUIDATION 624172 Miss Cow-girl Atlantique / Miss Atlantic 624290 Signature Communications 662190 J. Doiron’s Like New Auto Detail Cowgirl 662185 SOCIAL AD GIG Professionals 600132 MMSI Canada 662437 Southan Farms 662172 Jack Pine Pressure Washing Service 348937 MONCTON GOLF ACADEMY 662382 Straight Line Stripes 624473 JEAN’S RESTAURANT 662092 Moncton Youth Orchestra/Orchestre des 662358 SUGAR & SPICE BOWTIQUE 624474 JEAN’S RESTAURANT jeunes de Moncton 624550 Swanhaven Adult Residential Facility 351368 JMB INTERNATIONAL 661827 Morais Maintenance PC Plus 662165 T & T Dempsey Services FORWARDING 643430 MRS 322470 T.R.T. SALES 341292 JOHN DEERE CREDIT 350787 NADEAU EXCAVATION & FILS ENG. 662338 Teeka’s Nail Boutique 630983 Jonnie Java Roasters 661966 Natures Pet Spa 353482 TELAV/I.S.T.S. 662313 JS Quality RV Repair 624166 Nicholson’s Septic Tank Cleaning 662371 The DPL Group 662385 JVG Cleaning 624472 NITA’S BAR & GRILL 662262 The Penny Pinchers Emporium 662135 K&D Taxi 662069 Noah’s Ark Construction and Renovations 662104 The Roofing Connection 662269 Karen Grotterod Physiotherapy 661937 Northpay 338478 TINSEL THE CLOWN 662326 KAREN’S SIMPLE FOODS 661961 O Angel Cleaning 662004 Tippy Top Camp 351321 KCM CONSTRUCTION 624530 OCEAN DRAFTING 662057 TJ Furniture & Paint Restorations 600130 Kimrik Safety 661493 P B Modern Styles Hair Design 656715 TMT Landscaping 662171 Kingfisher Distributing 656726 Perfection for less Kitchen and Bath 661981 Tony’s Computer Repair Shop 624332 Kings County Performance 301882 PHOENIX RESTAURANT 662373 TRAVAILLEUR EXPRESS 662161 KV DECORATIVE CONCRETE 662170 Plaques du Nord 624592 Trinitea’s Cup 662033 L’atelier l’artisan de Memramcook 623621 PLAQUES GALORE / PLAQUES À 624636 Tweed-Eatery 661973 L.I.V. Leadership in Volunteerism GOGO 662340 Two Dogs Productions 662140 L.L. Tax Aid 661962 PLASTER ROCK GUARDIAN 662182 Villota Maintenance & Cleaning 624323 LA CAVE A VIN BOUDREAU 662103 Posi-Slope 662184 W.D. Hamiltons Landscaping 662078 La touche finale par Rachel/The final 661866 Postcard Portables Moncton 662407 WATER’S EDGE HAIR STUDIO touch by Rachel 662148 Precision Document Management 662404 Wedding Dreamz by Katherine Nantel 624470 Lawn Rangers 624512 Prestige Beauté Esthétique 661985 WELL KEPT LAWNS BY JOHN 624435 Leclerc Design Drafting Services 662051 PSR Roofing MURPHY 662246 LES PETITS TRESORS D’OLIVIER 630477 QUANTUM EMERGENCY RESPONSE 662062 West Isles Property Specialists 662221 LESTER’S CLEANING SERVICES 630476 QUANTUM HAZMA 662329 WJS Construction 662248 Lindsay Sporting Camps 630478 QUANTUM REMEDIATION 662070 XO Technologies 624122 LITTLE SHEMOGUE OYSTER FARM 662355 Quispamsis Planetary Growth 662362 Yves LeBlanc Auto Service 662124 Lockerbie & Hole Eastern 338463 RAPUNZEL’S

Loi sur les corporations Business Corporations Act commerciales PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commer- tions Act, a certificate of incorporation has been issued to: ciales, un certificat de constitution en corporation a été émis à : Reference Number Date Registered Office Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

ATNIV INC. Miramichi 693769 2017 02 22 694143 NB INC. Dieppe 694143 2017 02 07

Aristotle Real Marketing Group Ltd. Moncton 694207 2017 02 09 Bogtrotter Craft Brewery Ltd. Rusagonis 694362 2017 02 21 The Royal Gazette — March 22, 2017 307 Gazette royale — 22 mars 2017

SCOTTY’S MEAT MARKET INC. Scotch Settlement 694400 2017 02 23 694405 N.B. Ltd. Saint John 694405 2017 02 23 DOWMAR Inc. Saint John 694406 2017 02 23 Titan Heating and Cooling Inc. Killarney Road 694412 2017 02 23 B&B Waste Management Ltd. Newtown 694413 2017 02 23 MFox Holdings Inc. Hartford 694415 2017 02 23 DFox Holdings Inc. Hartford 694417 2017 02 23 KATIE KELLY PHYSIOTHERAPY P.C. INC. Lutes Mountain 694419 2017 02 23 Canada East Rides Inc. Fredericton 694421 2017 02 23 694422 N.B. INC. Upper Kingsclear 694422 2017 02 23 NORTH GRAIN COMPANY LTD. Saint John 694423 2017 02 23 Pêcheries Y & J Ltée Caraquet 694424 2017 02 23

PDM Management Group Inc. Dieppe 694426 2017 02 23 694428 N.B. Inc. Grand Bay-Westfield 694428 2017 02 23 OR ET ARGENT ACADIEN GOLD & SILVER INC. Saint-Sauveur 694431 2017 02 24 Moncton VHM H2 Hotel GP Inc. Moncton 694432 2017 02 24 SLE CONTRACTING SERVICES LTD. Odell 694433 2017 02 24 JB Nettoyage Ltee Sainte-Anne-de-Madawaska 694434 2017 02 24 T M Breneol & Associates Inc. Grand Bay-Westfield 694439 2017 02 24 694440 NB LTD. Bay du Vin 694440 2017 02 24 Feel good Therapy and Pain Management Inc. Dieppe 694448 2017 03 01 LebCor Holdings Inc. Cap-Pelé 694449 2017 02 24 Pharmacie François LeBlanc Inc. Cap-Pelé 694451 2017 02 27 Armoires Qualitek Inc. Saint-Irenée 694452 2017 02 27 694453 NB INC. Anfield 694453 2017 02 27 694455 NB INC. Saint John 694455 2017 02 27 CRYSTAL RICHARD & COMPANY INC. Dieppe 694456 2017 02 27 694457 NB INC. Quispamsis 694457 2017 02 27 Gusto Designs Ltd. Fredericton 694460 2017 02 27 TOP TIER DEVELOPMENTS INC. Petitcodiac 694461 2017 02 27 BRAKE FORM INC. Moncton 694463 2017 02 27 694465 NB Ltd. Upper Coverdale 694465 2017 02 27 RD MENDOZA CLEANING LTD. Saint John 694466 2017 02 27

694467 N.-B. Inc. Bas-Caraquet 694467 2017 02 27 Blue Jays Holdings Ltd. Penobsquis 694471 2017 02 27 Blacquier Investments Inc. Fredericton 694472 2017 02 27 The West Siders Ltd. Saint John 694473 2017 02 27 The Royal Gazette — March 22, 2017 308 Gazette royale — 22 mars 2017

Brittain Seale Holdings Inc. Saint John 694476 2017 02 27 694478 N.B. Inc. Drummond 694478 2017 02 27 Edmond l’art de spiner Inc. Bas-Caraquet 694484 2017 02 27 694488 NB Inc. St-Joseph-de-Madawaska 694488 2017 02 27 Jeramand Trucking Ltd. Irishtown 694490 2017 02 27 694494 NB Inc. Quispamsis 694494 2017 02 28 IVAN’S CAMERA (2017) LTD. - CAMERA YVON (2017) Moncton 694495 2017 02 28 LTEE AMAM Holdings Inc. Hampton 694496 2017 02 28 SMTM Holdings Inc. Hampton 694497 2017 02 28 PSM TRANSPORT INC. Saint-Quentin 694500 2017 02 28 694502 NB INC. Edmundston 694502 2017 02 28

Centre de Remboursement Bossé Inc. Saint-Quentin 694504 2017 02 28 ZJRD Consulting Inc. Moncton 694506 2017 02 28 AAC Leger Holdings Inc. Cormier Village 694509 2017 02 28 Graef Financial Inc. Hampton 694510 2017 02 28 T.FERRON CONSTRUCTION INC. Sainte-Marie-Saint-Raphaël 694515 2017 02 28 MA Holdings Inc. Colpitts Settlement 694518 2017 02 28 694520 N.B. Inc. Shediac Bridge 694520 2017 02 28 694521 NB INC. Moncton 694521 2017 02 28 Bare Blossom Skincare & Organics Inc. Salt Springs 694523 2017 02 28 East Winds Silviculture Inc. Canterbury 694528 2017 03 01 Emson Transport Inc. White Rapids 694534 2017 03 01 TELK Holdings Ltd. Linton Corner 694541 2017 03 01 Paper Engineering Plus Inc. Fredericton 694543 2017 03 01 BEST H FLOW CONTROL LTD. Rothesay 694545 2017 03 01 HTT AUTOMATION TRADING LTD. Saint John 694546 2017 03 01 694552 NB INC. Dieppe 694552 2017 03 01 Charles Y&L Holdings Ltd. Lutes Mountain 694555 2017 03 01 SAFF HOLDING INC. Moncton 694556 2017 03 01 Health and Wellnesss Sussex Inc. Sussex 694557 2017 03 01 Cyber Fundamentals Inc. Fredericton 694562 2017 03 02 Services Industriels Péninsule Ltée / Peninsula Industrial Inkerman Ferry 694563 2017 03 02 Services Ltd. The Green Corner, Inc. Harewood 694564 2017 03 02 Pineo & Kranendonk Plumbing & Heating Ltd. Fredericton 694565 2017 03 02 A-1 Overhead Door Service and Installations Inc. Grand Bay-Westfield 694566 2017 03 02 694579 NB Inc. Burtts Corner 694579 2017 03 02 The Royal Gazette — March 22, 2017 309 Gazette royale — 22 mars 2017

Elisell Consultants Ltd. Saint John 694582 2017 03 02 Denis Ouellette PC Ltée. Grand-Sault / Grand Falls 694588 2017 03 02 Fluor BNA GP Inc. Saint John 694592 2017 03 02 Fluor BNA Holdco Inc. Saint John 694594 2017 03 02 ALMAX TRUCKING LTD. Bedell 694596 2017 03 03 Pêcheries DGZ Ltée Lamèque 694597 2017 03 03 694598 NB Ltée Lamèque 694598 2017 03 03 694599 N.B. Inc. Moncton 694599 2017 03 03 694600 NB Corp. Bathurst 694600 2017 03 03 GJR Employee Benefit Consulting Inc. Richibucto Road 694602 2017 03 03 DANIEL LEVESQUE CONSTRUCTION ET RENOVATION Saint Leonard 694603 2017 03 03 LTD. Sagolj Trucking Inc. Woodstock 694614 2017 03 03 AtlantiCan Manufacturing, Trading & Service Inc. Moncton 694616 2017 03 03 ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpo- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, rations Act, a certificate of continuance has been issued to: un certificat de prorogation a été émis à : Previous Reference Jurisdiction Number Date Registered Office Compétence Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Bureau enregistré antérieure référence année mois jour

Cumberland Paving and Contracting Limited Moncton Nouvelle-Écosse / 694536 2017 03 01 Nova Scotia Cumberland Aggregates Limited Moncton Nouvelle-Écosse / 694537 2017 03 01 Nova Scotia Blue Country Insurance Ltd. Fredericton Terre-Neuve-et- 694551 2017 03 01 Labrador / Newfoundland and Labrador HealthPro (2006) Inc. Fredericton Nouvelle-Écosse / 694553 2017 03 01 Nova Scotia ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of amendment has been issued to: un certificat de modification a été émis à :

Date Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

500820 N.B. Ltd. 500820 2017 03 03 L.C. ENTERPRISE INC. 511841 2017 02 28 GORGE PROPERTY MANAGEMENT INC. 603946 2017 03 02 Madras Investments (2005) Inc. 622464 2017 03 03 The Royal Gazette — March 22, 2017 310 Gazette royale — 22 mars 2017

638570 N.B. Ltd. 638570 2017 02 27 Maritime Quality Consulting Ltd. 659437 2017 03 01 Sentrant Security Inc. 666944 2017 03 01 Dr. Jeremy Blacquier Professional Corporation 673247 2017 02 27 676054 N.B. INC. 676054 2017 02 28 Dango Inc. 680720 2017 02 28 683301 N.B. Inc. 683301 2017 02 28 Chinova Bioworks Inc. 688963 2017 02 27 693203 NB INC. 693203 2017 02 27 Meltone Inc. 693991 2017 03 01 ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of amendment which includes a change in un certificat de modification contenant un changement de raison name has been issued to: sociale a été émis à :

Date Previous name Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Ancienne raison sociale Numéro de référence année mois jour

031638 N.B. LTD. IVAN’S CAMERA LTD. - 031638 2017 02 28 CAMERA YVON LTEE Dr. Cindy McCormick Professional Corporation DRS. CLIFFORD and McCORMICK 601816 2017 03 02 PROFESSIONAL CORPORATION Human Performance Physiotherapy Inc. Human Performance Fitness Inc. 648590 2017 03 03 RALPH JUNIOR WELDING LTD. Ballaboom Welding Ltd. 676399 2017 03 02 Dream Alliance Inc. 694181 N.B. Inc. 694181 2017 02 24 ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of amalgamation has been issued to: un certificat de fusion a été émis à : Reference Number Date Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Registered Office Numéro de Year Month Day Corporation issue de la fusion Corporations fusionnantes Bureau enregistré référence année mois jour

Val Boucher Construction Ltd. VAL BOUCHER CONSTRUCTION Lutz Mountain 694276 2017 03 01 LTD. BOUCHER HOLDINGS LTD. ELDRIDGE’S HOLDINGS LTD. ELDRIDGE’S HOLDINGS LTD. Saint John 694435 2017 02 28 ELDRIDGE AUTHORIZED RENTALS LTD.

Monique LeBlanc Créations Inc. CINIMAGE PRODUCTIONS INC. Dieppe 694454 2017 03 01 Monique LeBlanc Creations Inc. LONE PINE EXPLORATION NICON HOLDINGS LTD. South Tetagouche 694531 2017 03 01 SERVICES LTD. LONE PINE EXPLORATION SERVICES LTD. The Royal Gazette — March 22, 2017 311 Gazette royale — 22 mars 2017

051520 N. B. LTD. 051520 N. B. LTD. Fredericton 694532 2017 03 01 MIXED ON-SITE CONCRETE LTD. Dolma Food Inc. DOLMA FOOD INC. Moncton 694533 2017 02 28 668290 N.B. INC. MacDonald Paving and MacDonald Paving and Construction Moncton 694538 2017 03 01 Construction Limited Limited Cumberland Paving and Contracting Limited Cumberland Aggregates Limited Blue Country Insurance Ltd. 693935 NB INC. Fredericton 694554 2017 03 01 Blue Country Insurance Ltd. HealthPro (2006) Inc.

Selco Equipment Sales Ltd. SELCO EQUIPMENT SALES LTD. Fredericton 694561 2017 03 01 647068 N.B. Inc. 693936 N.B. LTD. MARIA HENHEFFER PROFESSIONAL MARIA HENHEFFER Saint John 694571 2017 03 01 CORPORATION PROFESSIONAL CORPORATION M.G. Henheffer P.C. Inc.

Michael Brenton Professional Michael Brenton Professional Saint John 694572 2017 03 01 Corporation Corporation M.D. Brenton P.C. Inc. NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUM Business Corporations Act / Loi sur les corporations commerciales

In relation to a Certificate of Registration of Amalgamated Corporation issued on January 15, 1996, under the name of “IMPERIAL OIL RESOURCES LIMITED”, being corporation #075241, notice is given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate, correcting the name of the corporation from “IMPERIAL OIL RESOURCES LIMITED” to “IMPERIAL OIL RESOURCES LIMITED/PETROLIERE IMPERIALE RESSOURCES LIMITEE”.

Sachez que, relativement au certificat d’enregistrement d’une corporation issue d’une fusion délivré le 15 janvier 1996 à « IMPERIAL OIL RESOURCES LIMITED », dont le numéro de corporation est 075241, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat corrigé faisant passer le nom de la corporation de « IMPERIAL OIL RESOURCES LIMITED » à « IMPERIAL OIL RESOURCES LIMITED/PETROLIERE IMPERIALE RESSOURCES LIMITEE ». ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of dissolution has been issued to: un certificat de dissolution a été émis à : Reference Number Date Registered Office Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

FERME BELLEVUE LTEE - FARM BELLEVUE LTD. Grand-Sault / Grand Falls 006161 2017 02 27 STATION FRAMING & SHEETING LTD. Grand-Sault / Grand Falls 030038 2017 02 27 FOURNIER’S BEVERAGE ROOM LTD. Campbellton 058963 2017 02 27 Gebhardt Marketing Ltd. Jemseg 647338 2017 02 24 652174 N.B. Ltd. Quispamsis 652174 2017 02 17

673084 N.B. Inc. Saint John 673084 2017 02 27 Taylor Made Home Inspections Inc. Centreville 678257 2017 02 27 ______The Royal Gazette — March 22, 2017 312 Gazette royale — 22 mars 2017

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of discontinuance has been issued to: un certificat de cessation a été émis à :

Date Jurisdiction of Continuance Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Compétence de prorogation Numéro de référence année mois jour

658608 N.B. Inc. Nouvelle-Écosse / Nova Scotia 658608 2017 02 21 ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of revival has been issued to: un certificat de reconstitution a été émis à :

Date Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

PROVINCIAL SECURITY AND INVESTIGATION SERVICES LTD. 509603 2017 02 21

Fremato Canada Ltd. 619451 2017 03 01 N. BARRY PHARMACY LTD. 622910 2017 02 22 GREEN TREE HOLDINGS INC. 634074 2017 02 23 645062 NB Inc. 645062 2017 03 01 Underground 101 Inc. 655319 2017 02 27 Designed Ventures Inc. 658316 2017 02 27 GESTION DERIK FOULEM INC. 662781 2017 02 23 GESTION DAVID JOEL FOULEM INC. 662850 2017 02 23 Advanced Heli Core Inc. 669245 2016 02 27 Redsky Business Solutions Inc. 670873 2017 02 17 ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of registration of extra-provincial corporation un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a été has been issued to: émis à : Reference Number Date Jurisdiction Agent and Address Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Compétence Représentant et adresse référence année mois jour

(D.T.) SECURE TECHNOLOGIES Canada Robert Coates 694123 2017 03 01 INTERNATIONAL INC. St. Stephen GRIMARD OPTIQUE INC. Canada Jenny LeBlanc 694443 2017 02 24 Campbellton MSW INSPECTION SERVICES LTD. Canada Walter Robert Nixon 94447 2017 02 24 Boiestown

CASHCO PDL INC. Alberta Stewart McKelvey Corporate 694462 2017 02 27 Services (NB) Inc. Saint John 9 ALLAN WEEKS REAL ESTATE Île-du-Prince-Edouard / Tracy L. Wong 694469 2017 02 24 COMPANY LTD. Prince Edward Island Moncton The Royal Gazette — March 22, 2017 313 Gazette royale — 22 mars 2017

Recrutement GradsFinder inc. Québec / Quebec Thierry Comtois 94512 2017 02 28 GradsFinder Recruiting inc. Moncton STAFFORD COMMUNICATIONS New Jersey Kevin Schofield 694513 2017 02 28 GROUP, INC. Rothesay 6798021 CANADA INC. Canada Sonia St-Pierre 694514 2017 02 28 Edmundston POSERA LTD. Ontario Stewart McKelvey Corporate 694535 2017 03 01 Services (NB) Inc. Saint John Return to Prime Ltd. Canada McInnes Cooper CSD 694570 2017 03 02 Retour au préférentiel ltée Services Inc. Fredericton MULLEN TRUCKING CORP. Alberta Stewart McKelvey Corporate 694573 2017 03 02 Services (NB) Inc. Saint John

TENOLD TRANSPORTATION LTD. Alberta Stewart McKelvey Corporate 694574 2017 03 02 Services (NB) Inc. Saint John PAYNE TRANSPORTATION LTD. Alberta Stewart McKelvey Corporate 694575 2017 03 02 Services (NB) Inc. Saint John 9286-5591 Québec inc. Québec / Quebec Stewart McKelvey Corporate 694577 2017 03 02 Services (NB) Inc. Saint John

MTY TIKI MING ENTERPRISES INC. Canada Stewart McKelvey Corporate 694578 2017 03 02 LES ENTREPRISES MTY TIKI MING Services (NB) Inc. INC. Saint John

Promana Consulting Inc. Terre-Neuve-et- Robert William Power 694587 2017 03 02 Labrador / Quispamsis Newfoundland and Labrador CENTRICA CONNECTED HOME Alberta Stewart McKelvey Corporate 694606 2017 03 03 CANADA INC. Services (NB) Inc. Saint John Enkidu Inc. Canada Ross Pierce 694608 2017 03 03 Saint John MISA HAPPY HOUSE INC. Canada Thi Ngoc Lan Dang 694622 2017 03 03 Fredericton TECTRAN CO. Nouvelle-Écosse / Gino Pelletier 694635 2017 03 03 Nova Scotia Robertville ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of amendment of registration of extra- un certificat de modification de l’enregistrement de corporation provincial corporation has been issued to: extraprovinciale a été émis à : Reference Number Date Previous name Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Ancienne raison sociale référence année mois jour

VERITIV CANADA, INC. UNISOURCE CANADA, INC. 076218 2017 03 01 The Royal Gazette — March 22, 2017 314 Gazette royale — 22 mars 2017

NTP/Stag Canada Inc. Les Entreprises NTP/Stag Canada Inc. 077255 2017 03 02 NTP/Stag Canada Enterprises Inc. 35601 CUMMINS CANADA ULC 35601 Yukon Inc. 620137 2017 03 01 ContiTech Canada, Inc. VEYANCE TECHNOLOGIES CANADA, INC./ 633455 2017 03 02 ContiTech Canada inc. TECHNOLOGIES VEYANCE CANADA, INC.

Labatt Brewing Trading Company SOCIÉTÉ DE COMMERCE BRASSERIE 669398 2017 03 01 Ltd. Société de Commerce MILLER, LTÉE/MILLER BREWING Brasserie Labatt Ltée TRADING COMPANY, LTD. MCLEAN HALLMARK INSURANCE Moore-McLean Insurance Group Ltd. 677675 2017 02 27 GROUP LTD. ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, the Director has made a decision to cancel the registration le Directeur a décidé d’annuler l’enregistrement des corporations ex- of the following extra-provincial corporations: traprovinciales suivantes : Proposed Cancellation Reference Notice Date Date / Date de Number Date de l’avis l’annulation projetée Jurisdiction Agent Numéro de Year Month Day Year Month Day Name / Raison sociale Compétence Représentant référence année mois jour année mois jour

3324346 Canada Inc. Canada Willard M Jenkins 075804 2017 03 06 2017 06 05 Saint John Renee’s Gourmet Foods Inc. Ontario Stewart McKelvey 648866 2017 03 06 2017 06 05 Corporate Services (NB) Inc. Saint John 7743882 Canada Inc. Canada Stewart McKelvey 655314 2017 03 06 2017 06 05 Corporate Services (NB) Inc. Saint John NBC Covered Bond GP Inc. Canada Stewart McKelvey 655353 2017 03 06 2017 06 05 Corporate Services (NB) Inc. Saint John VALEANT PHARMACEUTICALS Colombie Britannique / Stewart McKelvey 662343 2017 03 06 2017 06 05 INTERNATIONAL INC. British Columbia Corporate Services (NB) Inc. Saint John Redberry Franchising Corp./ Ontario Peter R. Forestell 667258 2017 03 06 2017 06 05 La Corporation des Saint John Franchises Redberry 8741824 Canada Incorporated Canada Paul C. Levesque 674431 2017 03 06 2017 06 05 Fredericton MULTIONE EQUIPMENT Alberta Stewart McKelvey 681755 2017 03 06 2017 06 05 (CANADA) INC. Corporate Services (NB) Inc. Saint John BLUE BIRCH LEASING LTD. Canada McInnes Cooper CSD 684501 2017 03 06 2017 06 05 Services Inc. Fredericton The Royal Gazette — March 22, 2017 315 Gazette royale — 22 mars 2017

AVENIR CONSOLIDATED Alberta Stewart McKelvey 686708 2017 03 06 2017 06 05 CORPORATION Corporate Services (NB) Inc. Saint John ENTREPRISE GRAND’MA INC. Québec / Quebec DOCU-TEK 687227 2017 03 06 2017 06 05 INCORPORATED Fredericton Fresh Word Promotions, Inc. Terre-Neuve-et- Heidi Mackay 692093 2017 03 06 2017 06 05 Labrador / Riverview Newfoundland And Labrador MADIBA HOLDING Ontario Stewart McKelvey 692429 2017 03 06 2017 06 05 CORPORATION Corporate Services (NB) Inc. Saint John RC CAPITAL INC. Ontario Stewart McKelvey 692430 2017 03 06 2017 06 05 Corporate Services (NB) Inc. Saint John AttaDot Incorporated Canada Stewart McKelvey 692431 2017 03 06 2017 06 05 Corporate Services (NB) Inc. Saint John ______

PUBLIC NOTICE is hereby given, under the Business Corporations SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, Act, of the cancellation of the registration of the following extra- un avis d’annulation a été émis aux corporations extraprovinciales provincial corporations: suivantes : Reference Number Date Jurisdiction Agent Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Compétence Représentant référence année mois jour

Irving Oil Terminals, Inc. Delaware Chris Borden 615479 2017 03 06 Saint John W. H. Scrivens & Son Limited Ontario Stewart McKelvey 647767 2017 03 06 Corporate Services (NB) Inc. Saint John Les Restaurants M.G. Guérette Inc. Québec / Quebec Chantal Godin 648235 2017 03 06 Dalhousie Junction EASTWIND INSURANCE AGENCY LTD. Canada Jeffrey Hoyt 653085 2017 03 06 Saint John The Builders Warehouse Inc. Canada Adel Gönczi 653254 2017 03 06 Moncton HIGHLANDS FUEL DELIVERY, LLC Maine Chris Borden 659352 2017 03 06 Moncton PRIMUS TELECOMMUNICATIONS CANADA Ontario Stewart McKelvey 673484 2017 03 06 INC. Corporate Services (NB) Inc. Saint John CORNERSTONE INSURANCE BROKERS Ontario Stewart McKelvey 682513 2017 03 06 LIMITED Corporate Services (NB Inc. Saint John The Royal Gazette — March 22, 2017 316 Gazette royale — 22 mars 2017

JTS INSPECTION LTD. Alberta W. Rodney Macdonald 691432 2017 03 06 Saint John ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of registration of amalgamated corporation un certificat d’enregistrement d’une corporation extraprovinciale has been issued to the following extra-provincial corporations: issue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales sui- vantes : Reference Agent and Address Number Date Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Représentant et Numéro de Year Month Day Corporation issue de la fusion Corporations fusionnantes adresse référence année mois jour

SCHLUMBERGER CANADA SCHLUMBERGER CANADA McInnes Cooper CSD 694489 2017 02 27 LIMITED LIMITED Services Inc. Saint John QUADRA CHEMICALS LTD. QUADRA CHEMICALS LTD. Stewart McKelvey 694507 2017 02 28 QUADRA CHIMIE LTÉE Corporate Services (NB) Inc. Saint John NTP/Stag Canada Inc. NTP/Stag Canada Inc. McInnes Cooper CSD 694590 2017 03 02 Services Inc. Fredericton DIRECT ENERGY MARKETING DIRECT ENERGY MARKETING Stewart McKelvey 694605 2017 03 03 LIMITED LIMITED Corporate Services (NB) Inc. Saint John

Companies Act Loi sur les compagnies PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act, SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres letters patent have been granted to: patentes ont été émises à : Reference Number Date Head Office Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Siège social référence année mois jour

SAINT JOHN IRANIAN COMMUNITY INC. Saint John 693890 2017 02 17 Hawthorn Hill Academy Incorporated Riverview 693894 2017 02 20 Nourishing Minds NB Inc. Fredericton 694310 2017 02 17 Saint John Festival of Sail Inc. Saint John 694373 2017 02 21 St. George and Area Food Bank Inc. St. George 694374 2017 02 21 The Royal Gazette — March 22, 2017 317 Gazette royale — 22 mars 2017

Loi sur l’enregistrement des Partnerships and Business Names sociétés en nom collectif et des Registration Act appellations commerciales PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en Business Names Registration Act, a certificate of business name has nom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appel- been registered: lation commerciale a été enregistré : Registrant of Address of Business Reference Certificate or Agent Number Date Enregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

Académie Restigouche Academy RESTIGOUCHE HOME CARE Charlo 694023 2017 03 01 (2016) Inc. Green Bay Trucking Kevin Beckwith Baie Verte 694090 2017 03 01 MP Versatile Construction Michelle Poirier Moncton 694244 2017 02 13 and Management R. Mitton Custom Carpentry Roland Mitton Wheaton Settlement 694304 2017 02 16 East Coast Court Evaluations Michelle Landry-Reyes Moncton 694320 2017 03 01 & Counselling Services LES EVENEMENTS ACADIEN Micheal Kelly Tracadie-Sheila 694322 2017 02 17 R. Dickeson Plumbing Ralph Dickeson Killarney Road 694395 2017 02 22 Yoga Break Canada Anicka Senior Fredericton 694430 2017 02 24 Logan Dickinson Painting Logan Dickinson Wakefield 694441 2017 02 24 PURE entretien ménager Isabelle McGraw Saint-Jacques 694442 2017 02 24 LUNETTERIE GO EYEWEAR GRIMARD OPTIQUE INC. Campbellton 694444 2017 02 24 Bike-R-Way Bicycle repair Bernard Rousselle Cap-Pelé 694450 2017 02 25 and service shop FREDERICTON CAMERA SERVICE Andriy Volikhovskyy Fredericton 694458 2017 02 27 R.L Roofing Services Rodney Legace Memramcook 694459 2017 02 27 Bill’s Cottage Composters Bill Hamilton Fredericton 694468 2017 02 27 MARITIMEFARMREALTY.COM ALLAN WEEKS REAL ESTATE Moncton 694470 2017 02 24 COMPANY LTD. DR. KATE MCLELLAN MED. RCT. Kate McLellan Rothesay 694474 2017 02 27 COUNSELLING AND CONSULTING SERVICES Rita’s Home Blood Collection Rita Parsons Burton 694475 2017 02 27 SVH Distribution 689815 NB INC. Leech 694479 2017 02 27 Magasin chez Bernard 689815 NB INC. Pont-LaFrance 694480 2017 02 27 RAY’S RESTORATIONS Raymond Leger MacDougall Settlement 694482 2017 02 27 CENTRE SHEDIAC RV CENTRE TIME 2 SHINE INC. Shediac 694486 2017 02 27

Warren Enterprises WARREN READY- MIX LTD. Rexton 694487 2017 02 27 Fox’s Custom Sawmilling Scot Fox Pokiok 694491 2017 02 27 MacLEOD’s Anvil - Armoury & John MacLeod Hoyt 694492 2017 02 27 Forgeworks The Royal Gazette — March 22, 2017 318 Gazette royale — 22 mars 2017

Timeless Fitness Matthew-Jay Cormier Turtle Creek 694493 2017 02 27 RIDGE MACHINE QUILTING Rennick Media Ltd. Keswick Ridge 694498 2017 02 28 Stillpoint Yoga and Massage Paige Danaher Saint John 694499 2017 02 28 Centre Pete Poulos Carpentry Peter Poulos Keswick Ridge 694501 2017 02 28 Services Robertson’s Country Store Stephen Robertson Mundleville 694503 2017 02 28 Smitty’s Trucking Wayne Smith St. Margarets 694505 2017 02 28 GIANT TIGER TORA BATHURST (222) Quispamsis 694508 2017 02 28 LIMITED S&C Insulation Chantalle Kydd Cocagne 694511 2017 02 28 Ayat Timbers International Muhammad Javed Fredericton 694519 2017 02 28 Norton Shore Farm Trevor Fulton Hampton 694524 2017 02 28

Serenity Now Bath and Body Tammy Lee Neil Riverview 694526 2017 03 01 Clouston Photography Carol Clouston Riverview 694527 2017 03 01 Cumberland Aggregates MacDonald Paving and Moncton 694539 2017 03 01 Construction Limited Cumberland Paving and MacDonald Paving and Moncton 694540 2017 03 01 Contracting Construction Limited E K CLASSIC STYLE ELENA KRAMER Scotch Lake 694542 2017 03 01 The Brookside Butcher Mark Anthony Folkins Sainte-Marie-de-Kent 694544 2017 03 01 CAFÉ MARIS STELLA ENR. Gilbert Blanchard Bas-Caraquet 694547 2017 03 01 TAY’S TEAZ & DELIVEREEZ Tanya Christine Palmater Eel River Bar First Nation 694549 2017 03 01 Le Bonheur est LÂ, Service Julie Arseneault Saint-Laurent 694550 2017 03 01 et soutien Phychologique EMPIRE SOLOKOURE Daouda Diallo Moncton 694559 2017 03 01 AAA Storage B & B INVESTMENTS LTD. Fredericton 694560 2017 03 01 C & M Dentcare Chrisanna McGlinchey Fredericton 694585 2017 03 02 CBRE CBRE Limited Fredericton 694589 2017 03 02 The Coast Distribution NTP/Stag Canada Inc. Fredericton 694591 2017 03 02 System Carnation Chinese Restaurant Goh Holdings Ltd. Oromocto 694633 2017 03 03 BRUNSWICK BEVERAGES J.P. Blain Mobile Moncton 694634 2017 03 03 Service Inc. ______The Royal Gazette — March 22, 2017 319 Gazette royale — 22 mars 2017

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en Business Names Registration Act, a certificate of renewal of business nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re- name has been registered: nouvellement d’appellation commerciale a été enregistré : Registrant of Address of Business Reference Certificate or Agent Number Date Enregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

SALON DE BARBIER CLIPSO Yvette LeBlanc Saint-Antoine 325441 2017 03 05 BARBER SHOP THE DIPLOMAT RESTAURANT KIL INVESTMENTS LTD. Fredericton 327721 2017 03 01 E.W. BLAKNEY & ASSOCIATES EDWARD BLAKNEY Moncton 328872 2017 02 27 DEBLY FOREST PRODUCTS DEBLY FOREST SERVICES Saint John 340991 2017 02 27 LTD. DEBLY LOGGING DEBLY FOREST SERVICES Saint John 340992 2017 02 27 LTD. EQUIPMENT SOLUTIONS Snap-on Tools of Canada Saint John 342749 2017 03 01 Ltd. Outils Snap-on Du Canada Ltée MOUNT PLEASANT FARMS Arthur Ronalds Bathurst 348631 2017 02 27 “Leamans” Repair Shop Darren Leaman Turtle Creek 348700 2017 02 28

TRAINING SOLUTIONS, A SNAP- Snap-on Tools of Canada Saint John 350444 2017 03 01 ON SERVICES GROUP Ltd. Outils Snap-on Du Canada Ltée Border Fire & Res-Q JAMES BROWN Oak Bay 350932 2017 03 03 R & H Interior Finish WILLIAM K McKELLAR Albrights Corner 351053 2017 02 28 Norbert’s Trucking NORBERT MARTIN Shediac 351143 2017 03 02 BUCKWHEAT PETE DIGITAL Peter De Niverville Riverview 351185 2017 03 02 PRODUCTIONS PICTURES IN THREAD Margaret Brown Lower Brighton 351228 2017 02 24 MISS WHITE GOLD PAGEANT Valorie Walsh Miramichi 600898 2017 02 27 SPHERION Randstad Intérim Inc. / Saint John 615659 2017 03 03 Randstad Interim Inc. DIRECT ENERGY DIRECT ENERGY MARKETING Saint John 616929 2017 03 03 LIMITED St George Mini-Mart & Laundromat Anverali Rahemtulla Moncton 623037 2017 02 24 APPLEBY PROPERTY Kenneth Appleby Cambridge-Narrows 623708 2017 03 05 MANAGEMENT Rankin Photography Shelley Rankin Fredericton 623925 2017 03 03 City & District Web Development Philip E. Tetreault Quispamsis 623982 2017 02 27 ADVANCE SAVINGS CREDIT Advance Savings Credit Moncton 626564 2017 02 24 UNION Union Limited

IMAGINiT Technologies RAND A TECHNOLOGY Fredericton 629527 2017 03 02 CORPORTION DIPLOMAT EGG ROLLS KIL INVESTMENTS LTD. Fredericton 630173 2017 03 01 DIPLOMAT FOODS KIL INVESTMENTS LTD. Fredericton 630174 2017 03 01 The Royal Gazette — March 22, 2017 320 Gazette royale — 22 mars 2017

PRO-MEDIX THE STEVENS COMPANY Saint John 630555 2017 03 03 LIMITED DIRECT ENERGY BUSINESS DIRECT ENERGY MARKETING Saint John 649445 2017 03 03 LIMITED DIRECT ENERGY HOME DIRECT ENERGY MARKETING Saint John 649446 2017 03 03 SERVICES LIMITED Teva Novopharm Teva Canada Limited/Teva Saint John 650332 2017 02 17 Canada Limitée QUADRA INGREDIENTS - QUADRA CHEMICALS LTD. Saint John 653512 2017 02 28 QUADRA INGRÉDIENTS QUADRA CHIMIE LTÉE Randstad Technologies Randstad Intérim Inc. / Saint John 658060 2017 03 03 Randstad Interim Inc. Dewey’s Green & White Property Duane Johnson Gagetown 660828 2017 02 27 Care ELLEISO PLANNING DAVID NICKERSON Quispamsis 660856 2017 02 24

Centrework Pilates & Movement Lindsey Laidlaw New Maryland 660878 2017 02 28 Integration MONCTON CRUISESHIPCENTERS 660412 N.B. Inc. Moncton 661107 2017 03 03 AppMaverix Studios Scott Bulman Riverview 661364 2017 03 04 DC’s Small Engine Express Dwayne Campbell Rothesay 661437 2017 03 03 Naturothérapie L’Estrella Rachelle Roy Arseneau Beresford 661533 2017 02 28 JJJ ELECTRICAL MARK L. WRIGHT Lincoln 661601 2017 02 27 La vieille école de Miscou Michèle Garceau Miscou 661622 2017 02 27 Miramichi Northwest Lodge Carmen Bazinet Sorel Wayerton 661657 2017 03 03 River Valley Ventilation & Heating Luke Dukeshire Northampton 661662 2017 02 28 SWIT SWOO SERVICES Harvey A. Hillis Florenceville-Bristol 661669 2017 02 28 Tidal Pool Software Adrian Baerlocher Sackville 661722 2017 02 28 MAISONS LEVESQUE GÉRANCE DE PROJET Dieppe 661724 2017 02 27 RÉSIDENTIEL LEVESQUE INC. MELROSE ROCK & FILL CO. Harold Allen Upper Cape 661736 2017 02 24 Prescott Farms Prescott R. Alan Sackville 661738 2017 02 28 Esthétique Sublime Louella Giroux Dalhousie 661790 2017 03 02 Nava Yoga Studio Leanne Laracey Sackville 661824 2017 03 03 The York Bistro & Pub InnVest Hotels GP Ltd. Saint John 662741 2017 03 03 OSCO Concrete OSCO Concrete & Saint John 662875 2017 03 03 Aggregates Limited THE BEACH HOUSE BED AND LYNN HUMPHRIES Alma 663627 2017 03 01 BREAKFAST ALMA ______The Royal Gazette — March 22, 2017 321 Gazette royale — 22 mars 2017

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en Business Names Registration Act, a certificate of cessation of busi- nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessa- ness or use of business name has been registered: tion de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation com- merciale a été enregistré : Reference Number Date Address / Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Adresse référence année mois jour

AAA Storage Fredericton 623770 2017 03 01 Alpha-Nautique Caraquet 637198 2017 03 02 Centre de Remboursement Gaetan Bossé Saint-Quentin 645298 2017 02 28 B.K. SETHI DISTRIBUTION Concord 661260 2017 03 03 Photo Moncton International Riverview 681109 2017 03 01 Health and Wellness Sussex Sussex 684514 2017 03 01 JB Nettoyage Sainte-Anne-de-Madawaska 686201 2017 02 24

O.C.B Business Consulting Quispamsis 686664 2017 02 24 Sybel Gaufres Memramcook 687306 2017 03 01 ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en Business Names Registration Act, a certificate of change of agent for nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de chan- service has been registered: gement d’un représentant pour fin de signification a été déposé :

Reference Number Date Agent and Address / Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Représentant et adresse référence année mois jour

MATHEWS CONVEYER McInnes Cooper CSD Services Inc. 642829 2017 03 02 Fredericton ALVEY McInnes Cooper CSD Services Inc. 642591 2017 03 02 Fredericton ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en Business Names Registration Act, a certificate of partnership has nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de so- been registered: ciété en nom collectif a été enregistré : Address of Business Reference or Agent Number Date Adresse du commerce Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Partners / Membres ou du représentant référence année mois jour

Life on A Stick Valuables Brenda Cameron Fredericton 694607 2017 03 03 Sklyor Bemrose Winding Trails Trading Vanessa Burghardt Queensbury 694648 2017 03 03 Amanda Fanjoy Burghardt ______The Royal Gazette — March 22, 2017 322 Gazette royale — 22 mars 2017

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en Business Names Registration Act, a certificate of renewal of part- nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re- nership has been registered: nouvellement de société en nom collectif a été enregistré : Address of Business or Agent Reference Adresse du Number Date commerce ou Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Partners / Membres du représentant référence année mois jour

Rowan McGrath Lawyers Donald Rowan Law Professional Fredericton 661686 2017 02 24 Corporation Elizabeth Mary McGrath ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en Business Names Registration Act, a certificate of dissolution of part- nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de disso- nership has been registered: lution de société en nom collectif a été enregistré : Reference Number Date Address / Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Adresse référence année mois jour

DIAMOND OPPORTUNITIES Sussex 327120 2017 03 02

Limited Partnership Act Loi sur les sociétés en commandite

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une ship Act, a declaration of limited partnership has been filed by: déclaration de société en commandite a été déposée par :

Principal place in Reference New Brunswick Number Date General Partners Principal établissement au Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Commandités Nouveau-Brunswick référence année mois jour

Village View No. 3 Limited Partnership Brittain Seale Holding Inc. Saint John 694529 2017 03 01 ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une ship Act, a declaration of extra-provincial limited partnership has déclaration de société en commandite extraprovinciale a été dépo- been filed: sée par : Principal place in Reference New Brunswick Agent and Address Number Date Principal établissement au Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Nouveau-Brunswick Compétence et adresse référence année mois jour

MG STRATUM FUND III, LIMITED Saint John Ontario Stewart McKelvey 624871 2017 02 27 PARTNERSHIP Corporate Services (NB) Inc. Saint John ______The Royal Gazette — March 22, 2017 323 Gazette royale — 22 mars 2017

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une ship Act, a declaration of withdrawal of extra-provincial limited déclaration de retrait de société en commandite extraprovinciale a partnership has been filed: été déposée par : Reference Agent and Address Number Date Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Compétence et adresse référence année mois jour

Brompton 2015 Flow-Through Limited Ontario Stewart McKelvey Corporate 680229 2017 02 28 Partnership Services (NB) Inc. Saint John ______

Financial and Consumer Commission des services Services Commission financiers et des services aux consommateurs

NOTICE OF RULE AVIS DE RÈGLE The making of amendments to: L’établissement des modifications à :

• National Instrument 81-102 Investment Funds • la Norme canadienne 81-102 sur les fonds d’investissement; • National Instrument 81-101 Mutual Fund Prospectus Dis- • la Norme canadienne 81-101 sur le régime de prospectus des closure organismes de placement collectif; et • Companion Policy 81-101 Mutual Fund Prospectus Disclo- • l’Instruction complémentaire relative à la Norme canadienne sure 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de pla- cement collectif.

(Together, the Amendments). (ensemble, les modifications).

Ministerial Consent Consentement ministériel On 30 January 2017, the Minister of Finance consented to the Le 30 janvier 2017, la ministre des finances a donné son consen- making of the above-noted amendments. tement à l’établissement des modifications énoncées ci-dessus.

Summary of Amendments Résumé des modifications The amendments standardize risk classification methodology in Les modifications introduisent une méthode obligatoire norma- the “Fund Facts” investor disclosure document, and provide for lisée de classification du risque dans l’aperçu du fonds destiné greater transparency and consistency to allow investors to more aux investisseurs, améliorant la transparence et l’uniformité ac- readily compare the investment risk levels of different mutual tuellement constatée, et permettant aux investisseurs de compa- funds. rer plus facilement les niveaux de risque de placement des dif- férents OPC.

Effective Date Date d’entrée en vigueur The amendments came into force in New Brunswick on 8 Les modifications sont entrées en vigueur au Nouveau- March 2017. Brunswick le 8 mars 2017.

How to Obtain a Copy Comment obtenir un exemplaire The text of the above-noted amendments can be obtained from On trouvera le texte des modifications énoncées ci-dessus par the Commission’s website: http://www.fcnb.ca l’entremise du site web de la Commission : http://www.fcnb.ca The Royal Gazette — March 22, 2017 324 Gazette royale — 22 mars 2017

Paper copies may be obtained from the Commission by writing, On peut se procurer un exemplaire sur papier du document en telephoning or e-mailing: communiquant par courrier, par téléphone ou par courriel avec la Commission, dont voici les coordonnées :

Secretary Secrétaire Financial and Consumer Services Commission Commission des services financiers et des services aux 85 Charlotte Street, Suite 300 consommateurs Saint John, N.B. E2L 2J2 85, rue Charlotte, bureau 300 Telephone: 506-658-3060 Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2 Toll Free: 866-933-2222 (within NB only) Téléphone : 506-658-3060 Fax: 506-658-3059 Sans frais : 1-866-933-2222 (au N.-B. seulement) E-mail: [email protected] Télécopieur : 506-658-3059 Courriel : [email protected]

______

NOTICE OF RULE AVIS DE RÈGLE The making of amendments to: L’établissement des modifications à :

• National Instrument 41-101 General Prospectus Require- • la Norme canadienne 41-101 sur les obligations générales ments; relatives au prospectus; • National Instrument 81-106 Investment Fund Continuous • la Norme Canadienne 81-106 sur l’information continue des Disclosure; fonds d’investissement; • Companion Policy 41-101 General Prospectus Require- • l’Instruction complémentaire relative à la Norme canadienne ments; and 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus; et • Companion Policy 81-106 Investment Fund Continuous Dis- • l’Instruction complémentaire relative à la Norme canadienne closure. 81-106 sur l’information continue des fonds d’investisse- ment.

(Together, the Amendments). (ensemble, les modifications).

Ministerial Consent Consentement ministériel On 30 January 2017, the Minister of Finance consented to the Le 30 janvier 2017, la ministre des finances a donné son consen- making of the above-noted amendments. tement à l’établissement des modifications énoncées ci-dessus.

Summary of Amendments Résumé des modifications The Amendments mandate a summary disclosure document for Les modifications introduisent un document d’information exchange-traded mutual funds (ETFs). They require ETFs to sommaire obligatoire pour les fonds négociés en bourse (les produce and file a summary disclosure document, which must « FNB »). Elles exigent des FNB qu’ils établissent et déposent be made available on the ETF’s or the ETF manager’s website, un document d’information sommaire appelé « aperçu du FNB » and must also be delivered to investors within two days of the et l’affichent sur leur site Web ou sur celui de leur gestionnaire, purchase. Delivery of the prospectus will not be required, but et le transmettent aux investisseurs dans les deux jours suivant there will be a requirement for the prospectus to be made avail- la souscription ou l’acquisition. La transmission du prospectus able to investors upon request, at no cost. ne sera pas exigée, mais une obligation de mettre le prospectus à la disposition de l’investisseur sur demande et sans frais sera introduite.

Effective Date Date d’entrée en vigueur The amendments came into force in New Brunswick on 8 Les modifications sont entrées en vigueur au Nouveau- March 2017. Brunswick le 8 mars 2017.

How to Obtain a Copy Comment obtenir un exemplaire The text of the above-noted amendments can be obtained from On trouvera le texte des modifications énoncées ci-dessus par the Commission’s website: http://www.fcnb.ca l’entremise du site web de la Commission : http://www.fcnb.ca The Royal Gazette — March 22, 2017 325 Gazette royale — 22 mars 2017

Paper copies may be obtained from the Commission by writing, On peut se procurer un exemplaire sur papier du document en telephoning or e-mailing: communiquant par courrier, par téléphone ou par courriel avec la Commission, dont voici les coordonnées :

Secretary Secrétaire Financial and Consumer Services Commission Commission des services financiers et des services aux 85 Charlotte Street, Suite 300 consommateurs Saint John, N.B. E2L 2J2 85, rue Charlotte, bureau 300 Telephone: 506-658-3060 Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2 Toll Free: 866-933-2222 (within NB only) Téléphone : 506-658-3060 Fax: 506-658-3059 Sans frais : 1-866-933-2222 (au N.-B. seulement) E-mail: [email protected] Télécopieur : 506-658-3059 Courriel : [email protected]

Sheriff’s Sales Ventes par exécution forcée

Sale of Lands Publication Act, Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces R.S.N.B. 1973, c.S-2,s.1(2) L.R.N.-B. 1973, ch. S-2, par. 1(2)

FEDERAL COURT COUR FÉDÉRAL

BETWEEN: ENTRE : HER MAJESTY THE QUEEN, AS REPRESENTED SA MAJESTÉ LA REINE, REPRÉSENTÉE PAR LA BY THE MINISTER OF NATIONAL REVENUE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Creditor Créancière and et DONNA MARIE NOBLE DONNA MARIE NOBLE Debtor Débitrice

SALE UNDER THE VENTE EFFECTUÉE EN VERTU DE LA LOI SUR LES MEMORIALS AND EXECUTIONS ACT EXTRAITS DE JUGEMENT ET LES EXÉCUTIONS

All right, title and interest of DONNA MARIE NOBLE in the Tous les droits, titres et intérêts de DONNA MARIE NOBLE following freehold properties: dans et sur les biens en tenure libre suivants : 1) Vacant Land, Route 655, Waasis, NB 1) Lot de terrain, rte 655, Waasis (N.-B.) PID 60031408 NID 60031408 2) Development Lot 2005-1 Rose of Sharon Court, Waasis, NB 2) Lot de terrain Lot 2005-1, cour Rose of Sharon, Wassis PID 60157716 (N.-B.) NID 60157716 3) Woodland, Panther Pass, Waasis, NB 3) Terrain boisé, Panther Pass, Wassis (N.-B.) PID 60142254 NID 60142254 4) Vacant Lot 09-4 Route 655, Waasis, NB 4) Lot de terrain, 09-4 rte 655, Wassis (N.-B.) PID 60170560 NID 60170560 5) Residential Lot 09-5, Route 655, Waasis, NB 5) Lot de terrain, 09-5, rte 655, Wassis (N.-B.) PID 60170578 NID 60170578 all located in the County of Sunbury, and in the Province of New tous situés dans le comté de Sunbury, dans la province du Brunswick. Nouveau-Brunswick. The sale is being conducted to enforce two Writs of Seizure and La vente est effectuée aux fins de deux ordonnances de saisie et Sale against DONNA MARIE NOBLE. vente contre DONNA MARIE NOBLE.

SALE will take place on Wednesday, May 10th, 2017 at 2:00 LA VENTE aura lieu le mercredi 10 mai 2017 à 14 h. p.m. The Royal Gazette — March 22, 2017 326 Gazette royale — 22 mars 2017

SEE advertisements in The Daily Gleaner on March 4 and 21, VOIR les annonces publiées dans les éditions suivantes du 2017, April 10, 2017 and May 2, 2017 and l’Acadie Nouvelle on Daily Gleaner les 4 et 21 mars, 2017, le 10 avril 2017 et le 2 mai April 10, 2017. 2017 et dans l’Acadie Nouvelle le 10 avril 2017.

Dated at Fredericton, New Brunswick, this 2nd day of March, Fait à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, le 2 mars 2017. 2017.

Sheriff George Oram Shérif George Oram Regional Sheriff for Southern Region Shérif régional pour district du sud

Notices of Sale Avis de vente

Sale of Lands Publication Act Loi sur la vente de biens-fonds par voie d'annonces R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2) L.R.N.-B. 1973, ch. S-2, par. 1(2) To: Lyn Marie Chase, Lyn Marie Ross and James William Ross, Destinataires : Lyn Marie Chase, Lyn Marie Ross et original Mortgagors, and to: all others whom it may concern. James William Ross, débiteurs hypothécaires originaires; et Sale pursuant to terms of the Mortgage and the Property Act tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée en vertu des dis- R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amendment thereof. Free- positions de l'acte d'hypothèque et de celles de la Loi sur les hold property being situated at 37 Elm Street, St. Stephen, New biens, L.R.N.-B 1973, ch. P-19. Biens en tenure libre situés au Brunswick, the same lot conveyed to Lyn Marie Chase and 37, rue Elm, à St. Stephen, au Nouveau-Brunswick, et corres- James William Ross by Transfer registered in the Lands Titles pondant au même lot ayant été transféré à Lyn Marie Chase et System on August 22, 2002, as Number 14838651. James William Ross par l’acte de transfert enregistré dans le système d’enregistrement foncier le 22 août 2002, sous le nu- méro 14838651. Notice of Sale given by Scotia Mortgage Corporation as Mort- Avis de vente donné par la Société hypothécaire Scotia, créan- gagee. Sale to be held at St. Stephen Town Hall situate at 73 cière hypothécaire. La vente aura lieu le 12 avril 2017, à 11 h, Milltown Boulevard, Suite 112, St. Stephen, New Brunswick, heure locale, à l’hôtel de ville de St. Stephen, 73, boule- on the 12th day of April 2017, at the hour of 11:00 a.m., local vard Milltown, bureau 112, St. Stephen (Nouveau-Brunswick). time. See advertisement of Notice of Sale in the Telegraph- Voir l'annonce publiée dans les éditions des 13, 20 et 27 mars et Journal dated March 13, 20, 27 and April 3, 2017. du 3 avril 2017 du Telegraph-Journal.

McInnes Cooper, Solicitors for Scotia Mortgage Corporation, Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Société Per: Adel Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite hypothécaire Scotia, Centre de la Croix Bleue, 644, rue Main, bu- S400, P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6. reau S400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6; Telephone: 506-857-8970 Facsimile: 506-857-4095. téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095

Notice to Advertisers Avis aux annonceurs

The Royal Gazette is published every Wednesday under the La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformé- authority of the Queen’s Printer Act. Documents must be re- ment à la Loi sur l’Imprimeur de la Reine. Les documents à ceived by the Royal Gazette coordinator, Legislative Services, publier doivent parvenir au coordonnateur de la Gazette no later than noon, at least seven days prior to Wednesday’s royale, aux Services législatifs, à midi, au moins sept jours publication. Each document must be separate from the cover- avant le mercredi de publication. Chaque avis doit être séparé ing letter. Signatures on documents must be immediately fol- de la lettre d’envoi. Les noms des signataires doivent suivre lowed by the printed name. The Royal Gazette coordinator immédiatement la signature. Le coordonnateur de la Gazette may refuse to publish a document if any part of it is illegible, royale peut refuser de publier un avis dont une partie est illi- and may delay publication of any document for administrative sible et retarder la publication d’un avis pour des raisons ad- reasons. ministratives. The Royal Gazette — March 22, 2017 327 Gazette royale — 22 mars 2017

Prepayment is required for the publication of all documents. Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis. Standard documents have the following set fees: Voici les tarifs pour les avis courants :

Cost per Coût par Notices Insertion Avis parution

Notice of the intention to apply for the enactment of a $20 Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loi 20 $ private bill d’intérêt privé Originating process $ 25 Acte introductif d’instance 25 $ Order of a court $ 25 Ordonnance rendue par une cour 25 $ Notice under the Absconding Debtors Act $20 Avis exigé par la Loi sur les débiteurs en fuite 20 $ Notice under the General Rules under the Law Society Act, $20 Avis de radiation ou de suspension ou de demande de 20 $ 1996, of disbarment or suspension or of application for réintégration ou de réadmission, exigé par les Règles reinstatement or readmission générales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur le Barreau Notice of examination under the Licensed Practical Nurses $25 Avis d’examen exigé par la Loi sur les infirmières et 25 $ Act infirmiers auxiliaires autorisés Notice under the Motor Carrier Act $30 Avis exigé par la Loi sur les transports routiers 30 $ Any document under the Political Process Financing Act $20 Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur le 20 $ financement de l’activité politique Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9 $20 Avis aux créanciers exigé par le Règlement du Nouveau- 20 $ under the Probate Court Act Brunswick 84-9 établi en vertu de la Loi sur la Cour des successions Notice under Rule 70 of the Rules of Court $120 Avis exigé par la Règle 70 des Règles de procédure 120 $ Note: Survey Maps cannot exceed 8.5″ x 14″ Nota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 po sur 14 po Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is $20 Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voie 20 $ 1/2 page in length or less d’annonces, si l’avis est d’une demi-page ou moins en longueur Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is $75 Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voie 75 $ greater than 1/2 page in length d’annonces, si l’avis est de plus d’une demi-page en longueur Any document under the Winding-up and Restructuring Act $20 Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur les 20 $ (Canada) liquidations et les restructurations (Canada) Notice of a correction charge is Avis d’une correction les frais sont the same as les mêmes que for publishing ceux imposés the original pour la document publication du document original Any other document $3.50 for each Tout autre document 3,50 $ pour cm or less chaque cm ou moins

Payments can be made by cash, MasterCard, VISA, cheque or Les paiements peuvent être faits en espèces, par carte de money order (payable to the Minister of Finance). No refunds crédit MasterCard ou VISA, ou par chèque ou mandat (à will be issued for cancellations. l’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation.

The official version of The Royal Gazette is available free La version officielle de la Gazette royale est disponible gra- on-line each Wednesday. This free on-line service replaces the tuitement en ligne chaque mercredi. Ce service gratuit en printed annual subscription service. The Royal Gazette can be ligne remplace le service d’abonnement annuel. Vous trouve- accessed on-line at: rez la Gazette royale à l’adresse suivante :

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/ attorney_general/royal_gazette.html procureur_general/gazette_royale.html

Print-on-demand copies of The Royal Gazette are available, at Nous offrons sur demande des exemplaires de la Gazette the following address, at $4.00 per copy plus 5% tax, plus royale à l’adresse suivante pour la somme de 4 $ l’exemplaire, shipping and handling where applicable. plus la taxe de 5 % ainsi que les frais applicables de port et de manutention.

Notice: The telephone number for The Royal Gazette has Avis : Le numéro de téléphone de la Gazette royale a changé. changed. Please see below. Prière de voir ci-dessous. The Royal Gazette — March 22, 2017 328 Gazette royale — 22 mars 2017

Legislative Publishing Publications législatives Office of the Attorney General Cabinet du procureur général Chancery Place Place-Chancery 675 King Street 675, rue King P.O. Box 6000 C.P. 6000 Fredericton, NB E3B 5H1 Fredericton (N.-B.) E3B 5H1

Tel: 506-453-2520 Tél. : 506-453-2520 E-mail: [email protected] Courriel : [email protected]

Note: Deliveries are to be addressed to The Royal Gazette and Note : Toute livraison étant adressée à la Gazette royale doit left with the commissionaire. être remise au commissionnaire.

QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved / Tous droits réservés