The Royal Gazette Gazette royale

Fredericton Fredericton Nouveau-Brunswick

ISSN 1714-9428

Vol. 173 Wednesday, October 21, 2015 / Le mercredi 21 octobre 2015 1249 Notice to Readers Avis aux lecteurs

The Royal Gazette is officially published on-line. La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne. Except for formatting, documents are published in The Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans Royal Gazette as submitted. la Gazette royale tels que soumis. Material submitted for publication must be received by Les documents à publier doivent parvenir à la coordonna- the Royal Gazette Coordinator no later than noon, at least trice de la Gazette royale, à midi, au moins 7 jours ou- 7 working days prior to Wednesday’s publication. vrables avant le mercredi de publication. En cas de jour However, when there is a public holiday, please contact férié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de la the Royal Gazette Coordinator. Gazette royale.

Proclamations Proclamations

PROCLAMATION PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-217, I declare that the Ser- Conformément au décret en conseil 2015-217, je déclare le vice New Brunswick Act, Chapter 44 of the Acts of New Bruns- 1er octobre 2015 date d’entrée en vigueur de la Loi sur Services wick, 2015, with the exception of subsection 19(5), comes into Nouveau-Brunswick, chapitre 44 des Lois du Nouveau- force on October 1, 2015. Brunswick de 2015, à l’exception du paragraphe 19(5).

This Proclamation is given under La présente proclamation est faite my hand and the Great Seal of the sous mon seing et sous le grand Province at Fredericton on Septem- sceau de la province, à Fredericton, ber 23, 2015. le 23 septembre 2015.

Serge Rousselle, Q.C. Jocelyne Roy-Vienneau Le procureur général, La lieutenante-gouverneure, Attorney General Lieutenant-Governor Serge Rousselle, c.r. Jocelyne Roy-Vienneau

______The Royal Gazette — October 21, 2015 1250 Gazette royale — 21 octobre 2015

PROCLAMATION PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-220, I declare that An Act to Conformément au décret en conseil 2015-220, je déclare le Amend the Maritime Provinces Harness Racing Commission 9 octobre 2015 date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Act, Chapter 13 of the Acts of New Brunswick, 2015, comes Loi sur la Commission des courses attelées des provinces Mari- into force on October 9, 2015. times, chapitre 13 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2015.

This Proclamation is given under La présente proclamation est faite my hand and the Great Seal of the sous mon seing et sous le grand Province at Fredericton on Septem- sceau de la province, à Fredericton, ber 23, 2015. le 23 septembre 2015.

Serge Rousselle, Q.C. Jocelyne Roy-Vienneau Le procureur général, La lieutenante-gouverneure, Attorney General Lieutenant-Governor Serge Rousselle, c.r. Jocelyne Roy-Vienneau

Legislative Assembly Assemblée législative

NOTICE OF LEGISLATION AVIS DE PRÉSENTATION D’UN PROJET DE LOI Notice is hereby given that the FILLES DE JÉSUS MONC- Sachez que les FILLES DE JÉSUS MONCTON va déposer TON will introduce a Private Bill in the Legislative Assembly un projet de loi privé à la Chambre Législative de la province du of the Province of New Brunswick humbly requesting that its Nouveau-Brunswick pour demander que ses aspirations soient objectives be changed to provide for the needs of the retired, changés à pourvoir aux besoins des membres retraités, ma- sick or infirm members of the Filles de Jésus Moncton. lades ou invalides, des Filles de Jésus Moncton. DATED this 25th day of September, 2015. FAIT le 25 septembre, 2015.

Filles de Jésus Moncton, 553 Elmwood Drive, Moncton, New Filles de Jésus Moncton, 553, promenade Elmwood, Moncton, Brunswick, E1A 2X4. Nouveau-Brunswick, E1A 2X4.

Business Corporations Act Loi sur les corporations commerciales

Notice of decision Avis d’une décision to cancel the registration of extra-provincial corporations d’annuler l’enregistrement des corporations extraprovinciales Take notice that the Director under the Business Corporations Act has Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations made a decision to cancel the registration of the following extra- commerciales, a pris la décision d’annuler l’enregistrement des corpo- provincial corporations pursuant to paragraph 201(1)(a) of the Act, as rations extraprovinciales suivantes en vertu de l’alinéa 201(1)a) de la the said corporations have been in default in sending to the Director Loi, puisque lesdites corporations ont fait défaut de faire parvenir au fees, notices, and/or documents required by the Act. Please note that Directeur les droits, avis et/ou documents requis par la Loi. Soyez avisé 60 days after the publication of this Notice in The Royal Gazette, the que 60 jours après la date de la publication du présent avis dans la Director may cancel the registration. Gazette royale, le Directeur pourra annuler l’enregistrement desdites corporations extraprovinciales.

666871 152724 Inc. 641275 GCO Canada, Inc. 673351 SALFORD FARM MACHINERY LTD. 641536 7026609 CANADA INC. 077968 GLIDEPATH CANADA LTD. 647816 Skylink Express Inc. 660810 7252331 Canada Inc. 654044 International Cash Card Corporation 073978 TIMBER SYSTEMS LIMITED 660611 7922825 Canada Inc. 654163 JMW CONSULTANTS CANADA LTD. 647677 TRAVELPORT CANADA 667158 ATTAIN FINANCE CANADA, INC. 647727 Ken Bennett Enterprises Inc. DISTRIBUTION SYSTEMS INC. 628432 BBM Electronic Inc. 641363 Kulli Poder Medical Services Inc. /SYSTÈMES DE DISTRIBUTION 641404 CAPITAL CONTRACTORS CANADA, 609551 MURGOR RESOURCES INC. / TRAVELPORT CANADA INC. INC. RESSOURCES MURGOR INC. 604136 Trupanion Brokers Ontario, Inc. 673507 Corporation Genacol Canada Inc 659185 NETLOGIC COMMUNICATIONS INC. 604004 VEOLIA ES MATIÈRES Genacol Canada Corporation Inc. 635245 NEW LINE SKATEPARKS INC. RÉSIDUELLES INC. 071344 DALIN INVESTMENTS LIMITED 641339 Nike Canada Corp. 654399 ViewPoint Realty Services Inc. 654114 Deutsche Asset Management Canada 635014 P.H. VITRES D’AUTOS INC. 018579 VOLKSWAGEN GROUP CANADA Limited 647678 RUSSELL L. TOWLE ENTERPRISES INC. 666910 E D INDUSTRIAL LTD. LTD. The Royal Gazette — October 21, 2015 1251 Gazette royale — 21 octobre 2015

Companies Act Loi sur les compagnies

Notice of decision to dissolve provincial companies Avis d’une décision de dissoudre les compagnies provinciales Take notice that the Director under the Companies Act has made a de- Soyez avisé que le Directeur, en application de la Loi sur les compa- cision to dissolve the following companies pursuant to paragraph gnies, a pris la décision de dissoudre les compagnies suivantes en vertu 35(1)(c) of the Act, as the said companies have been in default in send- de l’alinéa 35(1)c) de la Loi, puisque lesdites compagnies ont fait dé- ing to the Director fees, notices, and/or documents required by the Act. faut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou documents re- Please note that 60 days after the date of publication of this Notice in quis par la Loi. Soyez avisé que 60 jours après la date de la publication The Royal Gazette, the Director may dissolve the companies. du présent avis dans la Gazette royale, le Directeur pourra dissoudre lesdites compagnies. 001489 BATH LIONS CLUB INC 641483 Friends of Mount Carleton Provincial 635242 New Brunswick Chinese United 002436 BRUNSWICK CURLING CLUB INC. Park Inc. (N.B.C.U.) Inc. 003091 CARLETON MANOR INC. 647685 Iranian Canadian Association of New 012123 NEW BRUNSWICK SPECIAL 024297 CENTRE FOR NUCLEAR ENERGY Brunswick (ICANB) Inc. OLYMPICS SOCIETY INC LA RESEARCH INC. 023286 L’ASSOCIATION DES FAMILLES SOCIETE DES OLYMPIADES 022007 CLUB D’AGE D’OR DE BERTRAND, GIONET D’AMERIQUE INC. SPECIALES DU NOUVEAU INC. 009672 LAWNDALE HOLDINGS INC. BRUNSWICK INC. 023599 CLUB MOTO NEIGE BOUCTOUCHE 003831 LE CLUB DE L’AGE D’OR DE 622337 New Brunswick Sports Hall of Fame Inc. /SAINTE-MARIE INC. - POKEMOUCHE INC. /Temple de la renommée sportive du BOUCTOUCHE/SAINTE-MARIE 665044 Les Hookeuses du Bor’de’lo Inc. Nouveau-Brunswick Inc. SNOWMOBILE CLUB INC. 020913 LES RESIDENCES SENATEUR 024261 NEWCASTLE COLUMBUS CLUB 023312 COMITE DE GESTION DES PORTS DE EDGAR E. FOURNIER INC. INC. BAS-CARAQUET INC. 660689 LYMAN DAWN STREET 609575 RIVER VALLEY JUNIOR "A" 025668 COMITÉ PORTUAIRE DU QUAI DE ASSOCIATION LIMITED HOCKEY CLUB INC. BELLIVEAU-VILLAGE INC. 025383 Meduxnekeag River Association Inc. 622362 RURAL HEALTH RESEARCH 660723 CONCERNED CITIZENS 654319 MI’KMAQ-MALISEET ASSOCIATION NETWORK INC. REGARDING RURAL PLANNING OF SOCIAL SERVICE 014651 SAINT JOHN ROTARY BOYS CHOIR INC. PROFESSIONALS INC. INC. 622202 Cottage Road Association Inc. 660401 Musik Central Inc. 641255 Soccer du Grand Caraquet Ltée. 614739 E.W.G. Food Services Ltd. 628764 Musquash Light Station Inc. 016055 TEMPERANCE VALE COMMUNITY 022001 FONDATION DES AMIS DU 021739 NEW BRUNSWICK CAMPING HALL INC. TROISIEME AGE INC. ASSOCIATION INC. - ASSOCIATION 023049 WOODSTOCK TRAIL MAKERS - 654179 FRESH START SERVICES FOR DES AMIS DES CAMPS DU SNOWMOBILE ASSOCIATION INC. WOMEN INC. NOUVEAU-BRUNSWICK INC. 025386 YC & W WHARF PRESERVATION ASSOC. INC. ______

Notice of decision to dissolve provincial companies Avis d’une décision de dissoudre les compagnies provinciales Take notice that the Director under the Companies Act has made a de- Soyez avisé que le Directeur, en application de la Loi sur les compa- cision to dissolve the following companies pursuant to paragraph gnies, a pris la décision de dissoudre les compagnies suivantes en vertu 35(1)(c) of the Act, as the said companies have been in default in send- de l’alinéa 35(1)c) de la Loi, puisque lesdites compagnies ont fait dé- ing to the Director fees, notices, and/or documents required by the Act. faut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou documents re- Please note that 60 days after the date of publication of this Notice in quis par la Loi. Soyez avisé que 60 jours après la date de la publication The Royal Gazette, the Director may dissolve the companies. du présent avis dans la Gazette royale, le Directeur pourra dissoudre lesdites compagnies. 506025 047438 N.B. INC. 628709 628709 N.B. Ltd. 654444 654444 N.B. INC. 058626 058626 N.B. INC. 634881 634881 NB LTD. 654494 654494 N.-B. INC. 654494 NB INC. 058769 058769 N.B. INC. 634889 634889 NB Inc. 660384 660384 NB Inc. 634911 439-447 RUE DU MOULIN INC. 634939 634939 N.B. Inc. 660412 660412 N.B. Inc. 501222 501222 NB LTD. 634982 634982 NB Inc. 660413 660413 N.B. Ltd. 510655 510655 N.B. Ltd. 635065 635065 N.B. Inc. 660439 660439 N.B. Inc. 515524 515524 N.-B. Ltée 635247 635247 NB Ltd. 660529 660529 N.B. INC. 515571 515571 NB LTD. 641277 641277 N.B. INC. 660546 660546 N.-B. INC. 604081 604081 NB Ltd. 641389 641389 NB LTD. 660584 660584 New Brunswick Inc. 609261 609261 N.B. Inc. 641458 641458 N.B. Inc. 660629 660629 NB Inc. 609351 609351 NB Inc. 641478 641478 N.B. INC. 660653 660653 N.B. Ltd. 609508 609508 NB Inc. 641602 641602 N.B. Ltd. 660769 660769 N.-B. INC. 615672 615672 NB INC. 647591 647591 NB Ltd. 660790 660790 NB LTD. 622085 622085 N.B. LTD. 647617 647617 NB Inc. 666788 666788 N.B. Inc. 622097 622097 NB LTD. 647703 647703 N.B. Inc. 666887 666887 N.B. Inc. 622100 622100 N.B. LTD. 647794 647794 N.B. LTD. 666905 666905 NB Inc. 622342 622342 NB Inc. 647839 647839 NB INC. 667000 667000 NB Inc. 622424 622424 N.B. Ltd. 647971 647971 N.B. Ltd. 673289 673289 NB INC. 622432 622432 NB LTD. 647978 647978 N.B. Inc. 673290 673290 NB Ltd. 628727 625842 NB Ltd. 654257 654257 N.-B. Ltée 673298 673298 N.B. Inc. 628608 628608 New Brunswick Inc. 654283 654283 N.B. Ltd. 673333 673333 N.B. LTD. 628681 628681 N.-B. LTÉE 654370 654370 NB Ltd. 673343 673343 N.B. Ltd. 628698 628698 New Brunswick Ltd. 654402 654402 N.B. INC. 673515 673515 NB INC. The Royal Gazette — October 21, 2015 1252 Gazette royale — 21 octobre 2015

673523 673523 NB INC. 673575 D.A.E. Enterprises Inc. 045442 INVESTMENT REALTY SERVICES 673556 673556 NB Inc. 043276 D.S.G.C. HOLDINGS INC. LTD. 673586 673586 N.B. Inc. 503452 DAIBES HOLDINGS LTD. 503507 ISLAND VIEW CAMPING LTD. 673625 673625 NB Ltd. 673473 Dalumi Canada Inc. 622260 J & J Gold Creations Ltd. 673628 673628 N.B. LTD. 043183 DAWNALEN SYSTEMS INC. 043199 J.P. GALLANT CAMIONS, 673643 673643 N.B. Inc. 660750 DeAngelis Investments Inc. BULLDOZERS LTEE/TRUCKING, 628841 A 2 Z Learning & Care Centre Ltd 666813 DEB’S FLOWERS LTD. BULLDOZING LTD. 628527 A PLUS SEALERS INC. 628544 Decidiam Ltd. 673472 JADE KINGDOM RESTAURANT INC. 503506 A-PLUS PLUMBING & HEATING LTD. 641333 Deloras O’Neill Mediation Services Inc. 673503 Jeff Cooke Renovations Ltd. 660574 Absolute Property Management Inc. 634756 DEVEAUX PHARM INC. 647893 JimCor Developments Inc. 622013 ACM Logging Ltd. 505839 DEVTEK LTD. 628485 JLS Enterprises Inc. 635169 Acrylicon Canada Distribution Ltd. 660730 Dieppe Sports Inc. 666973 Joe’s Exteriors Ltd. 603651 AEG Innovative Solutions Inc. 666846 DIONNE DEVELOPMENTS CORP. 646742 Jonah Family Renovations Inc. 503471 AGENCE C.J. PELLETIER AGENCY 673277 DM Pottier inc. 673387 K & G Industrial Contracting Inc. LTD. 505882 DOCTEUR TO QUYEN TA 673309 KEILTY’S ISLAND SUGARY LTD. 654497 AGN Properties Inc. CORPORATION 666748 Kevin Schyf Inc. 667139 Allport Consulting Inc. PROFESSIONNELLE INC. 673486 KHS CONSULTING LTD. 635102 Amala Trading and Marketing Limited 622275 Dr Bernard Godin C.P. Inc. 641095 KID’S KORNER DAYCARE LTD. 667013 Amazon Pools and Spas Inc. 052966 DR. MARK A. INMAN OPTOMETRIST 628546 KRINIC HOLDINGS INC. 660667 Ana Banana Baby Products Inc. PROFESSIONAL CORPORATION 641486 KUKA Robotics Canada Ltd. 647476 ANDRE M. LTEE 628614 Dr. Paul B. Kerr Professional Corporation 658002 Kyvan Trucking Ltd. 043236 Anne Smith Realty Inc. 654315 Dr. Zaki Professional Corporation 043043 L.E.S. LAVOIE INC. 615532 ANVIN INTERNATIONAL LTD. 660469 DRE PIERRETTE M. DAIGLE C.P. INC. 628570 Lenron Transportation Services Inc. 641282 Asia-Housing Canada Inc. 641203 Dre Renée Chiasson-Basque C.P. Inc. 020917 LES AMBULANCES DE LA 673344 ASL Quality Construction Inc. 673470 E.C.T. HOLDINGS LTD. PENINSULE LIMITEE 635228 Assurance Nathalie Bowser Insurance Inc. 660474 East Coast Pub and Grill Inc. 505904 LINKLETTER MANAGEMENT INC. 647596 AT YOUR SERVICE CONTRACT 660430 EASTERN PROPERTIES HOLDING 635076 Little Rays of Sunshine Inc. DELIVERY LTD. INC. 513235 London Industrial Quality Services Inc. 609632 Atlantic Gold Mining Ltd. 510652 ECOSYL PRODUCTS CANADA 635073 LOU’S PUB INC. 052931 AUBERGE DU PONT ROUGE LIMITED 673555 M A FRASER INC. LIMITEE 009718 EMILE C. LEBLANC & FILS LTEE.- 609269 Manning Financial Inc. 654358 AVOCET ENTERPRISES LTD. EMILE C. LEBLANC & SONS LTD. 660817 Manning Investments Inc. 055449 B.C.D. VENTILATION LTEE 641295 EnTech Construction Ltd. 647821 MARIO RICHARD ROOFING LTD. 673526 B.R. Thompson Construction Inc. 647675 Entreprise RRCR Ltée 055713 MARITIME ICE CO. LTD. 609282 Barnworks Corp. 666744 Ethos Development Group Ltd. 505978 MAURICE LEVESQUE & FILS INC. 654273 Beagle Motors Ltd. 673617 Everette Construction Ltd. 020920 MAYFLOWER APARTMENTS LTD. 673346 Beam Pavement Services Inc. 053004 FIRST CHOICE PLUMBING REPAIRS 032916 MCKINNON’S TRUCKING LTD. 666792 Bistro Pub Nid du Héron Inc. LTD. 673305 ME Therapy Incorporated 034618 BLAIRCAN SIGNS LTD. 634866 First Nations Management Services Inc. 660635 Meri Trade Advisory Services Limited 609460 Bluff Hill Farm Ltd. 609334 Five Reasons Fisheries Ltd. 673392 MESSAGEVAULT SOFTWARE INC. 515630 BMH INVESTMENTS LTD. 048427 FOOTMAN MEDICAL LIMITED 673485 Metalid Enterprises Ltd. 002318 BRIDGES ELECTRICAL LTD. 615522 FORTEX HOLDINGS LTD. 615434 Milford Trailer Park Inc. 505893 BRIDGEWAY DEVELOPMENTS 006473 FRAN-AN ENTERPRISES LTD. 053066 MIREX HOLDINGS LTD. CORPORATION 634846 Fredericton Foods Inc. 660490 MJC Group Inc. 647931 Broadside Property Limited 032829 FUNDY LOBSTERS LTD. 634787 Moncton Catering Inc. 048269 C & P UNLIMITED INC. 510728 FUNDY VISION OPTICAL 034601 MORRISON ELECTRICAL 654332 C. Allain Roofing Inc. LABORATORY INC. CONTRACTING & MAINTENANCE 015600 C. M. STEWART COMPANY LIMITED 673453 Game Lords Inc. LTD. 040508 C.I.M. INVESTMENT LTD./ 014365 GERALD A. ROY LTD. 654127 MVP AGRI-SOLUTIONS INC. INVESTISSEMENT C.I.M. LTEE 673541 Gilbert Silviculture Inc. 654087 NIRVANA WELLNESS CENTRE INC. 002779 CALEDONIA CONSULTANTS LTD. 615655 Global Intermediate Finance Trust 048558 Noel Holdings Inc. 654132 Cape Enrage Property Holdings Corp. Corporation 050641 NORM’S PIZZA INC. 654038 CAPMARK CANADA LIMITED/ 036321 GODIN CONCRETE & TILE LTD. - 622351 North Shore Water Conditioning Inc. CAPMARK CANADA LIMITÉE BETON & TUILE GODIN LTEE 505782 NORTHERN NEW BRUNSWICK EGG 647672 CAT Residential Construction 647567 GOLF RUSH INC. PRODUCERS INC. Incorporated 667072 Golin Transport Inc. /LES PRODUCTEURS D’OEUFS DU 628520 CCHI CANADIAN HOLDINGS, INC. 036284 GOOD EARTH CANADA LTD. NORD DU NOUVEAU-BRUNSWICK 628522 CCHI DRYUP GULCH, INC. 667140 Gord Phillips GeoServices Inc. INC. 628564 CELLGEST LIMITED 634836 Gretzky Construction and Consulting 647894 NOSYDAM RENTALS INC. 501178 CHAMCOOK CANOE CLUB INC. Services Ltd. 609469 O.A.B. Enterprises Inc. 013337 CHARLES PRICE, LIMITED 603801 Groupe CIESA et Média-CI inc. 628830 OCEAN FRONTIER INC. 673549 Chartwell Holdings Ltd. 654061 H & D DIAMOND POTATOES INC. 012512 OCEAN INVESTMENT CO. LTD. 043299 CLAYPOLE LTD. 654368 HARVEST ALLIANCE CORP. 654428 Ocean to Plate N.B. Ltd. 503459 CMAC REBUILD INC. 609621 Heabury Holdings Ltd. 641601 Old Fangled Steeple Ltd. 673494 Coggan Drywall Inc. 048743 HILL TOP VARIETY STORE INC. 654341 Ottaway Motor Express (2010) Inc. 505841 COMPTABILITE J.G. LOSIER LTEE 008053 HILLSBOROUGH FASHIONS LTD. 622484 Outdoor Elements Inc 647774 Concrete Unlimited Inc. 503466 HOBRE INC. 666941 Park Place Homes (NB) Ltd. 673658 Corey Benefit Solutions Inc. 622019 Hometown Communications Ltd. 510540 PEGASUS PROPERTIES INC. 043180 COUNTY TRACTORS & MACHINERY 515680 Hughes Development Inc. 673402 PELLETIER CARON HOLDINGS LTD. LTD. 673518 Hummingbird RV Rentals and Repair Ltd. 660807 Physio For You Atlantic Inc. 660446 Crain’s Bottle Depot Ltd. 045967 HUNTER ENTERPRISES LTD. 647885 PORT CITY BUILDERS LTD. 673557 CREATING WONDERS DAYCARE 635054 Hurricane Shooters Canada Inc. 628867 Preneal Canada Inc. INC. 513138 IBL - Internet Business Logic Inc. 515650 Rabaey Management Consultants Inc. 667073 Crescent Management Consulting Inc. 609669 IMI Norgren Ltd. 641286 Ranco Enterprises Inc. 667007 Crown Court Ltd. 053020 IMMEUBLES NADEAU INC. - 609422 Razor Communication Inc. 647539 Cruiser Holdings Inc. NADEAU REAL ESTATE INC. 515578 REALTY ONE PROPERTIES LTD. 673239 D&S Miramichi Fishing Lodge inc. 666729 Imprimerie Promographic Inc. 673427 Red Dynamite Productions Inc. 048690 D. & M. HOLDINGS LTD. 503513 INTERNATIONAL SPORTS NET INC. 635103 RINKOM WOOD LIMITED The Royal Gazette — October 21, 2015 1253 Gazette royale — 21 octobre 2015

666819 Ronar Corp. 052996 SILVER SCREEN INC. 004339 THE CORNCRIB, NATURAL FOODS 020843 ROSE FLOWER FARMS LTD. 503389 SKYRIDGE SYSTEMS INC. LTD. 058786 RRG CONTRACTING LTD. 615762 Snack Fish Buyers Ltd. 501284 THIRSTY MULE SALOON LTD. 634928 RSE Investments Ltd. 015428 SPARKLE DRY CLEANING LTD. 622263 Tight Lines Productions Ltd. 634927 RSE Transportation Inc. 667143 St. Andrews Ocean Adventures Inc. 016221 TOBIQUE ESTATES LTD. 513231 RUADH MCNEIL HOLDINGS INC. 667042 St. Croix River Holdings (2012) Ltd. 660619 Trekk.it Corporation 508056 RUBIS D’ACADIE CANNEBERGES 055699 STEP ONE RENOVATION LTD. 647773 Trinity Alliance Corporation INC. 603834 Stone Fox Enterprises Ltd. 034575 U-STORE IT LTD. 666746 S. Keating Holding Company Inc. 654472 STONECUTTER’S EDGE LTD. 667041 Upsalquitch River Holdings (2012) Ltd. 654505 S.M. FORESTERIE INC. 515518 STOTHART AUTOMOTIVE INC. 009584 VAL LANDRY & SON (ROOFING & 508086 SALAMANCA DEVELOPMENTS INC. 052919 SUE LAWRENCE HAIR & GALLERY SHEET METAL WORKING) LTD. 058733 SAM’S GRAPHICS AND INC. 020922 VALLEY RANCH ESTATES LTD. ADVERTISING INC. 046194 SUGARLOAF MOUNTAIN 673270 VAPIRES.CA LTD. 014765 SANDWAY MOTEL LTD. MANAGEMENT LTD. 654247 VC Auto Repair Inc. 604006 Sav’s Real Estate Inc. 635166 Sunset Bay Enterprises Inc. 020834 VENEER PRODUCTS OF N. B. (1981) 510671 SBARRO DOMINION LIMITED 615521 T & D Legacy Transport Ltd. LTD. 666944 Sentrant Security Inc. 647921 T & R SOD FARMS LIMITED 615513 Village Shopping Centre (NL) Inc. 647597 Sersa Group Canada Ltd. 660687 TAN’S KICKFIT KICKBOXING & 654492 WMD Timber Trust Ltd. 654180 Shelley Consulting and Equipment Ltd. FITNESS INC. 505905 ZANE GIBERSON HOLDINGS LTD. 503505 Shorecrest Lodge Inc. 660467 TBR BUILDING CODE EXPERTS INC. 660370 ZOITALITY INC.

Partnerships and Business Loi sur l’enregistrement des Names Registration Act sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

TAKE NOTICE that, pursuant to sections 12.3 and 12.31 of the Part- SACHEZ QUE, conformément aux articles 12.3 et 12.31 de la Loi sur nerships and Business Names Registration Act R.S.N.B., 1973, c. P-5, l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations com- the Registrar under the said Act intends to cancel the registration of the merciales, L.R.N.-B. de 1973, chap. P-5, le registraire a l’intention, en certificates of partnership of the firms set forth in Schedule “A” an- vertu de ladite loi, d’annuler l’enregistrement des certificats de sociétés nexed hereto and the certificates of business names of the businesses en nom collectif indiquées à l’annexe « A » ci-jointe et des certificats set forth in Schedule “B” annexed hereto by reason of the fact the said d’appellations commerciales des commerces indiqués à l’annexe « B » firms and businesses have failed to register certificates of renewal in ci-jointe, en raison du fait que ces firmes ou commerces ont négligé de accordance with paragraph 3(1)(b) or (c) or subsection 3.1(2) or 9(7), faire enregistrer des certificats de renouvellement conformément à as the case may be applicable, of the said Act. l’alinéa 3(1)b) ou c) ou au paragraphe 3.1(2) ou 9(7) de ladite loi, selon le cas.

FURTHER TAKE NOTICE that at any time after the expiration date of SACHEZ AUSSI qu’en tout temps après la date d’expiration de trente thirty (30) days from the date of publication of this Notice, the Regis- (30) jours à partir de la date de publication du présent avis, le registraire trar may cancel the registration of the said certificates of partnerships peut annuler l’enregistrement desdits certificats de sociétés en nom and certificates of business names. collectif et certificats d’appellations commerciales. Schedule “A” / Annexe « A » Certificates of Partnerships / Certificats de sociétés en nom collectif

653161 Christmas Liquidators 652556 Kurihipi Station 653223 Sunflower Blooms Flower Shop 350104 Daybreak Trio 653166 Rainy Day Gutter Systems 652914 THE KINGSWOOD BED & 653373 Hair-Tastix by Amanda 653097 Raye’s Mustard Canada BREAKFAST 653473 IAA Invest Atlantic Alliance 653147 S&H Child Care Services

Schedule “B” / Annexe « B » Certificates of Business names / Certificats d’appellations commerciales

Schedule “B” / Annexe “ B ” 653431 AVE Acoustics & Vibration Engineering 620813 CK FOOD EQUIPMENT SERVICE 653219 2B Learning 653081 B. F. Kanada-Tours 653432 Coiffure et Esthetique Plaza Beaute 653417 2NZ4U MUSIC 653112 Back in Balance Massage Therapy Clinic Claudette 653293 A&G Premier Home Renovations & 620814 BAD AMY MOTION PICTURES 653141 Costume Corner Repairs 653259 BKD Automotive 620638 country hair haven 653273 A-1 Pizza Aboud 652629 Boutique d’élégance 14 ans et plus 653122 COZY LODGE COMPLEX 653121 ADM Home Care 620652 BRIAN MORIN GOUTTIÈRES 653188 CPR Electric 653348 Albert Doiron Trucking D’ALUMINIUM 653203 CROSS SYSTEMS Management 653315 Ali Baba Cab 653260 Brightspark 653220 CROSSROADS NIGHT CLUB 653065 AMCR Construction 653249 C&D Media Publications 653419 Cyr Log Furniture 653139 AMI Architectural Millwork Installations 653179 Casa-Dia Vinyl Records 653355 D&H Flooring 653283 APPLIED CANADA 653101 Cedar Shack Poultry 653229 D. Sharpe Cycle & ATV Repair 620664 ATLANTIC COVE FISHERY 653060 CFW THIBODEAU ELECTRICAL 653353 Danzing Dance Shoes 617015 Atlantic Pet Grooming 653256 Charlie Herman Chappell Well Drilling 653125 DAVE’S NO FRILLS The Royal Gazette — October 21, 2015 1254 Gazette royale — 21 octobre 2015

652708 David White Enterprise 653319 LEADING NOTE MUSIC STUDIO 653265 RM Consultant 653301 DD Sports Photo 620102 LES FONDS UNIVERSITAS 653446 Robbie’s First Class Deliveries 653173 Defined By Gillian Personal Training 620101 LES FONDS UNIVERSITAS DU 653051 ROCK’N COUNTRY 621062 Delora Media CANADA 621410 RODD HOTELS & RESORTS 620783 DJ Mécanique 653119 Les Services AJSN 653456 Rooftree Design 620844 DPTechnologies 652584 LESAFF Technologies 653463 SAINT JOHN FIRST CLASS 653150 Dr.Amos Adeniyi Abundant Life 620857 LIBRAIRIE "LA GRANDE OURSE" CLEANERS Counselling Center 653163 Little Steps Child Care 620598 salon chez mona 653243 Embassy Homes 653271 LorDan Health Services 620585 SALON COIFFURE EVANA 621363 ETS Canada 653129 MAGNETIC HILL BED AND 653274 Say I Do Studio 652996 Festival Country Folk Trash de Petit- BREAKFAST 653444 Sea Glass Career Solutions Rocher 653458 Magnolia Silver Jewellery 620423 Son Group 653479 Final Cut Machining 653032 McAllister’s Creative Images 653199 SPARKLE ME BOUTIQUE 620634 Foyer L & L Laforge 653459 McElman’s Flooring 653240 SRG Entreprise 652934 Gary Hawkins AutoBody 653320 MCPHEE BUSINESS SERVICE 652749 Staged 2 Live Home Staging 653333 Grab a Snack Vending 653341 MIRAMICHI SMOKED PRODUCTS 653095 Stiletto Consulting 651212 Grove Auto Repair 653339 MIRAMICHI SMOKED SALMON 653167 Stop & Stare Nails & Aesthetics 350017 HEALING WELL 653076 Mobility Oil Service 620474 Stowaway Storage 653155 Heyona Wellness Center 653233 Mobster Ink 653224 STUDIO DI MODA 653356 Hollow Farms Auction House 653067 Molten Metal Mobile Welding & Repair 653258 Sue Ross Art 653306 Holly’s Canine Enterprises 653257 MONIQUE LEBLANC, physiothérapeute 350235 T. E. NOBLE TRANSPORTATION 653096 HOVEY & SONS VENTURES 653357 Morris Carpentry SERVICES 620504 I-Haul 653326 MTN CLEANING SERVICES 620596 TANPOPO BATH & BODY 652969 iClick Web Marketing 653064 Nails To Go 653106 The Bobber Shop 653128 IMAGE1 653415 NATURAL MOVES YOGA AND 653198 THE CHRISTMAS PALACE 653346 Images by Nevin Magee BELLYDANCE 620586 THE EASTERN PROSTHETIC CLINIC 652040 ISAAC’S ARK 653074 New Method Cleaners & CLINIQUE DES PROTHESES DE 653079 Jamara Developments 620509 NICHOLSON’S WASTE L’EST 653480 JCFL Consultation MANAGEMENT 653162 The Pit Stop Grill and Buffet Oromocto 653430 Jean-Guy Bard Trucking 653316 NICK ROBERTSON AUTO SALES 652823 TIERRA JEWELRY DESIGN 653266 Jean-Guy Chiasson Services Enr. 652630 Noëlla’s Family Hair Cuts 620818 TIPS-N-TOES ESTHETICS 653178 JM THE SHOP BUY SELL TRADE 653090 Oland Brewery 620954 TM Shears & Associates 653450 JML Systems Consulting 653206 On The Mark Property Management 653451 TnT Disc Jockey Services 653049 JOE’S DRYWALL 653454 P. Riebel Consulting 653296 Tobique Hair Passion 653088 John Labatt 653421 P.A. Wilson Enterprises 649802 TOITURE G.R. DUGUAY ROOFING 620917 Juliette’s Pottery - Studio & Store 653331 Pennfield Daycare 653460 TruVek Home Inspections 621442 Kaos Solutions 620912 PETER MCKINNEY BUILDING 620103 UNIVERSITAS TRUST FUNDS 653453 KARR Productions Studios SERVICE 620100 UNIVERSITAS TRUST FUNDS OF 653202 KERRY’S PROFESSIONAL 653252 Pinky’s Roadside Diner (2010) CANADA DECORATING SERVICES 653321 PLASTER ROCK COMFORT GRILL 653148 Vanessa MacFarlane, Registered Massage 653443 Ketchum Realty Group 652959 PRESTIGE AUDIO & HOME THEATRE Therapist 653448 Kezia Law/droit Kezia 653292 PRIORITIES IN FOCUS HEALTH 620565 Veronica’s Music Books & Novelties 620929 KNEADING HANDS Therapeutic WELLNESS AND BALANCE 653335 VILLA DES CHUTES/FALLS VILLA Supplies And Services 653288 PROCTOR-RUSSELL PAINTING 653476 VILLA DES VINS CHEZ CLAUDE’s 653375 Knotting but Wood Signs 653102 Provincial Signs & Service WINE VILLA 653138 KOB SANITATION SUPPLIES 653371 QPC Builders 653225 WEIR INN 653089 La Brasserie Labatt 653247 Reco Properties 653360 Whatever Promo Wear 653091 Labatt Breweries Atlantic Region 653426 REM Safety Training Consultants 653303 WinRay Technology Group 653086 Labatt Breweries of Canada 620741 RITCHIE’S GENERAL CARPENTRY

Loi sur les corporations Business Corporations Act commerciales PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commer- tions Act, a certificate of incorporation has been issued to: ciales, un certificat de constitution en corporation a été émis à : Reference Number Date Registered Office Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

Ridgeback Lodge INC. Kingston 684576 2015 08 26 Maple Product KNB Inc. Kedgwick 684803 2015 09 10 Phil Coombes Enterprise Ltd. Shediac Cape 684988 2015 09 22 D.L. Finish & Flooring Inc. Shediac 685008 2015 09 23 Stephen’s Auto Repair Miramichi Ltd. Miramichi 685013 2015 09 23 The Royal Gazette — October 21, 2015 1255 Gazette royale — 21 octobre 2015

Martin Cell Phone Solutions Ltd. Saint John 685025 2015 09 24 COMEXPERT NEUTRAL SOLUTIONS CA INC. Saint John 685026 2015 09 24 Valley Corner Complex Ltd. Rothesay 685032 2015 09 24 MY RIDE TRANSPORTATION SERVICES LTD. Saint John 685034 2015 09 24 EARTH’S ESSENCE ORGANIC SKIN CARE INC. Quispamsis 685035 2015 09 24 TECHNICAL WELDING SOLUTIONS INC. Saint John 685036 2015 09 24 Smith Cummings & Sons Inc. Fredericton 685043 2015 09 25 GOLDFIN HOLDING LTD. Saint John 685044 2015 09 25 G L Jones Trucking Ltd. Oromocto 685045 2015 09 25 685046 NB Ltd. Petitcodiac 685046 2015 09 25 R.A. Farm Inc. Cookville 685050 2015 09 25 Pêcheries Stéphanie Patrick Ltée Pigeon-Hill 685054 2015 09 25 Spokeshank Consulting Group Inc. Fredericton 685060 2015 09 25 S & M Property Management LTD. Long Point 685061 2015 09 25 Drs. Amy Brennan & Angus MacDonald Professional Moncton 685062 2015 09 25 Corporation Inc. Kean Enterprises Inc. Fredericton 685064 2015 09 25 B&P Auto Sales Ltd. Saint Louis 685065 2015 09 25 685066 N.B. Inc. Fredericton 685066 2015 09 27 Dr. Victor Quartey Professional Corporation Moncton 685069 2015 09 28 Dr. Jonathan Clayton Professional Corporation Fredericton 685072 2015 09 28 685074 N.B. Inc. Fredericton 685074 2015 09 28 685076 NB Inc. Fredericton 685076 2015 09 28 KINGPIN JUICE INC. Fredericton 685081 2015 09 28 New Future Properties Inc. Dieppe 685082 2015 09 28 ISS Global Inc. Fredericton 685086 2015 09 29 INFLUENCE IT CONSULTING INC. St. Francois de Madawaska 685091 2015 09 29 685097 NB LTD. Saint John 685097 2015 09 29 685101 N.B. Inc. Salisbury 685101 2015 09 29 685102 N.B. Inc. Saint John 685102 2015 09 29 CAMPBELL’S AUTO SALES (2015) LTD. Moncton 685107 2015 09 29 J.R. MacTavish Holdings Ltd. Saint John 685109 2015 09 29 Here We Grow Early Learning & Childcare Centre Inc. Salisbury 685110 2015 09 29 TPMC Trucking Ltd. Saint John 685113 2015 09 29

EAST COAST ASPHALT MAINTENANCE LTD. Saint John 685115 2015 09 30 685116 NB Inc. Woodmans Point 685116 2015 09 30 Habibath Investments Inc. Fredericton 685120 2015 09 30 The Royal Gazette — October 21, 2015 1256 Gazette royale — 21 octobre 2015

Ecoleo Consultants Inc. Dieppe 685123 2015 09 30 685129 NB Inc. Campbellton 685129 2015 09 30 East Coast Nutri-Vent Inc. Sussex 685134 2015 09 30 Dave Gorman Financial Strategies Inc. Fredericton 685137 2015 09 30 BACKLAND ENTERPRISES INC. Ammon 685138 2015 09 30 685140 N.B. INC. Upper Cape 685140 2015 09 30 685141 N.B. INC. Dieppe 685141 2015 09 30 LYS TRUCKING LTD. Fredericton 685142 2015 09 30

NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUM Business Corporations Act / Loi sur les corporations commerciales

In relation to a certificate of incorporation issued on September 14, 2015 under the name of “Tandem Passion Inc.”, being corporation #684858, notice is given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of incorporation correcting the name of one of the incorporators and directors from “Rachel Ferguson-Arseneau” to “Rachel Arseneau-Ferguson”.

Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 30 avril 2015 à « TRESOR DES MERS INC. » dont le numéro de corporation est 682419, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat corrigé corrigeant le nom d’un des fondateurs et administrateurs de « Rachel Ferguson-Arseneau » à « Rachel Arseneau-Ferguson ».

______

In relation to a certificate of incorporation issued on September 15, 2015 under the name of “TAYA Holding Inc.”, being corporation #684882, notice is given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of incorporation correcting the name of the corporation from “TAYA Holding Inc.” to “Gestion TAYA Holding Inc.”.

Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 15 septembre 2015 à « TAYA Holding Inc. », dont le numéro de corporation est 684882, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat d’incorporation corrigé faisant passer le nom de la corporation de « TAYA Holding Inc. » à « Gestion TAYA Holding Inc. ».

______

In relation to a certificate of incorporation issued on September 30, 2015 under the name of “East Coast Nutri-Vent Inc.”, being corporation #685134, notice is given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of incorporation correcting the name of the corporation from “East Coast Nutri-Vent Inc.” to “East Coast Nutri-Vend Inc.”.

Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 30 septembre 2015 à « East Coast Nutri-Vent Inc. », dont le numéro de corporation est 685134, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat d’incorporation corrigé faisant passer le nom de la corporation de «East Coast Nutri-Vent Inc. » à «East Coast Nutri-Vend Inc. ».

______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of amendment has been issued to: un certificat de modification a été émis à :

Date Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

CUMMINGS BUILDERS & INVESTMENTS LTD. 002662 2015 09 30 J. P. LAVOIE & SONS LTD. 037182 2015 09 24 NEW BRUNSWICK WIRE FENCE COMPANY LIMITED 051006 2015 09 30

PHILLIPS ENGINEERING AND CONSULTING SERVICES LTD. 053492 2015 09 30 AQUA-TEK PLOMBERIE INC. 504109 2015 09 25 507461 NB. LTD. 507461 2015 09 30 The Royal Gazette — October 21, 2015 1257 Gazette royale — 21 octobre 2015

NORMAC PHARMACY LTD. 508176 2015 09 30 FREDWAL HOLDINGS LTD. 515617 2015 09 30 515635 N.B. LTD. 515635 2015 09 29 043901 N. B. LTD. 604681 2015 09 30 Cricket Cove Ltd. 606978 2015 09 28 Uphill Enterprises Inc. 616294 2015 09 30 CUMMINGS HOLDINGS LTD. 634229 2015 09 30 Riverside Pharmacy Limited 635384 2015 09 30 pobert K. Buzzell Limited 639321 2015 09 25 York Funeral Home Limited 659790 2015 09 30 Haven Lady Holdings Inc. 661203 2015 09 30 Jennco Holdings Ltd. 667433 2015 09 25 PLATINUM RV PARK INC. 672660 2015 09 24 682533 N.B. Inc. 682533 2015 09 28 A&E Colwell Ventures Inc. 684224 2015 09 29 684440 N.B. Ltd. 684440 2015 09 30 HOURGLASS HOLDINGS INC. 684958 2015 09 28 ENDURANCE INVESTMENTS INC. 684975 2015 09 28 MORNCO HOLDINGS INC. 684984 2015 09 30 ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of amendment which includes a change in un certificat de modification contenant un changement de raison name has been issued to: sociale a été émis à :

Date Previous name Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Ancienne raison sociale Numéro de référence année mois jour

052801 N.B. LTD. CAMPBELL’S AUTO SALES LTD. 052801 2015 09 30 Defense First Hockey Ltd. Mike Weaver’s Defensive Training Ltd. 661564 2015 09 28 Collinda Holdings Ltd. RONREG HOLDINGS INC. 664156 2015 09 25 Bathurst Radiator and Springs (2015) Ltd. 682597 NB Inc. 682597 2015 09 18 Benoit & Losier Avocats - Lawyers Inc. 684091 N.-B. Inc. /684091 N.B. Inc. 684091 2015 09 28 Ski Crabbe Mountain (2015) Inc. 684165 N.B. Inc. 684165 2015 09 29 ______The Royal Gazette — October 21, 2015 1258 Gazette royale — 21 octobre 2015

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of amalgamation has been issued to: un certificat de fusion a été émis à : Reference Number Date Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Registered Office Numéro de Year Month Day Corporation issue de la fusion Corporations fusionnantes Bureau enregistré référence année mois jour

B & K. ALLAIN ENTERPRISES LTD. B. & K. ALLAIN ENTERPRISES LTD. Dieppe 684562 2015 09 30 629794 N.B. INC. MEUBLES NU LOOK FURNITURE INC. Coastal Holdings Ltd. COASTAL HOLDINGS LTD. St. Stephen 685023 2015 09 24 OAK BAY AUTO SALES LTD. THE GREAT NORTHERN LAND & TIMBER CORPORATION Eastern Geotech Ltd. EASTERN GEOTECH LTD. Nackawic 685067 2015 09 23 681214 N.B. Inc. 606785 NB Inc. 606785 NB INC. Dieppe 685071 2015 09 30 673228 N.B. Inc. Claudia Chavarie P.C. Inc. Claudia Chavarie P.C. Inc. Moncton 685099 2015 09 30 685020 NB INC. 684492 N.B. Inc. Je Suis Prest Boutique Inc. Riverview 685111 2015 09 28 684492 N.B. Inc. ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of dissolution has been issued to: un certificat de dissolution a été émis à : Reference Number Date Registered Office Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

VERN’S JANITORIAL SERVICE LTD. Saint John 016734 2015 09 23 DORIS’ FISH SHOP LTD. Janeville 049334 2015 09 15 CONSTRUCTION INNOVATION INC. Fredericton 505519 2015 09 23 Dr Aurel Schofield Corporation Professionnelle Inc Dieppe 514525 2015 09 22 DR. N. RAMA MURTHY PROFESSIONAL CORPORATION Bathurst 607567 2015 09 30 PLUSH PUPPY (CANADA) LTD. Saint John 607721 2015 09 23 621411 N.B. Inc. Saint John 621411 2015 09 16 Bob&Scott Services Limited Saint John 636796 2015 09 17 Maritime Ready-Mix Concrete Inc. Grand Falls 649240 2015 09 23 Catapult Marketing Group Inc Moncton 651090 2015 09 18 PSL Safety Consultants Inc. Charlo 665415 2015 09 16 ViniCo Service Limited Saint John 672935 2015 09 30

______The Royal Gazette — October 21, 2015 1259 Gazette royale — 21 octobre 2015

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of discontinuance has been issued to: un certificat de cessation a été émis à :

Date Jurisdiction of Continuance Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Compétence de prorogation Numéro de référence année mois jour

Hologic Canada Limited Colombie-Britannique/ 618724 2015 09 24 British Columbia Zygo Canada Inc. Alberta 636756 2015 09 28 ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of revival has been issued to: un certificat de reconstitution a été émis à :

Date Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

DON R. CURRY AND ASSOCIATES LTD. 036101 2015 09 28 Direct Mortgage Inc. 617629 2015 09 29 Lil Imagination Station Daycare Inc. 637943 2015 09 25 654501 N.B. Ltd. 654501 2015 09 29 Frontier Technical Services Inc. 665300 2015 09 29 ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of registration of extra-provincial corporation un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a été has been issued to: émis à : Reference Number Date Jurisdiction Agent and Address Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Compétence Représentant et adresse référence année mois jour

YAMAHA MOTOR FINANCE Canada McInnes Cooper CSD 684999 2015 09 22 CANADA LTD. Services Inc. FINANCEMENT YAMAHA MOTEUR Fredericton DU CANADA LTÉE PROCON MEASUREMENT & Ontario Stewart McKelvey Corporate 685016 2015 09 23 CONTROL INC. Services (NB) Inc. Saint John GE HEALTHCARE CANADA INC. Ontario Stewart McKelvey Corporate 685019 2015 09 24 Services (NB) Inc. Saint John WINDY FOREST LLC Delaware Daniel L. Stevenson 685031 2015 09 24 Fredericton

BUREAU D’EXPERTISES S.J. Canada McInnes Cooper CSD 685041 2015 09 25 KERNAGHAN LTEE Services Inc. S.J. KERNAGHAN ADJUSTERS LTD. Fredericton

LAITRAM MACHINERY, INC. Louisiana McInnes Cooper CSD 685042 2015 09 25 Services Inc. Fredericton QUADRANGLE ARCHITECTS Ontario Kelsey Bingham 685048 2015 09 25 LIMITED Moncton The Royal Gazette — October 21, 2015 1260 Gazette royale — 21 octobre 2015

8487693 CANADA INC. Canada Annie Morrissette 685080 2015 09 28 Bathurst GT BILL LTD. Colombie-Britannique/ Stewart McKelvey Corporate 685093 2015 09 29 British Columbia Services (NB) Inc. Saint John ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of amendment of registration of extra- un certificat de modification de l’enregistrement de corporation provincial corporation has been issued to: extraprovinciale a été émis à : Reference Number Date Previous name Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Ancienne raison sociale référence année mois jour

Autofinco Inc. State Farm Finance Corporation of Canada 075250 2015 09 29 Corporation de crédit State Farm du Canada ALSTOM SITCA ULC Alstom Sitca Inc. 650861 2015 09 21 Saint John NB ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of registration of amalgamated corporation un certificat d’enregistrement d’une corporation extraprovinciale has been issued to the following extra-provincial corporations: issue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales sui- vantes : Reference Agent and Address Number Date Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Représentant et Numéro de Year Month Day Corporation issue de la fusion Corporations fusionnantes adresse référence année mois jour

INFORMA CANADA INC. Informa Canada Inc. McInnes Cooper CSD 685040 2015 09 25 Services Inc. Street Capital Financial Street Capital Financial Corporation Peter R. Forestell 685100 2015 09 29 Corporation Saint John Corporation Financière Street Capital

Companies Act Loi sur les compagnies PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act, SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres letters patent have been granted to: patentes ont été émises à : Reference Number Date Head Office Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Siège social référence année mois jour

Deer Island Fibre Project Inc. Leonardville 685079 2015 09 28

______The Royal Gazette — October 21, 2015 1261 Gazette royale — 21 octobre 2015

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act, SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres supplementary letters patent have been granted to: patentes supplémentaires ont été émises à :

Date Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

SAINT JOHN REGIONAL HOSPITAL FOUNDATION INC. 014649 2015 09 29 ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act, SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, l’abandon de the surrender of charter has been accepted and the company has been la charte des corporations suivantes a été accepté, et que celles-ci sont dissolved: dissoutes : Date Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Numéro de réference année mois jour

ALI-SANTE EME INC. 023841 2015 09 24 ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that the charter of the following SACHEZ que la charte de la compagnie suivante est reconstituée company is revived under subsection 35.1(1) of the Companies Act: en vertu du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les compagnies :

Date Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

LA SOCIETE CULTURELLE DE KENT-NORD INC. 015319 2015 09 22 Greater Moncton Down Syndrome Society Inc. 025827 2015 09 29 Société du syndrome de Down du Grand Moncton Inc. Codiac Chords Inc. 634363 2015 09 24

Loi sur l’enregistrement des Partnerships and Business Names sociétés en nom collectif et des Registration Act appellations commerciales PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en Business Names Registration Act, a certificate of business name has nom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appel- been registered: lation commerciale a été enregistré : Registrant of Address of Business Reference Certificate or Agent Number Date Enregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

Stephanie Scissorhands Salon Stephanie Collette Moncton 684818 2015 09 23

Brenda’s Academy of 683693 NB Inc. Moncton 684969 2015 09 21 Professional Dog Grooming Brenda’s Poodle Parlour 683693 NB Inc. Moncton 684971 2015 09 21 The Royal Gazette — October 21, 2015 1262 Gazette royale — 21 octobre 2015

Média NB New Brunswick Producers Moncton 684977 2015 09 29 Association Inc./ L’Association des producteurs du Nouveau-Brunswick inc. Café Jade et MariLove Mariline Dube Saint-Quentin 685003 2015 09 23 ANTIQUES PLUS Kevin Joseph Surette Belledune 685005 2015 09 23 CHATEAU DAIGLE B & B Real Daigle St. Charles 685007 2015 09 23 A. & A. Driver Education 684559 N.B. INC. Dieppe 685021 2015 09 24 SIMPLY CLEAN HOUSEKEEPING Marsha Burrill Waterville Sunbury 685024 2015 09 24 by Marsha Dahlias Hair Design Terry Lyne Toner Sackville 685028 2015 09 28 The Bluebird Cafe 682395 N.B. Ltd. Moncton 685029 2015 09 24 The Urban Farmgirl Deanna Jo Norton Fredericton 685033 2015 09 24 HILL ASSISTANT BIKE & TRIKE Albert R. Mossman Fredericton 685037 2015 09 24 Arcon Enterprises James Arnold Penniac 685038 2015 09 24 Ocean White Wolf Enterprises Cyril Polchies Elsipogtog 685039 2015 09 24 Lauren’s Makeup & Nails Lauren Arseneault Sussex 685047 2015 09 25 Travel Nation Hotels 8742995 Canada Inc. Saint John 685049 2015 09 25

REG WEBB SAFETY CONSULTING Reginald Webb Lakeside 685051 2015 09 25 Homestead Creations Stephanie Heenan-Orr Charters Settlement 685053 2015 09 25 Sems Transport 2240599 ONTARIO INC. Dieppe 685055 2015 09 25 CA Retirees Association Bill Gammell Moncton 685056 2015 09 25 Gordon Wood Margaret Hicks AVALAWN Horticultural Terrance Melanson Moncton 685057 2015 09 25 eLeet Breathalyzers Curtis Leet Allsion 685063 2015 09 25 Penny’s Pet Pantry Dylan Saulnier Moncton 685078 2015 09 28 Yvon’s Tools And More Store Yvon Deschenes Saint John 685083 2015 09 28 Seal Cove Salmon Kelly Cove Salmon Ltd. Saint John 685087 2015 09 28 Holmes Healthy Vending Andrew Holmes Saint John 685089 2015 09 29 Rob Case’s Custom Homes Robert Case Hanwell 685090 2015 09 29 LINGUITEK TRANSLATION Jeanne D’Arc Bossé St.-Joseph-de-Madawaska 685095 2015 09 29 I SEE DEEP PURPLE HAIR Denise J. Bossé St. Basile 685096 2015 09 29 PRODUCT MARITIME DENT REMOVAL Kim Palmer Hawkshaw 685103 2015 09 29 KnowMadd Automotive Jennifer Normand Port Elgin 685112 2015 09 29 Cindy Dyer Guide Service Cindy Dyer Burntland Brook 685114 2015 09 29

KCC CONTRACTING Melissa Thibodeau Carter’s Point 685125 2015 09 30 CTM Photography Normagene Chase Hawkins Corner 685126 2015 09 30 The Royal Gazette — October 21, 2015 1263 Gazette royale — 21 octobre 2015

DANNY FITZHERBERT GUIDE Danny Fitzherbert Plaster Rock 685127 2015 09 30 SERVICE Bartlett Gardens Care Home Michael Symonds Richibucto 685128 2015 09 30 Dietitians in the Kitchen Julie Melanson Dieppe 685131 2015 09 30 TRIM EAST Andrea Hall Norton 685135 2015 09 30 Dinetek Consulting Joeseph Goodine Moncton 685136 2015 09 30 ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en Business Names Registration Act, a certificate of renewal of business nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re- name has been registered: nouvellement d’appellation commerciale a été enregistré : Registrant of Address of Business Reference Certificate or Agent Number Date Enregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

CLEANOL JANITORAL SERVICES Darlene Lavigne Keswick Ridge 336987 2015 09 24 GLEEM TEAM 2000 Cliff Mitchell Moncton 350005 2015 09 27 J R K Holdings James McBrine Rothesay 613483 2015 09 29 THE WILD CARROT CAFE A WHALE OF A CAFE INC. Saint John 614844 2015 09 28 STEVENSON’S SPECIAL CARE Karen Carson Mill Cove 619715 2015 09 28 HOME Mercury Marine Acceptance Canada GE COMMERCIAL Saint John 620644 2015 09 28 DISTRIBUTION FINANCE CANADA/GE FINANCEMENT COMMERCIAL AUX DETAILLANTS CANADA Sheldon’s Sheetrock Sheldon McDevitt Saint John 620839 2015 09 24 J Reno Carpentry Jason Green Saint John 621313 2015 09 29 RIVER VALLEY FINE CRAFTS THE CITY OF FREDERICTON Fredericton 621797 2015 09 28

WATSON SEPTIC TANK SERVICES Gerald Watson Kars 650365 2015 09 24 The White Lotus Tattoo & Company Shawn Martinson Fredericton 652274 2015 09 24 GO ORGANIC Atlantic Distributors 649623 NB Ltd. Woodstock 652486 2015 09 24 Billy English Construction & William English Beaverbrook 652522 2015 09 27 Renovations YORK CARE CENTRE YORK MANOR INC. Fredericton 652558 2015 09 28 HOST Event and Association Sara Robinson Moncton 652572 2015 09 28 Management Crown Media Robert Charles Giffard Riverview 652848 2015 09 25

First Revival Pentecostal Queensbury Christian Nackawic 652869 2015 09 04 Church of Queensbury Centre, Inc. JIM BOB’S VARIETY Frank & Sons Enterprises Ltd. Saint John 652952 2015 09 29 B.C. Wrecker Sales Brian Clarke Moncton 652953 2015 09 29 The Royal Gazette — October 21, 2015 1264 Gazette royale — 21 octobre 2015

Take it for Granite Countertops Darren Long Sussex Corner 652963 2015 09 28 EUREST SERVICES Compass Group Canada Ltd. Saint John 653524 2015 09 28 Groupe Compass Canada Ltée ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en Business Names Registration Act, a certificate of cessation of busi- nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessa- ness or use of business name has been registered: tion de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation com- merciale a été enregistré : Reference Number Date Address / Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Adresse référence année mois jour

BARK AVENUE DOG GROOMING Keswick 329203 2015 09 23 ARMTEC Saint John 614536 2015 09 24 BIG ’O’ Saint John 614537 2015 09 24 CAMPBELL’S AUTO SALES Riverview 622809 2015 09 29 Brenda’s Poodle Parlour Moncton 625817 2015 09 21 ANTIQUES PLUS Belledune 626029 2015 09 23 Brenda’s Academy of Professional Dog Grooming Moncton 626144 2015 09 21 DURISOL Saint John 639554 2015 09 24 Here We Grow Childcare Center Salisbury 653279 2015 09 29 Martin Cell Phone Solutions Saint John 666489 2015 09 24 ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en Business Names Registration Act, a certificate of partnership has nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de so- been registered: ciété en nom collectif a été enregistré : Address of Business Reference or Agent Number Date Adresse du commerce Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Partners / Membres ou du représentant référence année mois jour

J and J Flooring Installation John Andrew Molnar Fredericton 685030 2015 09 24 John-Paul Molnar ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en Business Names Registration Act, a certificate of dissolution of part- nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de disso- nership has been registered: lution de société en nom collectif a été enregistré : Reference Number Date Address / Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Adresse référence année mois jour

Bore City Brewing Moncton 681022 2015 09 23 ______The Royal Gazette — October 21, 2015 1265 Gazette royale — 21 octobre 2015

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en Business Names Registration Act, a certificate of change of member- nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de chan- ship of partnership has been registered: gement d’associé d’une société en nom collectif a été enregistré : Reference Number Date Retiring Partners Incoming Partners Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Associés sortants Nouveaux associés référence année mois jour

AEROSPORT - N.B. Eric Marchand Joanne Leblanc 653964 2015 09 23 Cormier

Limited Partnership Act Loi sur les sociétés en commandite

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une ship Act, a declaration of limited partnership has been filed by: déclaration de société en commandite a été déposée par :

Principal place in Reference New Brunswick Number Date General Partners Principal établissement au Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Commandités Nouveau-Brunswick référence année mois jour

Y & R CANADA INVESTMENTS LP Cygnet Holdings Inc. Saint John 400514 2015 09 15 Seahorse Shipping and Trading Limited Drishbane Global Ltd. Saint John 684972 2015 09 21 Partnership ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une ship Act, a declaration of extra-provincial limited partnership has déclaration de société en commandite extraprovinciale a été dépo- been filed: sée par : Principal place in Reference New Brunswick Agent and Address Number Date Principal établissement au Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Nouveau-Brunswick Compétence et adresse référence année mois jour

BELL EXPRESSVU LIMITED Saint John Ontario Saint John 400559 2015 09 21 PARTNERSHIP CLAIRVEST EQUITY PARTNERS Saint John Ontario Saint John 400562 2015 09 23 LIMITED PARTNERSHIP CLAIRVEST GENERAL Saint John Ontario Saint John 400563 2015 09 23 PARTNER L.P. GOLDMAN SACHS ASSET Saint John Delaware Saint John 654015 2015 09 25 MANAGEMENT, L.P.

GOLDMAN SACHS EXECUTION & Saint John New York Saint John 654018 2015 09 25 CLEARING, L.P. ______The Royal Gazette — October 21, 2015 1266 Gazette royale — 21 octobre 2015

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une ship Act, a declaration of withdrawal of extra-provincial limited déclaration de retrait de société en commandite extraprovinciale a partnership has been filed: été déposée par : Reference Agent and Address Number Date Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Compétence et adresse référence année mois jour

Renewable Construction Services Limited Manitoba Stewart McKelvey Corporate 645464 2015 09 21 Partnership Services (NB) Inc. Saint John ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une ship Act, a declaration of change of limited partnership or extra- déclaration de changement de société en commandite ou de société provincial limited partnership has been filed: en commandite extraprovinciale a été déposée : Principal place in Reference New Brunswick Number Date Jurisdiction General Partners Principal établissement au Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Compétence Commandités Nouveau-Brunswick référence année mois jour

SUPERIOR PLUS LP Ontario Superior General Partner Moncton 628930 2015 09 21 Inc.

Department of Ministère des Human Resources Ressources humaines

NOTICE AVIS PUBLIC SERVICE LABOUR LOI RELATIVE AUX RELATIONS DE TRAVAIL RELATIONS ACT DANS LES SERVICES PUBLICS OCCUPATIONAL GROUP AMENDMENTS MODIFICATIONS AU GROUPE PROFESSIONNEL Pursuant to Section 24 of the Public Service Labour Relations Conformément à l’article 24 de la Loi relative aux relations de Act, notice is hereby given of amendments to the following Oc- travail dans les services publics, avis est donné par les présentes cupational Group effective September 1, 2015: que des modifications ont été apportées au groupe professionnel suivant, effectif le 1 septembre 2015:

Operational Category, Part III Catégorie De L’exploitation, Partie III Group 381 - Institutional Services Groupe 381: Services d’établissement

RETITLED CLASSIFICATIONS CLASSIFICATIONS REDÉSIGNÉES Supply Technician to Medical Device Technicien / technicienne en approvisionnement Reprocessing Technician 2070 à Technicien / technicienne en retraitement de dispositifs médicaux 2070

______The Royal Gazette — October 21, 2015 1267 Gazette royale — 21 octobre 2015

NOTICE AVIS PUBLIC SERVICE LABOUR LOI RELATIVE AUX RELATIONS DE TRAVAIL RELATIONS ACT DANS LES SERVICES PUBLICS OCCUPATIONAL GROUP AMENDMENT MODIFICATION AU GROUPE PROFESSIONNEL Pursuant to Section 24 of the Public Service Labour Relations Conformément à l’article 24 de la Loi relative aux relations de Act, notice is hereby given of amendments effective October 1, travail dans les services publics, avis est donné par les présentes 2015: des modifications suivantes apportées effectifs le 1 octobre 2015:

Operational Category, Part I Catégorie de l’exploitation, Partie I Group: General Labour and Trades (183) Groupe : Manœuvres et métiers (183)

ADD CLASSIFICATIONS CODES NOUVELLES CLASSIFICATIONS CODES Supplies Courier 9599 1 83 Messager/Messagère à la livraison des approvisionnements 9599 1 83 Cartage Driver 9600 1 83 Camionneur/Camionneuse 9600 1 83 Courier Coordinator 9601 1 83 Coordinateur/Coordinatrice des services de messagerie 9601 1 83 Industrial Mechanic 9602 1 83 Mécanicien Industriel/mécanicienne industrielle 9602 1 83 Patient and Supply Courier 9603 1 83 Messager/Messagère des patients et d’approvisionnements 9603 1 83 Sewing Machine Operator 9604 1 83 Opérateur/Opératrice de machine à coudre 9604 1 83 Medical Device Reprocessing Technician 9605 1 83 Technicien/Technicienne en retraitement des dispositifs médicaux 9605 1 83 Supplies Services Supervisor 9606 1 83 Surveillant/surveillante des services de l’approvisionnement 9606 1 83

______

NOTICE AVIS PUBLIC SERVICE LABOUR LOI RELATIVE AUX RELATIONS DE TRAVAIL RELATIONS ACT DANS LES SERVICES PUBLICS OCCUPATIONAL GROUP AMENDMENT MODIFICATION AU GROUPE PROFESSIONNEL Pursuant to Section 24 of the Public Service Labour Relations Conformément à l’article 24 de la Loi relative aux relations de Act, notice is hereby given of an amendment effective October travail dans les services publics, avis est donné par les présentes 1, 2015: qu’une modification a été apportée effectif le 1 octobre 2015:

Operational Category, Part I Catégorie de l’exploitation, Partie I Group: Institutional Services (181) Groupe : Services d’établissement (181)

NEW CLASSIFICATION CODE NOUVELLE CLASSIFICATION CODE Laundry Services Coordinator 8092 Coordonnateur/coordonnatrice des services de buanderie 8092 Laundry Services Supervisor 8093 Surveillant/surveillante des services de buanderie 8093 Laundry Services Worker 8094 Préposé/préposée aux services de buanderie 8094 Clean Laundry Processor 8095 Préposé/préposée à la lessive propre 8095 Environmental Services Worker B 8096 Préposé/préposée aux services d’entretien ménager B 8096

______The Royal Gazette — October 21, 2015 1268 Gazette royale — 21 octobre 2015

NOTICE AVIS PUBLIC SERVICE LABOUR LOI RELATIVE AUX RELATIONS DE TRAVAIL RELATIONS ACT DANS LES SERVICES PUBLICS OCCUPATIONAL GROUP AMENDMENT MODIFICATION AU GROUPE PROFESSIONNEL Pursuant to Section 24 of the Public Service Labour Relations Conformément à l’article 24 de la Loi relative aux relations de Act, notice is hereby given of an amendment effective October travail dans les services publics, avis est donné par les présentes 1, 2015: qu’une modification a été apportée effectif le 1 octobre 2015:

Technical Occupational Category, Part I Catégorie technique, Partie I Group: Engineering and Field (123) Groupe : Techniciens et technologistes des travaux de génie (123)

NEW CLASSIFICATION CODE NOUVELLE CLASSIFICATION CODE Clinical Engineering Technologist 1 4029 Technologue de génie clinique 1 4029 Clinical Engineering Technologist 2 4030 Technologue de génie clinique 2 4030 Clinical Engineering Technologist 3 4031 Technologue de génie clinique 3 4031 Clinical Engineering Technologist 4 4032 Technologue de génie clinique 4 4032

Financial and Consumer Commission des services Services Commission financiers et des services aux consommateurs

NOTICE OF RULE AVIS DE RÈGLE The making of amendments to L’établissement des modifications aux textes suivants :  National Instrument 21-101 Marketplace Operation;  a Norme canadienne 21-101 sur le fonctionnement du marché,  National Instrument 23-101 Trading Rules; and  la Norme canadienne 23-101 sur les règles de négociation; et  Related Companion Policies.  les instructions complémentaires afférentes.

(Collectively, the amendments) (Collectivement, les modifications)

Ministerial Consent Consentement ministériel On 14 September 2015, the Minister of Justice consented to the Le 14 septembre 2015, le ministre de la Justice a donné son making of the above-noted amendments. consentement à l’établissement des modifications énoncées ci- dessus.

Summary of Amendments Résumé des modifications The main purpose of the amendments is to update the require- Le principal objectif des modifications est la mise à jour des ments applicable to marketplaces’ and information processors’ obligations applicables aux systèmes et à la planification de la systems and business continuity planning. These changes apply continuité des activités des marchés et des agences de traite- to marketplaces, including alternative trading systems, recog- ment de l’information. Ces modifications s’appliquent aux mar- nized quotation and trade reporting systems, recognized ex- chés, notamment les systèmes de négociation parallèles, les sys- changes, and information processors. tèmes reconnus de cotation et de déclaration d’opérations et les bourses reconnues, et aux agences de traitement de l’informa- tion.

Effective Date Date d’entrée en vigueur The amendments came into force in New Brunswick on 1 Oc- Les modifications sont entrées en vigueur au Nouveau- tober 2015. Brunswick le 1er octobre 2015.

How to Obtain a Copy Comment obtenir un exemplaire The text of the above-noted amendments can be obtained from On trouvera le texte des modifications énoncées ci-dessus par the Commission’s website: http://www.fcnb.ca l’entremise du site web de la Commission : www.fcnb.ca

Paper copies may be obtained from the Commission by writing, On peut se procurer un exemplaire sur papier du document en telephoning or e-mailing: communiquant par courrier, par téléphone ou par courriel avec la Commission, dont voici les coordonnées: The Royal Gazette — October 21, 2015 1269 Gazette royale — 21 octobre 2015

Secretary Secrétaire Financial and Consumer Services Commission Commission des services financiers et des services aux 85 Charlotte Street, Suite 300 consommateurs Saint John, N.B. E2L 2J2 85, rue Charlotte, bureau 300 Telephone: 506-658-3060 Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2 Toll Free: 866-933-2222 (within NB only) Téléphone : 506-658-3060 Fax: 506-658-3059 Sans frais : 1-866-933-2222 (au N.-B. seulement) E-mail: [email protected] Télécopieur : 506-658-3059 Courriel : [email protected]

Notices of Sale Avis de vente

AUDREY ANN ARSENAULT and JOSEPH ANDREW AUDREY ANN ARSENAULT et JOSEPH ANDREW AR- ARSENAULT, of 169 Main Street, St. Martins, in the County SENAULT, du 169, rue Main, à St. Martins, comté de Saint of St. John and Province of New Brunswick, mortgagors and John, province du Nouveau-Brunswick, débiteurs hypothé- owners of the equity of redemption, CITIFINANCIAL CAN- caires et propriétaires du droit de rachat; CITIFINANCIÈRE, ADA EAST CORPORATION, holder of the first and second CORPORATION DU CANADA EST, titulaire des première Mortgages and to ALL OTHERS WHOM IT MAY CON- et deuxième hypothèques; et TOUT AUTRE INTÉRESSÉ CERN. ÉVENTUEL. Freehold premises situate, lying and being at 169 Main Street, Lieux en tenure libre situés au 169, rue Main, à St. Martins, St. Martins, in the County of St. John and Province of New comté de Saint John, province du Nouveau-Brunswick, et dont Brunswick, known as PID 410340. le NID est 410340. Notice of sale is given by the holder of the said first Mortgage. Avis de vente donné par la titulaire de ladite première hypo- thèque. Sale to be held on November 12th, 2015 at 11:00 a.m. at the La vente aura lieu le 12 novembre 2015, à 11 h, au palais de Saint John Law Courts located at 10 Peel Plaza, in Saint John, justice de Saint John, 10, place Peel, Saint John, comté de Saint in the County of Saint John and Province of New Brunswick. John, province du Nouveau-Brunswick. See advertisement in the newspaper Telegraph Journal, editions Voir l’annonce publiée dans les éditions des 15, 22 et 29 octobre of October 15, 22, 29, and November 5, 2015. et du 5 novembre 2015 du Telegraph Journal. Dated at Edmundston, New Brunswick, this 29th, day of Sep- Fait à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, le 29 sep- tember, 2015. tembre 2015.

GARY J. McLAUGHLIN,Q.C., McLaughlin Law Offices, So- GARY J. McLAUGHLIN, c.r., Cabinet McLaughlin Law Of- licitors and agents for CitiFinancial Canada East Corporation fice, Avocats et représentants de CitiFinancière, corporation du Canada Est

______

Sale of Lands Publication Act Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2) L.R.N.-B. 1973, c.S-2, paragr.1[2] To Shokooh Mostafaie, original Mortgagor, and to all others Destinataire : Shokooh Mostafaie, débitrice hypothécaire origi- whom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mortgage naire; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée en vertu and the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amend- des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur ment thereof. Freehold property being situated at 15 Harvest les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libre situés Court, Fredericton, New Brunswick, the same lot conveyed to au 15, cour Harvest, à Fredericton (Nouveau-Brunswick), cor- Shokooh Mostafaie by Deed registered in the York County Reg- respondant au même lot ayant été transféré à istry Office on March 28, 2012, as document number 31293856. Shokooh Mostafaie par l’acte de transfert enregistré au bureau de l’enregistrement du comté de York le 28 mars 2012, sous le numéro 31293856. Notice of Sale given by The Bank of Montreal as Mortgagee. Avis de vente donné par la Banque de Montréal, créancière hy- Sale to be held at the offices of the Fredericton Court House, pothécaire. La vente aura lieu le 29 octobre 2015, à 11 h, heure 427 Queen Street, Fredericton, New Brunswick on the 29th day locale, au palais de justice de Fredericton, 427, rue Queen, Fre- of October, 2015, at the hour of 11:00 a.m., local time. See ad- dericton (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans vertisement of Notice of Sale in The Daily Gleaner dated Octo- les éditions des 1er, 8, 15 et 22 octobre 2015 du Daily Gleaner. ber 1, 8, 15 and 22, 2015. The Royal Gazette — October 21, 2015 1270 Gazette royale — 21 octobre 2015

McInnes Cooper, Solicitors for The Bank of Nova Scotia, Per: Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Banque Adel Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400, de Nouvelle-Écosse, Centre de la Croix Bleue, bureau S400, 644, P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, Tele- rue Main, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6; phone: (506) 857-8970, Facsimile: (506) 857-4095. téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095

______

Sale of Lands Publication Act Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2) L.R.N.-B. 1973, c.S-2, paragr.1(2) To: David Darrell Phillips (Darrell David Phillips), original Destinataires : David Darrell Phillips (Darrell David Phillips), mortgagor and owners of the equity of redemption; and Regi- débiteur hypothécaire originaire et propriétaire du droit de ra- nald Eugene Phillips, attorney of the original mortgagor; and to chat; Reginald Eugene Phillips, fondé de pouvoir du débiteur all others whom it may concern. Sale pursuant to terms of the hypothécaire originaire; et tout autre intéressé éventuel. Vente mortgage and the Property Act, R.S.N.B. 1973, c.P-19, as effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de amended. Freehold property situate at 106 First Plymouth celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en Road, Woodstock, in the County of Carleton and Province of tenure libre situés au 106, chemin First Plymouth, à Woods- New Brunswick, and being identified as PID 10124279. tock, comté de Carleton, province du Nouveau-Brunswick, et dont le NID est 10124279. Notice of Sale given by The Toronto-Dominion Bank, mort- Avis de vente donné par la Banque Toronto-Dominion, créan- gagee and holder of the mortgage. Sale to be held at the Wood- cière hypothécaire et titulaire de l’hypothèque. La vente aura stock Court House, 698 Main Street, Woodstock, New Bruns- lieu le jeudi 29 octobre 2015, à 11 h, heure locale, au palais de wick on Thursday, October 29, 2015 at the hour of 11:00 a.m., justice de Woodstock, 698, rue Main, Woodstock (Nouveau- local time. See advertisement of Notice of Mortgage Sale in the Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions du 29 sep- Bugle Observer dated September 29, October 6, 13 and 20, tembre et des 6, 13 et 20 octobre 2015 du Bugle-Observer. 2015.

McInnes Cooper, Solicitors for The Toronto-Dominion Bank, Natalie M. Stewart, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Per: Natalie M. Stewart, Suite 1700, Brunswick Square, Banque Toronto-Dominion, Brunswick Square, 1, rue Ger- 1 Germain Street, P.O. Box 6370, Saint John, New Brunswick, main, bureau 1700, C.P. 6370, Saint John (Nouveau- E2L 4R8, Telephone: 506-643-6500, Facsimile: 506-643-6505. Brunswick) E2L 4R8; téléphone : 506-643-6500; télécopieur : 506-643-6505

______

Sale of Lands Publication Act Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2) L.R.N.-B. 1973, c. S-2, paragr. 1[2] To Joanne Richard, Marie Joanne Richard, original Mortgagor, Destinataires : Joanne Richard, Marie Joanne Richard, débi- Estate of Eugère Richard as Spouse of Marie Joanne Richard, trice hypothécaire originaire, la succession d’Eugère Richard, and to all others whom it may concern. Sale pursuant to terms conjoint de Marie Joanne Richard, et tout autre intéressé éven- of the Mortgage and the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 tuel. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypo- and Acts in amendment thereof. Freehold property being situ- thèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c. P- ated at 254 Richibucto-Village, Richibucto-Village, New 19. Biens en tenure libre situés au 254, chemin Richibucto-Vil- Brunswick, the same lot conveyed to Joanne Richard by Trans- lage, à Richibucto-Village, au Nouveau-Brunswick, et corres- fer registered in the Land Titles Office on February 4, 2010 as pondant au même lot ayant été transféré à Joanne Richard par number 28341007. l’acte de transfert enregistré au bureau de l’enregistrement fon- cier le 4 février 2010, sous le numéro 28341007. Notice of Sale given by Scotia Mortgage Corporation. Sale to Avis de vente donné par la Société hypothécaire Scotia. La be held at the Bouctouche Municipal Town Hall, located at 30 vente aura lieu le 29 octobre 2015, à 11 h, heure locale, à l’hôtel Evangeline Street, Bouctouche, New Brunswick, on the 29th de ville de Bouctouche, situé au 30, rue Évangéline, à Bouc- day of October, 2015, at the hour of 11:00 a.m., local time. See touche, au Nouveau-Brunswick. Voir l’annonce publiée dans advertisement of Notice of Sale in the Times and Transcript les éditions des 1er, 8, 15 et 22 octobre 2015 du Times & Trans- dated October 1, 8, 15 and 22, 2015. cript.

McInnes Cooper, Solicitors for Scotia Mortgage Corporation, Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Société Per: Adel Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite hypothécaire Scotia, Centre de la Croix Bleue, bureau S400, S400, P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, 644, rue Main, C. P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) Telephone: (506) 857-8970, Facsimile: (506) 857-4095 E1C 8T6; téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857- 4095 The Royal Gazette — October 21, 2015 1271 Gazette royale — 21 octobre 2015

Notice to Advertisers Avis aux annonceurs

The Royal Gazette is published every Wednesday under the La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformé- authority of the Queen’s Printer Act. Documents must be re- ment à la Loi sur l’Imprimeur de la Reine. Les documents à ceived by the Royal Gazette Coordinator, Legislative publier doivent parvenir à la coordonnatrice de la Gazette Services, no later than noon, at least seven days prior to royale, aux Services législatifs, à midi, au moins sept jours Wednesday’s publication. Each document must be separate avant le mercredi de publication. Chaque avis doit être séparé from the covering letter. Signatures on documents must be im- de la lettre d’envoi. Les noms des signataires doivent suivre mediately followed by the printed name. The Royal Gazette immédiatement la signature. La coordonnatrice de la Gazette Coordinator may refuse to publish a document if any part of it royale peut refuser de publier un avis dont une partie est illi- is illegible, and may delay publication of any document for ad- sible et retarder la publication d’un avis pour des raisons ad- ministrative reasons. ministratives. Prepayment is required for the publication of all documents. Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis. Standard documents have the following set fees: Voici les tarifs pour les avis courants :

Cost per Coût par Notices Insertion Avis parution

Notice of the intention to apply for the enactment of a $20 Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loi 20 $ private bill d’intérêt privé Originating process $ 25 Acte introductif d’instance 25 $ Order of a court $ 25 Ordonnance rendue par une cour 25 $ Notice under the Absconding Debtors Act $20 Avis exigé par la Loi sur les débiteurs en fuite 20 $ Notice under the General Rules under the Law Society Act, $20 Avis de radiation ou de suspension ou de demande de 20 $ 1996, of disbarment or suspension or of application for réintégration ou de réadmission, exigé par les Règles reinstatement or readmission générales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur le Barreau Notice of examination under the Licensed Practical Nurses $25 Avis d’examen exigé par la Loi sur les infirmières et 25 $ Act infirmiers auxiliaires autorisés Notice under the Motor Carrier Act $30 Avis exigé par la Loi sur les transports routiers 30 $ Any document under the Political Process Financing Act $20 Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur le 20 $ financement de l’activité politique Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9 $20 Avis aux créanciers exigé par le Règlement du Nouveau- 20 $ under the Probate Court Act Brunswick 84-9 établi en vertu de la Loi sur la Cour des successions Notice under Rule 70 of the Rules of Court $120 Avis exigé par la Règle 70 des Règles de procédure 120 $ Note: Survey Maps cannot exceed 8.5″ x 14″ Nota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 po sur 14 po Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is $20 Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voie 20 $ 1/2 page in length or less d’annonces, si l’avis est d’une demi-page ou moins en longueur Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is $75 Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voie 75 $ greater than 1/2 page in length d’annonces, si l’avis est de plus d’une demi-page en longueur Any document under the Winding-up and Restructuring Act $20 Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur les 20 $ (Canada) liquidations et les restructurations (Canada) Notice of a correction charge is Avis d’une correction les frais sont the same as les mêmes que for publishing ceux imposés the original pour la document publication du document original Any other document $3.50 for each Tout autre document 3,50 $ pour cm or less chaque cm ou moins

Payments can be made by cash, MasterCard, VISA, cheque or Les paiements peuvent être faits en espèces, par carte de money order (payable to the Minister of Finance). No refunds crédit MasterCard ou VISA, ou par chèque ou mandat (à will be issued for cancellations. l’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation.

The official version of The Royal Gazette is available free La version officielle de la Gazette royale est disponible gra- on-line each Wednesday. This free on-line service replaces the tuitement et en ligne chaque mercredi. Ce service gratuit en printed annual subscription service. The Royal Gazette can be ligne remplace le service d’abonnement annuel. Vous trouve- accessed on-line at: rez la Gazette royale à l’adresse suivante : The Royal Gazette — October 21, 2015 1272 Gazette royale — 21 octobre 2015

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/ attorney_general/royal_gazette.html procureur_general/gazette_royale.html

Print-on-demand copies of The Royal Gazette are available, at Nous offrons, sur demande, des exemplaires de la Gazette the following address, at $4.00 per copy plus 5% tax, plus royale, à l’adresse suivante, pour la somme de 4 $ l’exem- shipping and handling where applicable. plaire, plus la taxe de 5 %, ainsi que les frais applicables de port et de manutention.

Legislative Services Services législatifs Office of the Attorney General Cabinet du procureur général Chancery Place Place Chancery 675 King Street 675, rue King P.O. Box 6000 C.P. 6000 Fredericton, NB E3B 5H1 Fredericton (N.-B.) E3B 5H1

Tel: 506-453-8372 Tél. : 506-453-8372 E-mail: [email protected] Courriel : [email protected]

Note: Deliveries are to be addressed to The Royal Gazette and Note : Toute livraison étant adressée à la Gazette royale doit left with the Commissionaire. être remise au commissionnaire.

QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved / Tous droits réservés