The Royal Gazette Gazette royale

Fredericton Fredericton Nouveau-Brunswick

ISSN 1714-9428

Vol. 179 Wednesday, January 20, 2021 / Le mercredi 20 janvier 2021 45

Notice to Readers Avis aux lecteurs

The Royal Gazette is officially published Online. La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne. Except for formatting, documents are published in The Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans Royal Gazette as submitted. la Gazette royale comme soumis. Material submitted for publication must be received by Les documents à publier doivent parvenir au The Royal Gazette coordinator no later than noon, at least coordonnateur de la Gazette royale, avant midi au moins 7 working days prior to Wednesday’s publication. 7 jours ouvrables avant le mercredi de publication. En However, when there is a public holiday, please contact cas de jour férié, veuillez communiquer avec le the coordinator. coordonnateur.

Orders in Council Décrets en conseil

DECEMBER 22, 2020 LE 22 DÉCEMBRE 2020 2020-271 2020-271 Under subsections 20.1(1) and 20.1(3) of the Workplace En vertu des paragraphes 20.1(1) et 20.1(3) de la Loi sur la Health, Safety and Compensation Commission and Workers’ Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des Compensation Appeals Tribunal Act, the Lieutenant-Governor accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au in Council reappoints the following individuals as Vice- travail, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme pour un Chairpersons of the Workers’ Compensation Appeals Tribunal, nouveau mandat les personnes suivantes à titre de vice- for a term of three years, effective December 22, 2020: présidentes du Tribunal d’appel des accidents au travail, pour un mandat de trois ans, à compter du 22 décembre 2020 : The Royal Gazette — January 20, 2021 46 Gazette royale — 20 janvier 2021

(a) Johanne Thériault, Bathurst, New Brunswick; and a) Johanne Thériault, de Bathurst (Nouveau-Brunswick); et (b) J. Nathalie Thibault, Quispamsis, New Brunswick. b) J. Nathalie Thibault, de Quispamsis (Nouveau- Brunswick).

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

______

DECEMBER 22, 2020 LE 22 DÉCEMBRE 2020 2020-272 2020-272 Under paragraph 9(3)(e) and subsection 11(2) of the En vertu de l’alinéa 9(3)e) et du paragraphe 11(2) de la New Brunswick Community Colleges Act, the Lieutenant- Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, le Governor in Council appoints Tammy Lynn MacNeill, Bains lieutenant-gouverneur en conseil nomme Tammy Lynn Corner, New Brunswick, as the Student Member of the Board MacNeill, de Bains Corner (Nouveau-Brunswick), membre du of Governors of the New Brunswick Community College, for a conseil des gouverneurs du Collège communautaire du term of two years, effective December 17, 2020 Nouveau-Brunswick à titre d’étudiante de la société que proposent ses étudiants, à compter du 17 décembre 2020, pour un mandat de deux ans.

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

______

DECEMBER 22, 2020 LE 22 DÉCEMBRE 2020 2020-273 2020-273 Under subsections 4(1), 4(2) and 4(4) of the Premier’s En vertu des paragraphes 4(1), 4(2) et 4(4) de la Loi créant le Council on Disabilities Act, the Lieutenant-Governor in Conseil du premier ministre pour les personnes handicapées, le Council reappoints Michèle Ouellette, Edmundston, New lieutenant-gouverneur en conseil nomme pour un nouveau Brunswick, as a member of the Premier’s Council on mandat Michèle Ouellette, d’Edmundston (Nouveau- Disabilities, for a term of two years, effective December 22, Brunswick), membre du Conseil du premier ministre pour les 2020. personnes handicapées, à compter du 22 décembre 2020, pour un mandat de deux ans. Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy ______

DECEMBER 22, 2020 2020-274 LE 22 DÉCEMBRE 2020 1. Under paragraph 2(1)(b) and subsection 3(3) of the 2020-274 Assessment and Planning Appeal Board Act, the Lieutenant- 1. En vertu de l’alinéa 2(1)b) et du paragraphe 3(3) de la Governor in Council appoints the following persons as Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et members of the Assessment and Planning Appeal Board, for a d’urbanisme, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les term of three years, effective December 22, 2020: personnes suivantes membres de la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme, pour un mandat de trois ans, à compter du 22 décembre 2020 : (a) Angela Breau Caissie, Cocagne, New Brunswick, from a) Angela Breau Caissie, de Cocagne (Nouveau- Region 2; and Brunswick), représentant la région 2; et (b) Eric Falkjar, Saint John, New Brunswick, from b) Eric Falkjar, de Saint John (Nouveau-Brunswick), Region 6. représentant la région 6.

2. Under subsections 3(3) and 9(1) of the Assessment and 2. En vertu des paragraphes 3(3) et 9(1) de la Loi sur la Planning Appeal Board Act, the Lieutenant-Governor in Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme, Council appoints L. Graeme MacKinnon, Hampton, New le lieutenant-gouverneur en conseil nomme L. Graeme Brunswick, as an alternate member of the Assessment and MacKinnon, de Hampton (Nouveau-Brunswick), membre Planning Appeal Board, from Region 7, for a term of three suppléant de la Commission d’appel en matière d’évaluation et years, effective December 22, 2020. d’urbanisme représentant la région 7, pour un mandat de trois ans, à compter du 22 décembre 2020. The Royal Gazette — January 20, 2021 47 Gazette royale — 20 janvier 2021

3. Under subsections 3(3) and 9(1) of the Assessment and 3. En vertu des paragraphes 3(3) et 9(1) de la Loi sur la Planning Appeal Board Act and section 26 of the Interpretation Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme et Act, the Lieutenant-Governor in Council revokes paragraph de l’article 26 de la Loi d’interprétation, le lieutenant- 2(a) of Order in Council 2020-183 dated August 12, 2020. gouverneur en conseil révoque l’alinéa 2a) du décret en conseil 2020-183 pris le 12 août 2020.

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

Elections Élections New Brunswick Nouveau-Brunswick

Pursuant to section 149 of the Elections Act, chapter E-3, Conformément à l’article 149 de la Loi électorale, chapitre Province of New Brunswick, the following changes to the E-3, province du Nouveau-Brunswick, les changements original registrations have been entered in the Registry of suivants aux enregistrements originaux ont été inscrits au st Political Parties between October 1 , 2020, and er December 31st, 2020: registre des partis politiques entre le 1 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 :

06 PROGRESSIVE CONSERVATIVE ASSOCIATION OF CARAQUET (District No. 06) / ASSOCIATION PROGRESSISTE-CONSERVATRICE DE CARAQUET (Circonscription no 06)

2nd Vice-President / 2e Vice-présidente Suzanne Morais-Vienneau 75 chemin St-Simon Road Caraquet, NB E1W 1B3

Secretary / Secrétaire Vacant

08 PROGRESSIVE CONSERVATIVE ASSOCIATION OF TRACADIE-SHEILA (District No. 08) / ASSOCIATION PROGRESSISTE-CONSERVATRICE DE TRACADIE-SHEILA (Circonscription no 08)

President / Présidente Gertrude McLaughlin PO Box/C.P. 20006 Centre-ville Tracadie, NB E1X 1G6

13 PROGRESSIVE CONSERVATIVE ASSOCIATION OF KENT SOUTH (District No. 13) / ASSOCIATION PROGRESSISTE-CONSERVATRICE DE KENT-SUD (Circonscription no 13)

Official Representative / Représentant officiel Donald Bastarache 151 chemin Alonzo Road Sainte-Marie de Kent, NB E4S 5L8

16 PROGRESSIVE CONSERVATIVE ASSOCIATION OF MEMRAMCOOK-TANTRAMAR (District No. 16) / ASSOCIATION PROGRESSISTE-CONSERVATRICE DE MEMRAMCOOK-TANTRAMAR (Circonscription no 16)

Official Representative / Représentante officielle Thelma Cormier 443 chemin Old Shediac Road Memramcook, NB E4K 1V6

21 PROGRESSIVE CONSERVATIVE ASSOCIATION OF MONCTON NORTHWEST (District No. 21) / ASSOCIATION PROGRESSISTE-CONSERVATRICE DE MONCTON-NORD-OUEST (Circonscription no 36)

Official Representative / Représentant officiel Troy Butler 187 croissant Ashley Crescent Moncton, NB E1G 1R5 The Royal Gazette — January 20, 2021 48 Gazette royale — 20 janvier 2021

34 PROGRESSIVE CONSERVATIVE ASSOCIATION OF KINGS CENTRE (District No. 34) / ASSOCIATION PROGRESSISTE-CONSERVATRICE DE KINGS-CENTRE (Circonscription no 34)

Official Representative / Représentant officiel Glen Baxter 1326 Route 845 Clifton Royal, NB E5S 2B9

42 PROGRESSIVE CONSERVATIVE ASSOCIATION OF FREDERICTON-YORK (District No. 42) / ASSOCIATION PROGRESSISTE-CONSERVATRICE DE FREDERICTON-YORK (Circonscription no 42)

President / Présidente Kelly Wilson 267 chemin McNamee Road McNamee, NB E9C 2G9

1st Vice-President / 1er Vice-président Travis O’Donnell 26 promenade Hazen Drive Killarney Road, NB E3A 1E2

Secretary / Secrétaire Jennifer Hanson 121 promenade Stirling Drive Killarney Road, NB E3A 9E9

45 PROGRESSIVE CONSERVATIVE ASSOCIATION OF CARLETON (District No. 45) / ASSOCIATION PROGRESSISTE-CONSERVATRICE DE CARLETON (Circonscription no 45)

President / Président Doug Graham 343 chemin Estey Road Waterville, NB E7P 1H8

1st Vice-President / 1er Vice-président Vacant

Treasurer / Trésorier Michael Wegner 96A chemin Gregg Settlerment Road Centreville, NB E7K 2N7

Official Representative / Représentant officiel Michael Wegner 96A chemin Gregg Settlerment Road Centreville, NB E7K 2N7

46 PROGRESSIVE CONSERVATIVE ASSOCIATION OF CARLETON-VICTORIA (District No. 46) / ASSOCIATION PROGRESSISTE-CONSERVATRICE DE CARLETON-VICTORIA (Circonscription no 46)

Treasurer / Trésorière Lottie Nye 3131 rue Main Street Centreville, NB E7K 2W7

Official Representative / Représentante officielle Lottie Nye 3131 rue Main Street Centreville, NB E7K 2W7

LIBERAL PARTY / PARTI LIBÉRAL

Interim Leader / Chef par intérim 384 ruelle Joseph Alley Dieppe, NB E1A 7B9 The Royal Gazette — January 20, 2021 49 Gazette royale — 20 janvier 2021

03 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF RESTIGOUCHE-CHALEUR (District No. 03) / ASSOCIATION DU PARTI LIBÉRAL DE RESTIGOUCHE-CHALEUR (Circonscription no 03)

Secretary / Secrétaire Martial McLaughlin 730 rue Mgr.-Lanteigne Street Petit-Rocher, NB E8J 1E7

Treasurer / Trésorier Martial McLaughlin 730 rue Mgr.-Lanteigne Street Petit-Rocher, NB E8J 1E7

Official Representative / Représentant officiel Martial McLaughlin 730 rue Mgr.-Lanteigne Street Petit-Rocher, NB E8J 1E7

13 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF KENT SOUTH (District No. 13) / ASSOCIATION DU PARTI LIBÉRAL DE KENT-SUD (Circonscription no 13)

President / Président Stephen Doucet 176 rue Acadie Street Bouctouche, NB E4S 2T5

1st Vice-President / 1er/re Vice-président(e) Vacant

2nd Vice-President / 2e Vice-président(e) Vacant

Secretary / Secrétaire Vacant

Treasurer/ Trésorière Léa Bastarache 210 chemin Saint-Lazare Farm Road Sainte-Marie-de-Kent, NB E4S 2K8

19 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF MONCTON CENTRE (District No. 19) / ASSOCIATION DU PARTI LIBÉRAL DE MONCTON-CENTRE (Circonscription no 19)

President / Présidente Cherrie Moreault 1216 Route Lavallée Memramcook, NB E4K 1E2

1st Vice-President / 1er/re Vice-président(e) Vacant

2nd Vice-President / 2e Vice-président(e) Vacant

Secretary / Secrétaire Vacant

Treasurer/ Trésorière Crystal Landry-Parlee 245 chemin Hennesey Road Moncton, NB E1A 5C7

21 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF MONCTON NORTHWEST (District No. 21) / ASSOCIATION DU PARTI LIBÉRAL DE MONCTON-NORD-OUEST (Circonscription no 21)

Official Representative / Représentant officiel Boyd Ross 210 promenade Evergreen Drive Moncton, NB E1G 2C1 The Royal Gazette — January 20, 2021 50 Gazette royale — 20 janvier 2021

23 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF RIVERVIEW (District No. 23) / ASSOCIATION DU PARTI LIBÉRAL DE RIVERVIEW (Circonscription no 23)

President / Président Heath Johnson 167 croissant Rosebank Crescent Riverview, NB E1B 0R5

1st Vice-President / 1er/re Vice-président(e) Vacant

2nd Vice-President / 2e Vice-président(e) Vacant

Secretary / Secrétaire Vacant

Treasurer/ Trésorière Heath Johnson 167 croissant Rosebank Crescent Riverview, NB E1B 0R5

Official Representative / Représentant officiel Heath Johnson 167 croissant Rosebank Crescent Riverview, NB E1B 0R5

27 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF HAMPTON (District No. 27) / ASSOCIATION DU PARTI LIBÉRAL DE HAMPTON (Circonscription no 27)

President / Président David Lutz 4 chemin Centennial Road Hampton, NB E5N 6N2

1st Vice-President / 1er/re Vice-président(e) Vacant

2nd Vice-President / 2e Vice-président(e) Vacant

Secretary / Secrétaire Vacant

Treasurer/ Trésorier David Lutz 4 chemin Centennial Road Hampton, NB E5N 6N2

30 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF SAINT JOHN EAST (District No. 30) / ASSOCIATION DU PARTI LIBÉRAL DE SAINT JOHN-EST (Circonscription no 30)

Official Representative / Représentant officiel Phil Comeau 37 rue Carthier Street Saint John, NB E2N 0C7

31 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF PORTLAND-SIMONDS (District No. 31) / ASSOCIATION DU PARTI LIBÉRAL DE PORTLAND-SIMONDS (Circonscription no 31)

President / Président Mike Butler 30 promenade Scenic View Drive Saint John, NB E2K 0G3

1st Vice-President / 1er/re Vice-président(e) Vacant

2nd Vice-President / 2e Vice-président(e) Vacant The Royal Gazette — January 20, 2021 51 Gazette royale — 20 janvier 2021

Secretary / Secrétaire Vacant

Treasurer/ Trésorière Dixie Coughlin 205-310 avenue Woodward Avenue Saint John, NB E2K 2L1

32 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF SAINT JOHN HARBOUR (District No. 32) / ASSOCIATION DU PARTI LIBÉRAL DE SAINT JOHN HARBOUR (Circonscription no 32)

President / Président Ralph Landers 60 avenue Crescent Avenue Saint John, NB E2J 3R6

1st Vice-President / 1er/re Vice-président(e) Vacant

2nd Vice-President / 2e Vice-président(e) Vacant

Secretary / Secrétaire Vacant

Treasurer/ Trésorier Mike Winchester 5 cour Veterans Court Saint John, NB E2K 4W4

33 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF SAINT JOHN LANCASTER (District No. 33) / ASSOCIATION DU PARTI LIBÉRAL DE SAINT JOHN LANCASTER (Circonscription no 33)

Official Representative / Représentante officielle Anne Hickey 73 promenade Downsview Drive Saint John, NB E2M 5E4

39 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF NEW MARYLAND-SUNBURY (District No. 39) / ASSOCIATION DU PARTI LIBÉRAL DE NEW MARYLAND-SUNBURY (Circonscription no 39)

President / Président Chris Pelkey 87 allée Springwater Lane New Maryland, NB E3C 1H8

1st Vice-President / 1er/re Vice-président(e) Vacant

2nd Vice-President / 2e Vice-président(e) Vacant

Secretary / Secrétaire Vacant

Treasurer/ Trésorier Chris Pelkey 87 allée Springwater Lane New Maryland, NB E3C 1H8

46 LIBERAL PARTY ASSOCIATION OF CARLETON-VICTORIA (District No. 46) / ASSOCIATION DU PARTI LIBÉRAL DE CARLETON-VICTORIA (Circonscription no 46)

President / Présidente Rochelle Pelletier 58 rue Terrace Street Perth-Andover, NB E7H 4Z1 The Royal Gazette — January 20, 2021 52 Gazette royale — 20 janvier 2021

1st Vice-President / 1er/re Vice-président(e) Vacant

2nd Vice-President / 2e Vice-président(e) Vacant

Secretary / Secrétaire Vacant

Treasurer/ Trésorière Rochelle Pelletier 58 rue Terrace Street Perth-Andover, NB E7H 4Z1

KISS N.B. POLITICAL PARTY / KISS N.B. POLITICAL PARTY

Registration cancelled / Enregistrement annulé

26 SUSSEX-FUNDY-ST. MARTINS PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 26) / ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DU PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DE SUSSEX-FUNDY-ST. MARTINS (Circonscription no 26)

Official Agent / Agente officielle Magen Handspiker 60 chemin Browns Cove Road Kars, NB E5T 2Z2

28 QUISPAMSIS PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 28) / ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DU PARTI VERT N. B. GREEN PARTY DE QUISPAMSIS (Circonscription no 28)

Official Agent / Agente officielle Magen Handspiker 60 chemin Browns Cove Road Kars, NB E5T 2Z2

30 PEOPLE’S ALLIANCE OF NEW BRUNSWICK SAINT JOHN EAST DISTRICT ASSOCIATION (District No. 30) / ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DE L’ALLIANCE DE GENS DU NOUVEAU-BRUNSWICK DE SAINT JOHN-EST (Circonscription no 30)

Official Agent / Agent officiel Brock Davidge 730 Route 616 Keswick Ridge, NB E6L 1T1

39 PEOPLE’S ALLIANCE OF NEW BRUNSWICK NEW MARYLAND-SUNBURY DISTRICT ASSOCIATION (District No. 39) / ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DE L’ALLIANCE DE GENS DU NOUVEAU- BRUNSWICK DE NEW MARYLAND-SUNBURY (Circonscription no 39)

President / Président Vacant

Vice-President / Vice-président Meryl Sarty 770-A Route 655 Waasis, NB E3B 8V3

Treasurer / Trésorière Terry Hayward 724 Route 655 Waasis, NB E3B 8V3 The Royal Gazette — January 20, 2021 53 Gazette royale — 20 janvier 2021

43 PEOPLE’S ALLIANCE OF NEW BRUNSWICK FREDERICTON WES T-HANWELL DISTRICT ASSOCIATION (District No. 43) / ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION DE L’ALLIANCE DE GENS DU NOUVEAU-BRUNSWICK DE FREDERICTON-OUEST-HANWELL (Circonscription no 43)

President / Président Mel Keeling 26 avenue Carl Avenue New Market, NB E6K 2W9

Vice-President / Vice-présidente Rebekka Vissers 14-190 promenade Parkside Drive Fredericton, NB E3B 5V9

Treasurer / Trésorière Susan Nason 408-787 rue Prospect Street Fredericton, NB E3B 9Y5

Official Representative / Représentant officiel Robert Nason 408-787 rue Prospect Street Fredericton, NB E3B 9Y5

Notices Avis

IN THE MATTER of the Law Society Act, 1996 DANS L’AFFAIRE de la Loi de 1996 sur le Barreau and et IN THE MATTER of the disbarment of HARVEY DANS L’AFFAIRE de la radiation de HARVEY URQUHART URQUHART

NOTICE OF DISBARMENT AVIS DE RADIATION

PLEASE NOTE that on August 28, 2020, a panel of the SACHEZ que le 28 août 2020, un sous-comité de discipline du Discipline Committee of the Law Society ordered, with his Barreau a ordonné, avec son consentement, que Harvey consent, that Harvey Urquhart of Miramichi be disbarred Urquhart de Miramichi soit radié du Barreau, à compter du from the Law Society pursuant to paragraph 60(1)(d) of the Law 28 août 2020, en application de l’alinéa 60(1)d) de la Loi de Society Act, 1996 effective August 28, 2020. The panel found 1996 sur le Barreau. Le sous-comité a statué que Harvey that Harvey Urquhart was guilty of committing acts of fraud, Urquhart a commis des fraudes, a trompé ses clients et ses misleading his clients and colleagues, failing to cooperate with collègues, a omis de coopérer à l’investigation menée par le the investigation of the Law Society into complaints filed Barreau concernant des plaintes déposées contre lui, et a omis against him, and failing to comply with, among others, Rules de se conformer, entre autres, aux Règles 2.1-1 (Intégrité), 3.1- 2.1-1 (Integrity), 3.1-2 (Competence), 3.2-1 (Quality of 2 (Compétence), 3.2-1 (Qualité du service), 3.2-2 (Honnêteté et Service), 3.2-2 (Honesty and Candour), 5.6-1 (Encouraging franchise), 5.6-1 (Encourager le respect envers l’administration Respect for the Administration of Justice), 7.2-11 de la justice), 7.2-11 (Engagements et stipulations fiduciaires) (Undertakings and Trust Conditions, and 7.1-1 et 7.1-1 (Communications émanant du Barreau) du Code de (Communications from the Society) of the Law Society of New déontologie professionnelle du Barreau du Nouveau- Brunswick Code of Professional Conduct; Rules 2(1) and Brunswick; aux Règles 2(1) et 4(2)a), b) et c) des Règles 4(2)(a), (b) and (c) of the Uniform Trust Account Rules; and uniformes sur les comptes en fiducie; et à l’article 7 des Règles section 7 of the Rules on Cash Transactions. sur les opérations en liquide.

Joleen J. Dable Joleen J. Dable Registrar of Complaints Registraire des plaintes The Royal Gazette — January 20, 2021 54 Gazette royale — 20 janvier 2021

Department of Environment Ministère de l’Environnement and Local Government et des Gouvernements locaux

NOTICE UNDER THE AVIS CONFORMÉMENT À LA COMMUNITY PLANNING ACT LOI SUR L’URBANISME PUBLIC NOTICE IS HEREBY GIVEN that, under the AVIS PUBLIC EST DONNÉ, PAR LES PRÉSENTES, Community Planning Act, subsection 52(14), Ministerial conformément au paragraphe 52(14) de la Loi sur l’urbanisme, Regulation for the Amending of the Nashwaak Valley Planning le Règlement Ministériel pour le secteur d’aménagement de la Area Rural Plan Regulation under the Community Planning Act, vallée Nashwaak établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme, soit being Ministerial Regulation 19-NAV-009-03 a regulation to le Règlement ministériel 19-NAV-009-03, un règlement pour add definitions to and amend the Regulation in order to permit ajouter des définitions et modifier le plan rural afin de permettre cannabis production, was enacted by the Minister of Local la production de cannabis, a été adopté par le ministre des Government and Local Governance Reform on December 3rd, Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance 2020 and filed in the Registry office on December 14th, 2020 local le 3 décembre 2020 et a été déposé au bureau under official number 40792203. d’enregistrement le 14 décembre 2020 sous le numéro 40792203.

______

NOTICE UNDER THE AVIS CONFORMÉMENT À LA COMMUNITY PLANNING ACT LOI SUR L’URBANISME PUBLIC NOTICE IS HEREBY GIVEN that, under the AVIS PUBLIC EST DONNÉ, PAR LES PRÉSENTES, Community Planning Act, subsection 52(14), Ministerial conformément au paragraphe 52(14) de la Loi sur l’urbanisme, Regulation for the Amending of the Nashwaak Valley Planning le Règlement ministériel amendant le Règlement ministériel Area Rural Plan Regulation under the Community Planning Act, pour le Secteur d’aménagement de la vallée Nashwaak établi en being Ministerial Regulation 19-NAV-009-04 a regulation to vertu de la Loi sur l’urbanisme, soit le Règlement ministériel rezone the property with PID 75532960, from the Rural Zone to 19-NAV-009-04, visant à rezoner la propriété avec le NID the Industrial Zone was enacted by the Minister of Local 75532960 de la zone rurale à la zone industrielle, a été adopté Government and Local Governance Reform on par le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de December 3rd,2020 and filed in the Registry office on la gouvernance local le 3 décembre 2020 et a été déposé au December 14th, 2020 under official number 40794738. bureau d’enregistrement le 14 décembre 2020 sous le numéro 40794738.

Department of Ministère de la Public Safety Sécurité publique

SALE OF MOTOR VEHICLES VENTE DE VÉHICULES À MOTEUR Take notice that the Registrar of Motor Vehicles, Province of Sachez que le registraire des véhicules à moteur de la province New Brunswick will be disposing of the following vehicles on du Nouveau-Brunswick mettra en vente les véhicules à moteur or after January 6, 2021. suivants le 6 Janvier 2021.

2000 Suzuki TL 1000R Suzuki TL 1000R 2000 Serial No.JS1VT52ASYZ100681 numéro de série JS1VT52ASYZ100681 License Plate: YSR15 Numéro d’immatriculation : YSR15 Registered Owner: Ryan Alyre Wallace Propriétaire immatriculé : Ryan Alyre Wallace Vehicle located at Kitchen’s Towing. out of Upper Kingsclear, Véhicule se trouvant actuellement chez Kitchen’s Towing, NB Upper Kingsclear (N-B)

2012 Honda Civic Honda Civic 2012 Serial No 2GHFB2F52CB000313 numéro de série 2GHFB2F52CB000313 License Plate: NA Numéro d’immatriculation : S.O. Registered Owner: Nicole Leanne Hamm Propriétaire immatriculé : Nicole Leanne Hamm Vehicle located at Kitchen’s Towing. out of Upper Kingsclear, Véhicule se trouvant actuellement chez Kitchen’s Towing, NB Upper Kingsclear (N-B) The Royal Gazette — January 20, 2021 55 Gazette royale — 20 janvier 2021

2008 Honda Accord Honda Accord 2008 Serial No. 1HGCS12768S802745 numéro de série 1HGCS12768S802745 License Plate: NA Numéro d’immatriculation : S.O. Registered Owner: Andrew Brian McCloskey Propriétaire immatriculé : Andrew Brian McCloskey Vehicle located at Kitchen’s Towing. out of Upper Kingsclear, Véhicule se trouvant actuellement chez Kitchen’s Towing, NB Upper Kingsclear (N-B)

2005 Mazda B Series Mazda B Series 2005 Serial No.4F4ZR47E85PM04806 numéro de série 4F4ZR47E85PM04806 License Plate: CRG578 Numéro d’immatriculation : CRG578 Registered Owner: Karen Ann Polchies Propriétaire immatriculé : Karen Ann Polchies Vehicle located at Kitchen’s Towing. out of Upper Kingsclear, Véhicule se trouvant actuellement chez Kitchen’s Towing, NB Upper Kingsclear (N-B)

2000 Dodge Ram Dodge Ram 2000 Serial No.1B7HF13Y0YJ181518 numéro de série 1B7HF13Y0YJ181518 License Plate: NA Numéro d’immatriculation : S.O. Registered Owner: Jason William Thomson Propriétaire immatriculé : Jason William Thomson Vehicle located at Kitchen’s Towing. out of Upper Kingsclear, Véhicule se trouvant actuellement chez Kitchen’s Towing, NB Upper Kingsclear (N-B)

2003 Ford Expedition Ford Expedition 2003 Serial No.1FMFU18L73LA35586 numéro de série 1FMFU18L73LA35586 License Plate: NEY679 Numéro d’immatriculation : NEY679 Registered Owner: Iain Paul Whyte Propriétaire immatriculé : Iain Paul Whyte Vehicle located at Kitchen’s Towing. out of Upper Kingsclear, Véhicule se trouvant actuellement chez Kitchen’s Towing, NB Upper Kingsclear (N-B)

______

SALE OF MOTOR VEHICLES VENTE DE VÉHICULES À MOTEUR Take notice that the Registrar of Motor Vehicles, Province of Sachez que le registraire des véhicules à moteur de la province New Brunswick will be disposing of the following vehicles on du Nouveau-Brunswick mettra en vente les véhicules à moteur or after January 6, 2021. suivants le 6 Janvier 2021.

2006 GMC Canyon GMC Canyon 2006 Serial No. 1GTCS196568279380 numéro de série 1GTCS196568279380 License Plate: NA Numéro d’immatriculation : S.O. Registered Owner: Stanley William Dunphy Propriétaire immatriculé : Stanley William Dunphy Vehicle located at Loyalist City Towing (2012) Ltd. out of Saint Véhicule se trouvant actuellement chez Loyalist Towing (2012) John, NB Ltd., Saint John (N-B)

2013 Dodge Journey Dodge Journey 2013 Serial No 3C4PDCAB8DT721924 numéro de série 3C4PDCAB8DT721924 License Plate: JFO129 Numéro d’immatriculation : JFO129 Registered Owner: Richard Ernest Rogers Propriétaire immatriculé : Richard Ernest Rogers Vehicle located at Loyalist City Towing (2012) Ltd. out of Saint Véhicule se trouvant actuellement chez Loyalist Towing (2012) John, NB Ltd., Saint John (N-B)

2005 Toyota Corolla Toyota Corolla 2005 Serial No. 2T1BR32E75C842646 numéro de série 2T1BR32E75C842646 License Plate: GUJ246 Numéro d’immatriculation : GUJ246 Registered Owner: Joshua Paul Knox Propriétaire immatriculé : Joshua Paul Knox Vehicle located at Loyalist City Towing (2012) Ltd. out of Saint Véhicule se trouvant actuellement chez Loyalist Towing (2012) John, NB Ltd., Saint John (N-B) The Royal Gazette — January 20, 2021 56 Gazette royale — 20 janvier 2021

2005 Toyota Echo Toyota Echo 2005 Serial No. JTDBT123250387848 numéro de série JTDBT123250387848 License Plate: NA Numéro d’immatriculation : S.O. Registered Owner: Michael Anthony Trites Propriétaire immatriculé : Michael Anthony Trites Vehicle located at Loyalist City Towing (2012) Ltd. out of Saint Véhicule se trouvant actuellement chez Loyalist Towing (2012) John, NB Ltd., Saint John (N-B)

2004 Honda Accord Honda Accord 2004 Serial No. 1HGCM56654A801826 numéro de série 1HGCM56654A801826 License Plate: JRG753 Numéro d’immatriculation : JRG753 Registered Owner: Derrick Joseph Rolfe Propriétaire immatriculé : Derrick Joseph Rolfe Vehicle located at Loyalist City Towing (2012) Ltd. out of Saint Véhicule se trouvant actuellement chez Loyalist Towing (2012) John, NB Ltd., Saint John (N-B)

2004 Oldsmobile Alero Oldsmobile Alero 2004 Serial No. 1G3NL52E74C221022 numéro de série 1G3NL52E74C221022 License Plate: NA Numéro d’immatriculation : S.O. Registered Owner: Timothy Richard Gogan Propriétaire immatriculé : Timothy Richard Gogan Vehicle located at Loyalist City Towing (2012) Ltd. out of Saint Véhicule se trouvant actuellement chez Loyalist Towing (2012) John, NB Ltd., Saint John (N-B)

______

SALE OF MOTOR VEHICLES VENTE DE VÉHICULES À MOTEUR Take notice that the Registrar of Motor Vehicles, Province of Sachez que le registraire des véhicules à moteur de la province New Brunswick will be disposing of the following vehicles on du Nouveau-Brunswick mettra en vente les véhicules à moteur or after January 6, 2021. suivants le 6 Janvier 2021.

2000 GMC Sonoma GMC Sonoma 2000 Serial No. 1GTDT19W4Y8283991 numéro de série 1GTDT19W4Y8283991 License Plate: CJB828 Numéro d’immatriculation : CJB828 Registered Owner: Michael Edward Peacock Propriétaire immatriculé : Michael Edward Peacock Véhicule Vehicle located at Loyalist City Towing (2012) Ltd. out of Saint se trouvant actuellement chez Loyalist Towing (2012) Ltd., John, NB Saint John (N-B)

2006 Dodge Caravan Dodge Caravan 2006 Serial No 1D4GP24R16B669697 numéro de série 1D4GP24R16B669697 License Plate: GOI181 Numéro d’immatriculation : GOI181 Registered Owner: Jeannette Doucet Propriétaire immatriculé : Jeannette Doucet Vehicle located at Loyalist City Towing (2012) Ltd. out of Saint Véhicule se trouvant actuellement chez Loyalist Towing (2012) John, NB Ltd., Saint John (N-B)

2006 Kia Spectra Kia Spectra 2006 Serial No. KNAFE121965329103 numéro de série KNAFE121965329103 License Plate: NA Numéro d’immatriculation : S.O. Registered Owner: Gilbert Russell Janes Propriétaire immatriculé : Gilbert Russell Janes Vehicle located at Loyalist City Towing (2012) Ltd. out of Saint Véhicule se trouvant actuellement chez Loyalist Towing (2012) John, NB Ltd., Saint John (N-B)

2006 Chevrolet Malibu Chevrolet Malibu 2006 Serial No. 1G1ZT51816F271275 numéro de série 1G1ZT51816F271275 License Plate: GOW791 Numéro d’immatriculation : GOW791 Registered Owner: Mary Dale Breau Propriétaire immatriculé : Mary Dale Breau Vehicle located at Loyalist City Towing (2012) Ltd. out of Saint Véhicule se trouvant actuellement chez Loyalist Towing (2012) John, NB Ltd., Saint John (N-B) The Royal Gazette — January 20, 2021 57 Gazette royale — 20 janvier 2021

2006 Toyota Matrix Matrix Toyota 2006 Serial No. 2T1KR32E76C582668 numéro de série 2T1KR32E76C582668 License Plate: GNC729 Numéro d’immatriculation : GNC729 Registered Owner: Dennis Francis Dobbin Propriétaire immatriculé : Dennis Francis Dobbin Vehicle located at Loyalist City Towing (2012) Ltd. out of Saint Véhicule se trouvant actuellement chez Loyalist Towing (2012) John, NB Ltd., Saint John (N-B)

2004 Chevrolet Impala Chevrolet Impala 2004 Serial No. 2G1WF52E149441977 numéro de série 2G1WF52E149441977 License Plate: GKO804 Numéro d’immatriculation : GKO804 Registered Owner: Fillmore Stewart Allan Propriétaire immatriculé : Fillmore Stewart Allan Vehicle located at Loyalist City Towing (2012) Ltd. out of Saint Véhicule se trouvant actuellement chez Loyalist Towing (2012) John, NB Ltd., Saint John (N-B)

______

SALE OF MOTOR VEHICLES VENTE DE VÉHICULES À MOTEUR Take notice that the Registrar of Motor Vehicles, Province of Sachez que le registraire des véhicules à moteur de la province New Brunswick will be disposing of the following vehicles on du Nouveau-Brunswick mettra en vente les véhicules à moteur or after January 6, 2021. suivants le 6 Janvier 2021.

2009 Ford Focus Ford Focus 2009 Serial No. 1FAHP36N29W193092 numéro de série 1FAHP36N29W193092 License Plate: GWD562 Numéro d’immatriculation : GWD562 Registered Owner: Derek Watson McVicar Propriétaire immatriculé : Derek Watson McVicar Vehicle located at Loyalist City Towing (2012) Ltd. out of Saint Véhicule se trouvant actuellement chez Loyalist Towing (2012) John, NB Ltd., Saint John (N-B)

2000 Honda Civic Honda Civic 2000 Serial No 1HGEJ617XYL812645 numéro de série 1HGEJ617XYL812645 License Plate: JDS061 Numéro d’immatriculation : JDS061 Registered Owner: Michael James McNulty Propriétaire immatriculé : Michael James McNulty Vehicle located at Loyalist City Towing (2012) Ltd. out of Saint Véhicule se trouvant actuellement chez Loyalist Towing (2012) John, NB Ltd., Saint John (N-B)

2004 Jeep Liberty Jeep Liberty 2004 Serial No. 1J4GL48K24W280892 numéro de série 1J4GL48K24W280892 License Plate: JKE853 Numéro d’immatriculation : JKE853 Registered Owner: Lacey Leanne Williams Propriétaire immatriculé : Lacey Leanne Williams Vehicle located at Loyalist City Towing (2012) Ltd. out of Saint Véhicule se trouvant actuellement chez Loyalist Towing (2012) John, NB Ltd., Saint John (N-B)

2007 Dodge Charger Dodge Charger 2007 Serial No. 2B3KA43G47H841543 numéro de série 2B3KA43G47H841543 License Plate: NBR840 Numéro d’immatriculation : NBR840 Registered Owner: Brandon Evans Kelly Propriétaire immatriculé : Brandon Evans Kelly Vehicle located at Loyalist City Towing (2012) Ltd. out of Saint Véhicule se trouvant actuellement chez Loyalist Towing (2012) John, NB Ltd., Saint John (N-B)

2007 Ford Fusion Ford Fusion 2007 Serial No. 3FAHP07197R182729 numéro de série 3FAHP07197R182729 License Plate: NA Numéro d’immatriculation : S.O. Registered Owner: Cindy Andrea Stillman Propriétaire immatriculé : Cindy Andrea Stillman Vehicle located at Loyalist City Towing (2012) Ltd. out of Saint Véhicule se trouvant actuellement chez Loyalist Towing (2012) John, NB Ltd., Saint John (N-B) The Royal Gazette — January 20, 2021 58 Gazette royale — 20 janvier 2021

2008 Kia Rondo Kia Rondo 2008 Serial No. KNAFG525787165569 numéro de série KNAFG525787165569 License Plate: JSI766 Numéro d’immatriculation : JSI766 Registered Owner: Mark Douglas Gillespie Propriétaire immatriculé : Mark Douglas Gillespie Vehicle located at Loyalist City Towing (2012) Ltd. out of Saint Véhicule se trouvant actuellement chez Loyalist Towing (2012) John, NB Ltd., Saint John (N-B)

______

SALE OF MOTOR VEHICLES VENTE DE VÉHICULES À MOTEUR Take notice that the Registrar of Motor Vehicles, Province of Sachez que le registraire des véhicules à moteur de la province New Brunswick will be disposing of the following vehicles on du Nouveau-Brunswick mettra en vente les véhicules à moteur or after January 6, 2021. suivants le 6 Janvier 2021.

2006 Ford Focus Ford Focus 2006 Serial No. 1FAFP34N46W193214 numéro de série 1FAFP34N46W193214 License Plate: JPZ161 Numéro d’immatriculation : JPZ161 Registered Owner: Brenda Marie Murphy Propriétaire immatriculé : Brenda Marie Murphy Vehicle located at Loyalist City Towing (2012) Ltd. out of Saint Véhicule se trouvant actuellement chez Loyalist Towing (2012) John, NB Ltd., Saint John (N-B)

2002 Subaru Legacy Subaru Legacy 2002 Serial No 4S3BE635427215203 numéro de série 4S3BE635427215203 License Plate: JCJ118 Numéro d’immatriculation : JCJ118 Registered Owner: Louis Andre Nantel Propriétaire immatriculé : Louis Andre Nantel Vehicle located at Loyalist City Towing (2012) Ltd. out of Saint Véhicule se trouvant actuellement chez Loyalist Towing (2012) John, NB Ltd., Saint John (N-B)

2003 Honda Civic Honda Civic 2003 Serial No. 1HGEM226X3L010272 numéro de série 1HGEM226X3L010272 License Plate: GTN658 Numéro d’immatriculation : GTN658 Registered Owner: Brian Sterling Pare Propriétaire immatriculé : Brian Sterling Pare Vehicle located at Loyalist City Towing (2012) Ltd. out of Saint Véhicule se trouvant actuellement chez Loyalist Towing (2012) John, NB Ltd., Saint John (N-B)

2007 GMC Canyon GMC Canyon 2007 Serial No. 1GTDT13E378128962 numéro de série 1GTDT13E378128962 License Plate: NA Numéro d’immatriculation : S.O. Registered Owner: Joshua Willem Bent Propriétaire immatriculé : Joshua Willem Bent Vehicle located at Loyalist City Towing (2012) Ltd. out of Saint Véhicule se trouvant actuellement chez Loyalist Towing (2012) John, NB Ltd., Saint John (N-B)

2005 Buick Allure Buick Allure 2005 Serial No. 2G4WF532651344703 numéro de série 2G4WF532651344703 License Plate: GPG279 Numéro d’immatriculation : GPG279 Registered Owner: Heather Lynn Thompson Propriétaire immatriculé : Heather Lynn Thompson Vehicle located at Loyalist City Towing (2012) Ltd. out of Saint Véhicule se trouvant actuellement chez Loyalist Towing (2012) John, NB Ltd., Saint John (N-B)

2006 Pontiac G6 Pontiac G6 2006 Serial No. 1G2ZG558264280010 numéro de série 1G2ZG558264280010 License Plate: NA Numéro d’immatriculation : S.O. Registered Owner: Anthony Raymond Debly Propriétaire immatriculé : Anthony Raymond Debly Vehicle located at Loyalist City Towing (2012) Ltd. out of Saint Véhicule se trouvant actuellement chez Loyalist Towing (2012) John, NB Ltd., Saint John (N-B)

______The Royal Gazette — January 20, 2021 59 Gazette royale — 20 janvier 2021

SALE OF MOTOR VEHICLES VENTE DE VÉHICULES À MOTEUR Take notice that the Registrar of Motor Vehicles, Province of Sachez que le registraire des véhicules à moteur de la province New Brunswick will be disposing of the following vehicles on du Nouveau-Brunswick mettra en vente les véhicules à moteur or after January 6, 2021. suivants le 6 Janvier 2021.

2005 Chevrolet Cobalt Chevrolet Cobalt 2005 Serial No. 1G1AJ52FX57536297 numéro de série 1G1AJ52FX57536297 License Plate: GRV029 Numéro d'immatriculation : GRV029 Registered Owner: Renald Levesque Propriétaire immatriculé : Renald Levesque Vehicle located at Loyalist City Towing (2012) Ltd. out of Saint Véhicule se trouvant actuellement chez Loyalist Towing (2012) John, NB Ltd., Saint John (N-B)

2008 Chevrolet HHR Chevrolet HHR 2008 Serial No 3GNDA13D08S572846 numéro de série 3GNDA13D08S572846 License Plate: GTF344 Numéro d'immatriculation : GTF344 Registered Owner: Sean William Ryan Propriétaire immatriculé : Sean William Ryan Vehicle located at Loyalist City Towing (2012) Ltd. out of Saint Véhicule se trouvant actuellement chez Loyalist Towing (2012) John, NB Ltd., Saint John (N-B)

2010 Mazda 6 Mazda 6 2010 Serial No. 1YVHZ8BA6A5M00303 numéro de série 1YVHZ8BA6A5M00303 License Plate: GZI609 Numéro d'immatriculation : GZI609 Registered Owner: Allan David Degruchy Propriétaire immatriculé : Allan David Degruchy Vehicle located at Loyalist City Towing (2012) Ltd. out of Saint Véhicule se trouvant actuellement chez Loyalist Towing (2012) John, NB Ltd., Saint John (N-B)

2001 Dodge Durango Dodge Durango 2001 Serial No. 1B4HS28N61F620954 numéro de série 1B4HS28N61F620954 License Plate: NA Numéro d'immatriculation : S.O. Registered Owner: Wayne Scott Roberts Propriétaire immatriculé : Wayne Scott Roberts Vehicle located at Loyalist City Towing (2012) Ltd. out of Saint Véhicule se trouvant actuellement chez Loyalist Towing (2012) John, NB Ltd., Saint John (N-B)

2008 Ford Edge Ford Edge 2008 Serial No. 2FMDK48C08BA63736 numéro de série 2FMDK48C08BA63736 License Plate: JUO326 Numéro d'immatriculation : JUO326 Registered Owner: Thomas Andrew Dallon Propriétaire immatriculé : Thomas Andrew Dallon Vehicle located at Loyalist City Towing (2012) Ltd. out of Saint Véhicule se trouvant actuellement chez Loyalist Towing (2012) John, NB Ltd., Saint John (N-B)

1998 Pontiac Sunfire Pontiac Sunfire 1998 Serial No. 1G2JD12T3W7574103 numéro de série 1G2JD12T3W7574103 License Plate: NA Numéro d'immatriculation : S.O. Registered Owner: Carrie M Dosch Propriétaire immatriculé : Carrie M Dosch Vehicle located at Loyalist City Towing (2012) Ltd. out of Saint Véhicule se trouvant actuellement chez Loyalist Towing (2012) John, NB Ltd., Saint John (N-B)

Notice to Advertisers Avis aux annonceurs

The Royal Gazette is published every Wednesday under the La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformément authority of the Official Notices Publication Act. Documents à la Loi sur la publication des avis officiels. Les documents à must be sent to The Royal Gazette coordinator in Microsoft publier doivent être soumis au coordonnateur de la Gazette Word format, no later than noon, at least seven working days royale en format Microsoft Word, avant midi, au moins sept prior to Wednesday’s publication. Each document must be jours ouvrables avant le mercredi de publication. Chaque avis separate from the covering letter. Signatures on documents must doit être séparé de la lettre d’envoi. Les noms des signataires be immediately followed by the printed name. The Royal doivent suivre immédiatement la signature. Le coordonnateur Gazette coordinator may refuse to publish a document if any de la Gazette royale peut refuser de publier un avis dont une The Royal Gazette — January 20, 2021 60 Gazette royale — 20 janvier 2021 part of it is illegible, and may delay publication of any partie est illisible et retarder la publication d’un avis pour des document for administrative reasons. raisons administratives. Prepayment is required for the publication of all documents. Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis. Standard documents have the following set fees: Voici les tarifs pour les avis courants :

Notices Fee Avis Droit

Notice of the intention to apply for the enactment of a $ 20 Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loi 20 $ private bill d’intérêt privé Originating process $ 25 Acte introductif d’instance 25 $ Order of a court $ 25 Ordonnance rendue par une cour 25 $ Notice under the General Rules under the Law Society Act, $ 20 Avis de radiation ou de suspension ou de demande de 20 $ 1996, of disbarment or suspension or of application for réintégration ou de réadmission, que prévoient les Règles reinstatement or readmission générales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur le Barreau Notice of examination under the Licensed Practical Nurses $ 25 Avis d’examen qu’exige la Loi sur les infirmières et infirmiers 25 $ Act auxiliaires autorisés Notice under the Motor Carrier Act $ 30 Avis qu’exige la Loi sur les transports routiers 30 $ Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9 $ 20 Avis aux créanciers prévu par le Règlement du Nouveau- 20 $ under the Probate Court Act Brunswick 84-9 pris en vertu de la Loi sur la Cour des successions Notice under Rule 70 of the Rules of Court $120 Avis qu’exige la Règle 70 des Règles de procédure 120 $ Note: Survey Maps cannot exceed 8.5 x 14 Nota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 po sur 14 po Notice of sale of property under an Act, if the notice is 1/2 page $ 20 Avis de vente d’un bien que prévoit une loi, si l’avis mesure 20 $ or less une demi-page ou moins Notice of sale of property under an Act, if the notice is greater $ 75 Avis de vente d’un bien que prévoit une loi, si l’avis est de 75 $ than 1/2 page plus une demi-page Any document under the Winding-up and Restructuring Act $ 20 Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur les 20 $ () liquidations et les restructurations (Canada) Notice of a correction fee is Avis de correction les droits sont the same as les mêmes que for publishing ceux exigés the original pour la document publication du document original

Any other document $3.50 for each Tout autre document 3,50 $ pour ch- cm (rounded aque cm up to the (arrondi au cm nearest cm) supérieur)

Payments can be made by cheque or money order (payable to Les paiements peuvent être faits par chèque ou mandat (à the Minister of Finance). No refunds will be issued for l’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement ne cancellations. sera effectué en cas d’annulation.

The official version of The Royal Gazette is available free La version officielle de la Gazette royale est disponible Online each Wednesday. gratuitement en ligne chaque mercredi.

The Royal Gazette Gazette royale Brookside Place Place Brookside 435 Brookside Drive, Suite 30 435, promenade Brookside, bureau 30 P.O. Box 6000 C.P. 6000 Fredericton, NB E3B 5H1 Fredericton (N.-B.) E3B 5H1

Tel: 506-453-3864 Tél. : 506-453-3864 Email: [email protected] Courriel : [email protected]

Note: Deliveries are to be addressed to The Royal Gazette and Note : Toute livraison étant adressée à la Gazette royale doit left at the reception. être remise à la réception. Government of New Brunswick © Le gouvernement du Nouveau-Brunswick All rights reserved / Tous droits réservés