The Royal Gazette Gazette royale

Fredericton Fredericton Nouveau-Brunswick

ISSN 1714-9428

Vol. 178 Wednesday, February 5, 2020 / Le mercredi 5 février 2020 129

Important Notice Avis important

As of January 1st, 2020, we have moved À partir du 1er janvier 2020, nous avons déménagé to Service New Brunswick à Services Nouveau-Brunswick

See Notice to Advertisers Veuillez consulter l’avis aux annonceurs for our new address. pour notre nouvelle adresse.

______

Effective January 1, 2020, the Minister of Service New Bruns- À compter du 1er janvier 2020, le ministre de Services wick will be the Minister responsible for the administration of Nouveau-Brunswick sera le ministre responsable de l’adminis- the Official Notices Publication Act, including The Royal tration de la Loi sur la publication des avis officiels, y compris Gazette. la Gazette royale.

The Royal Gazette e-mail will remain the same: L’adresse courriel de la Gazette royale demeure la même : [email protected] [email protected]

______The Royal Gazette — February 5, 2020 130 Gazette royale — 5 février 2020

Notice to Readers Avis aux lecteurs

The Royal Gazette is officially published on-line. La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne. Except for formatting, documents are published in The Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans Royal Gazette as submitted. la Gazette royale comme soumis. Material submitted for publication must be received by Les documents à publier doivent parvenir à le coordonna- the Royal Gazette coordinator no later than noon, at least teur de la Gazette royale, à midi, au moins 7 jours ou- 7 working days prior to Wednesday’s publication. vrables avant le mercredi de publication. En cas de jour However, when there is a public holiday, please contact férié, veuillez communiquer avec le coordonnateur. the coordinator.

Proclamations Proclamations

PROCLAMATION PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2019-247, I declare that the Coop- Conformément au décret en conseil 2019-247, je déclare le eratives Act, Chapter 24 of the Acts of New Brunswick, 2019, 1er janvier 2020 date d’entrée en vigueur de la Loi sur les coo- comes into force on January 1, 2020. pératives, chapitre 24 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2019.

This Proclamation is given under La présente proclamation est faite my hand and the Great Seal of the sous mon seing et sous le grand Province at Fredericton on sceau de la province, à Fredericton, December 12, 2019. le 12 décembre 2019.

Andrea Anderson-Mason, Q.C. Brenda L. Murphy La procureure générale, La lieutenante-gouverneure, Attorney General Lieutenant-Governor Andrea Anderson-Mason, c.r. Brenda L. Murphy

Legislative Assembly Assemblée législative

NOTICE OF LEGISLATION AVIS DE PROJET DE LOI NOTICE IS HEREBY GIVEN that a Bill respecting the SACHEZ PAR LES PRÉSENTES qu’un Projet de Loi relatif à removal of certain restrictive covenants on title to certain lands l’extinction de certains covenants restrictifs du titre de certains in the City of Saint John vested in Plazacorp Property Holdings biens-fonds dans la Ville de Saint John dévolus à Plazacorp Inc. will be presented to the current session of the Legislative Property Holdings Inc. sera présenté à la session en cours de Assembly of the Province of New Brunswick. l’Assemblée législative de la province du Nouveau-Brunswick. The purpose of the Bill is to remove certain restrictive Le but du Projet Loi est d’éteindre et retirer certains covenants covenants on title to certain lands in the City of Saint John restrictifs du titre de certains biens-fonds dans la Ville de Saint vested in Plazacorp Property Holdings Inc. and more John dévolus à Plazacorp Property Holdings Inc. et situés plus particularly located at the corner of Millidge Avenue and particulièrement à l’intersection de l’avenue Millidge et de University Avenue in the said City of Saint John. l’avenue University dans ladite Ville de Saint John.

DATED this 24th day of January, 2020. FAIT CE 24e jour de janvier 2020.

James D. Murphy, Stewart McKelvey, James D. Murphy, Stewart McKelvey, Solicitors for the Applicant, avocats du Requérant, 44 Chipman Hill, 10th Floor, 44 Chipman Hill, 10e étage, P.O. Box 20105, Brunswick Square, C.P. 20105, Brunswick Square, Saint John, New Brunswick, E2L 5B2. Saint John, Nouveau-Brunswick, E2L 5B2. The Royal Gazette — February 5, 2020 131 Gazette royale — 5 février 2020

Elections Élections New Brunswick Nouveau-Brunswick

SUPERVISOR OF POLITICAL FINANCING CONTRÔLEUR DU FINANCEMENT POLITIQUE In accordance with section 36 of the Political Process Financ- Selon l’article 36 de la Loi sur le financement de l’activité poli- ing Act, the annual allowance paid to each of the registered po- tique, l’allocation annuelle versée à chaque parti politique enre- litical parties for the fiscal year 2018-2019 was as follows: gistré pendant l’année financière 2018-2019 étaient comme suit :

 New Brunswick Liberal Association $274,699  Association libérale du Nouveau-Brunswick 274 699 $  Progressive Conservative  Parti progressiste-conservateur du Party of New Brunswick $223,592 Nouveau-Brunswick 223 592 $  New Brunswick New Democratic  Nouveau Parti démocratique du Party $83,687 Nouveau-Brunswick 83 687 $  Parti Vert N.B. Green Party $42,802  Parti Vert N.B. Green Party 42 802 $  People’s Alliance of New Brunswick $14,054  Alliance des gens du Nouveau-Brunswick 14 054 $  KISS N. B. Political Party $0  KISS N. B. Political Party 0 $

Total $638,834 Total 638 834 $

In accordance with section 32.01 of the Political Process Fi- Selon l’article 32.01 de la Loi sur le financement de l’activité nancing Act, the annual allowance that is payable to each of the politique, l’allocation annuelle payable à chaque parti politique registered political parties for the fiscal year 2019-2020 is as enregistré pendant l’année financière 2019-2020 est comme follows: suit :

 New Brunswick Liberal Association $241,731  Association libérale du Nouveau-Brunswick 241 731 $  Progressive Conservative  Parti progressiste-conservateur du Party of New Brunswick $198,011 Nouveau-Brunswick 198 011 $  New Brunswick New Democratic  Nouveau Parti démocratique du Party $34,216 Nouveau-Brunswick 34 216 $  Parti Vert N.B. Green Party $81,105  Parti Vert N.B. Green Party 81 105 $  People’s Alliance of New Brunswick $78,571  Alliance des gens du Nouveau-Brunswick 78 571 $

Total $633,634 Total 633 634 $

DATED at Fredericton this 24th day of January 2020. FAIT à Fredericton le 24 janvier 2020.

Kimberly Poffenroth, Supervisor of Political Financing Kimberly Poffenroth, contrôleur du financement politique

______The Royal Gazette — February 5, 2020 132 Gazette royale — 5 février 2020

Pursuant to subsection 9(4) of the Elections Act, chapter E-3, Province Conformément au paragraphe 9(4) de la Loi électorale, chapitre E-3, of New Brunswick, the following is a list of the names, addresses and province du Nouveau-Brunswick, ce qui suit est une liste des noms, occupations of the returning officers for every electoral district in the adresses et professions des directeurs et directrices du scrutin de Province: chaque circonscription électorale de la province :

Electoral District Name Address Occupation Circonscription électorale Nom Adresse Profession

01 Jeannot Roy 74 ch Mgr-Martin Ouest Rd Sugar Bush Employee / RESTIGOUCHE-OUEST Saint-Quentin, NB E8A 2B3 / Employé d’érablière 02 CAMPBELLTON-DALHOUSIE Mel Parker 49 rue George St Retired / Retraité / CAMPBELLTON-DALHOUSIE Campbellton, NB E3N 3A4 03 RESTIGOUCHE-CHALEUR Gérald Mallais 115 rue Madisco Ouest St Retired / Retraité / RESTIGOUCHE-CHALEUR Petit-Rocher, NB E8J 1T9 04 BATHURST WEST-BERESFORD Mark Guindon 540 av Murray Ave Instructor -Geology, Prospecting / / BATHURST-OUEST-BERESFORD Bathurst, NB E2A 1T7 Instructeur – géologie, prospection 05 BATHURST EAST-NEPISIGUIT-SAINT-ISIDORE / Micheline Hachey 12 Suzan Dr Retired / Retraitée BATHURST-EST-NEPISIGUIT-SAINT-ISIDORE North Tetagouche NB E2A 4Y9 06 CARAQUET / CARAQUET Augustina Lanteigne 41 boul St-Pierre Est Blvd Administrative Assistant Caraquet, NB E1W 1B6 / Adjointe administrative 07 SHIPPAGAN-LAMÈQUE-MISCOU Delcia Cool 9 rue l’Assomption St Retired / Retraitée / SHIPPAGAN-LAMÈQUE-MISCOU Le Goulet, NB E8S 2B9 08 TRACADIE-SHEILA / TRACADIE-SHEILA Donald Wade 4153 rue Principale St Retired / Retraité Tracadie-Sheila, NB E1X 1B9 09 MIRAMICHI BAY-NEGUAC Cyril Donahue 2210 King George Hwy Retired / Retraité / BAIE-DE-MIRAMICHI-NEGUAC Miramichi, NB E1V 5T3 10 MIRAMICHI / MIRAMICHI William (Bill) 165 Treadwell Lane Retired / Retraité Treadwell Miramichi, NB E1V 2G2 11 SOUTHWEST MIRAMICHI-BAY DU VIN Krista Price Lambert 20 rue Meadow St N Instructor, Mad Science / MIRAMICHI-SUD-OUEST-BAIE-DU-VIN Doaktown, NB E9C 1S8 / Instructrice, Sciences en folie 12 KENT NORTH / KENT-NORD Michel Vautour 1619 ch Desherbiers Rd Retired / Retraité Saint-Ignace, NB E4X 2B5 13 KENT SOUTH / KENT-SUD Raoul Leger 28 rue Yvon St Retired / Retraité Saint-Antoine, NB E4V 1L1 14 SHEDIAC BAY-DIEPPE Bernice Williams 4352 Route 115 Office Manager / Gérante de bureau / BAIE-DE-SHEDIAC-DIEPPE Saint-Antoine-Sud, NB E4V 2Z7 15 SHEDIAC-BEAUBASSIN-CAP-PELÉ Leo Doiron 109 rue Brown St Legal Document Server / SHEDIAC-BEAUBASSIN-CAP-PELÉ Shediac, NB E4P 1J6 / Serveur de préavis juridiques 16 MEMRAMCOOK-TANTRAMAR William Hicks 8 allée Penny Retired / Retraité / MEMRAMCOOK-TANTRAMAR Memramcook, NB E4K 2K8 17 DIEPPE / DIEPPE O’Neil Arseneau 254 rue Jean-Darois St Retired / Retraité Dieppe, NB E1A 6G9 18 MONCTON EAST / MONCTON-EST George Duff 75 rue Pleasant St Retired / Retraité Moncton, NB E1A 2T8 19 MONCTON CENTRE / MONCTON-CENTRE Leo Belliveau 114 rue Churchill St Retired / Retraité Moncton, NB E1C 7J4 20 MONCTON SOUTH / MONCTON-SUD Armand LeBlanc 125 ch Lewisville Rd Retired / Retraité Moncton, NB E1B 4X8 21 MONCTON NORTHWEST William Justason 53 Briardale Dr Retired / Retraité / MONCTON NORD-OUEST Moncton, NB E1G 2B7 23 RIVERVIEW / RIVERVIEW Dean Johnston 201-197 av Buckingham Ave Retired / Retraité Riverview, NB E1B 4X8 24 ALBERT / ALBERT Cheri Smith 1050 Route 114 Management Consultant Lower Coverdale, NB E1J 1A2 / Conseillère en gestion The Royal Gazette — February 5, 2020 133 Gazette royale — 5 février 2020

25 GAGETOWN-PETITCODIAC Krista Hall 4654 Route 105 Nursing Home Relief Worker / GAGETOWN-PETITCODIAC Jemseg, NB E4C 3K4 / Travail de relève de foyer de soins 26 SUSSEX-FUNDY-ST. MARTINS Brenda Graham 184 av Pleasant Ave Retired / Retraitée / SUSSEX-FUNDY-ST. MARTINS Sussex, NB E4E 1Y2 27 HAMPTON / HAMPTON Sandra Thorne 57 Highland Dr Retired / Retraitée Hampton, NB E5N 5C6 28 QUISPAMSIS / QUISPAMSIS Joanne Nice 137 ch Neck Rd Retired / Retraitée Quispamsis, NB E2G 1K9 29 ROTHESAY / ROTHESAY Victorine Robichaud 30 av Highland Ave Substitute Teacher Rothesay, NB E2E 5N3 / Enseignante suppléante 30 SAINT JOHN EAST / SAINT JOHN-EST Kathryn Dalling 10 ch Spring Garden Rd Retired / Retraitée Saint John, NB E2N 1K3 31 PORTLAND-SIMONDS / HAMPTON Richard Thorne 57 Highland Dr Retired / Retraité Hampton, NB E5N 5C6 32 SAINT JOHN HARBOUR Carl Killen 22 Vale Crest Dr Retired / Retraité / SAINT JOHN HARBOUR Saint John, NB E2M 4B7 33 SAINT JOHN LANCASTER Arthur Sisk 7212 Tippett Dr Trainer, Rescue Guide, Landscaper / SAINT JOHN LANCASTER Saint John, NB E2M 4Y3 / Formateur, guide de sauvetage, paysagiste 34 KINGS CENTRE / KINGS-CENTRE Melodie Bourque- 6 tsse Myles Terr Retired / Retraitée Melanson Grand Bay-Westfield, NB E5K 0C3 35 FUNDY-THE ISLES-SAINT JOHN WEST Nancy Coulton 6 rue Prince William St Retired / Retraitée / FUNDY-LES-ÎLES-SAINT JOHN-OUEST St. George, NB E5C 3L8 36 SAINT CROIX / SAINTE-CROIX James Carr 62 rue Montague St Retired / Retraité St. Andrews, NB E5B 1H2 37 OROMOCTO-LINCOLN-FREDERICTON Patrick Lynch 711 Waterloo Row Business Manager / OROMOCTO-LINCOLN-FREDERICTON Fredericton, NB E3B 1Z6 / Gérant d’entreprise 38 FREDERICTON-GRAND LAKE Alison Gallagher 542 Route 690 Retired / Retraitée / FREDERICTON-GRAND LAKE Lakeville Corner, NB E4B 1M9 39 NEW MARYLAND-SUNBURY Eveline Harrison 2 cour Pluto Crt Retired / Retraitée / NEW MARYLAND-SUNBURY Hanwell, NB E3C 2M8 40 FREDERICTON SOUTH Kay Simonds 307-215 rue Queen St Retired / Retraitée / FREDERICTON-SUD Fredericton, NB E3B 0Y2 41 FREDERICTON NORTH Kathleen MacDonald 110 rue Melvin St Retired / Retraitée / FREDERICTON-NORD Fredericton, NB E3A 2N2 42 FREDERICTON-YORK Deanna Hawkins-Scott 161 ch Kingsley Rd Adjudication Coordinator / / FREDERICTON-YORK Estey’s Bridge, NB E3G 6B9 Coordinateur d’arbitrage 43 FREDERICTON WEST-HANWELL Gerard Beaulieu 91 Archangel Way Retired / Retraité / FREDERICTON-OUEST-HANWELL Keswick Ridge, NB E6L 0A3 44 CARLETON-YORK / CARLETON-YORK Nancy Sutherland 418 ch Charlie Little Rd Retired / Retraitée Harvey, York Co., NB E6K 1N4 45 CARLETON / CARLETON Eleanor Leonard 148 rue Chapel St Retired / Retraitée Woodstock, NB E7M 1H4 46 CARLETON-VICTORIA Vernon Thomas 2 rue Burtt St Special Projects Coordinator / / CARLETON-VICTORIA Centreville, NB E7K 3E3 Coordonnateur de projets spéciaux 47 VICTORIA-LA VALLÉE Brigitte Cyr Page 625 ch Montagne A. Comeau Rd Substitute Teacher / Enseignante / VICTORIA-LA-VALLÉE Saint-André, NB E3Y 3E8 suppléante 48 EDMUNDSTON-MADAWASKA CENTRE Joanne Plourde 445 ch du Pouvoir Rd Retired / Retraitée / EDMUNDSTON-MADAWASKA-CENTRE Edmundston, NB E3V 4K1 49 MADAWASKA LES LACS-EDMUNDSTON Jean Guy Marquis 957 rue St-François St Retired / Retraité / MADAWASKA-LES-LACS-EDMUNDSTON Verret, NB E3V 4P7 The Royal Gazette — February 5, 2020 134 Gazette royale — 5 février 2020

Loi sur les corporations Business Corporations Act commerciales PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commer- tions Act, a certificate of incorporation has been issued to: ciales, un certificat de constitution en corporation a été émis à : Reference Number Date Registered Office Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

CER Auto Finance Inc. Fredericton 714088 2019 12 23 GOODLIFE ROOFING LIMITED Saint John 714325 2020 01 07 Griffin Plumbing Inc. Saint Andrews 714340 2020 01 07 A1Z Associates Inc. Fredericton 714347 2020 01 08 Katie Friars Realty Inc. Moncton 714358 2020 01 08 714362 N.B. LTD. Smiths Creek 714362 2020 01 08 Editions Dragonum Inc. Canton des Basques 714364 2020 01 08 East Coast Innovation Inc. Saintt Andrews 714367 2020 01 09 714372 N.B. Ltd. Smiths Creek 714372 2020 01 09 K & K RICHARDSON HOLDINGS LTD. Quispamsis 714373 2020 01 09 Raven Speech & Language Therapy Inc. Burton 714378 2020 01 09 714379 NB Ltd. Saint John 714379 2020 01 09 WF TRUCKING LTD. Cap-Pelé 714380 2020 01 09 DR. IVRAYM BARSOUM Medical Professional Corporation Fredericton 714382 2020 01 09 Tyra’s Dairy Ltd. Miramichi 714383 2020 01 09 714384 N.B. Ltd. Miramichi 714384 2020 01 09 714390 NB INC. Petit-Rocher-Nord 714390 2020 01 10 D&L PROPERTY MANAGEMENT LTD. Fredericton 714395 2020 01 10 714397 N.B. INC. Moncton 714397 2020 01 10 MCR Building Supplies Ltd. Dieppe 714403 2020 01 10

714404 NB INC. Saint John 714404 2020 01 10 714405 N.B. Ltd. Moncton 714405 2020 01 10 714406 NB LTD. Perth-Andover 714406 2020 01 10 Gospa Enterprises Inc. Saint John 714409 2020 01 10 L’ÉRABLIÈRE L’EAU DORÉE INC. Saint-Basile 714410 2020 01 10 714411 N.B. INC. Saint John 714411 2020 01 10 714412 NB Inc. Saint John 714412 2020 01 11 714413 NB LTD. Saint John 714413 2020 01 12 714414 NB Inc. Rothesay 714414 2020 01 12 714418 N.B. Inc. Saint John 714418 2020 01 13 Infobahn Softworld Corp. Fredericton 714419 2020 01 13 The Royal Gazette — February 5, 2020 135 Gazette royale — 5 février 2020

JEFF LIBERTY’S MUSIC TO GO INC. Kingston 714427 2020 01 13 714429 N.B. Inc. Hanwell 714429 2020 01 13 RCT Superior Contracting Services Inc. Beersville 714430 2020 01 13 Maiz & Mixta Taqueria Inc. Moncton 714435 2020 01 13 Royal Women Social Club Inc. Saint John 714438 2020 01 14 Blessing Christian Book Store Inc. Moncton 714441 2020 01 14 Sin Sheng Trading Inc. Moncton 714445 2020 01 14 AVL Holdings Inc. Drummond 714447 2020 01 14 Empire Ink Corp. Bathurst 714453 2020 01 14 714454 NB Inc. Riverview 714454 2020 01 14 714460 N.-B. INC. Balmoral 714460 2020 01 14 714462 NB INC. Lamèque 714462 2020 01 14 714471 N.-B. INC. Balmoral 714471 2020 01 15 714477 NB CORP. Scoudouc 714477 2020 01 15 Fundy Capital Inspections Ltd. Saint John 714479 2020 01 15 Dr. Shokri Al Masri Professional Corporation Saint John 714480 2020 01 15 ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpo- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, rations Act, a certificate of continuance has been issued to: un certificat de prorogation a été émis à : Previous Reference Jurisdiction Number Date Registered Office Compétence Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Bureau enregistré antérieure référence année mois jour

Yardstick Assessment Strategies Inc. Saint John 714424 2020 01 10 ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of amendment has been issued to: un certificat de modification a été émis à :

Date Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

D. & L. MOTORS INC. 039307 2020 01 13 THE RADICAL EDGE LTD. 052460 2020 01 08 ATLANTIC INJURY LAW GROUP INC. 515561 2020 01 09 631087 N.B. Ltd. 631087 2020 01 13 AVL Construction Group Inc 669811 2020 01 14 GUIMOND MARINE FINISHERS INC. 684118 2020 01 10 700159 N.B. Limited 700159 2020 01 10 700160 N.B. Limited 700160 2020 01 14 The Royal Gazette — February 5, 2020 136 Gazette royale — 5 février 2020

703880 N.B. LTD. 703880 2020 01 08 705552 N.B. INC. 705552 2020 01 14 The Healthiest Alternative N.B. Inc 705608 2020 01 09 Primetria Software Inc. 713733 2020 01 15 Team91 Holdings Inc. 714210 2020 01 15 Dr. Kazi Shahnaz Parveen Professional Corporation 714258 2020 01 10 ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of amendment which includes a change in un certificat de modification contenant un changement de raison name has been issued to: sociale a été émis à :

Date Previous name Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Ancienne raison sociale Numéro de référence année mois jour

054113 NB Ltd. ATV COUNTRY WHEELERS LTD. 054113 2019 12 23 057331 N.B. LTD. CLASSIC HEATING & AIR CONDITIONING 057331 2020 01 14 SERVICES LTD. 512267 NB Inc. Danielle Jones Flower Shop Inc. 512267 2020 01 15 AVL Realty Inc. Gérald C. Morin Construction Inc. 514316 2020 01 14 ACADIAN FOSSES SEPTIQUES INC. TOITURES GLOUCESTER INC. 689322 2020 01 14 GRAMko Properties Inc. 699156 N.B. Inc. 699156 2020 01 09 Orgfields Valley Inc. GREENLUSH SOLUTIONS INC. 702560 2020 01 09 Ordinary Trucking Ltd. Coldwater Canadian Transportation LTD. 710625 2020 01 09 Atlantic Auto Parts Resource Inc. 711790 NB INC. 711790 2020 01 10 Cirrus9 Inc. 712276 N.B. Ltd. 714184 2020 01 01 ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of amalgamation has been issued to: un certificat de fusion a été émis à : Reference Number Date Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Registered Office Numéro de Year Month Day Corporation issue de la fusion Corporations fusionnantes Bureau enregistré référence année mois jour

MACRAE ENVIRONMENTAL SERVICES MACRAE ENVIRONMENTAL Harvey 714176 2019 12 31 INC. SERVICES INC Comté de York 688897 NB Inc. County East Coast Sheet Metal Ltd. CHIEN CHIC INC. Memramcook 714401 2020 01 01 EAST COAST SHEET METAL LTD.

Services Financiers Goguen 686386 NB Inc. Dieppe 714421 2020 01 13 Champlain Financial Services Inc. 686388 NB Inc. Services Financiers Goguen Champlain Financial Services Inc. The Royal Gazette — February 5, 2020 137 Gazette royale — 5 février 2020

PUI Exchangeco Inc. PUI Exchangeco Inc. Saint John 714425 2020 01 10 713833 N.B. Inc. 713834 N.B. Inc. Yardstick Assessment Strategies Inc. ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of dissolution has been issued to: un certificat de dissolution a été émis à : Reference Number Date Registered Office Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

HERVCO CONSTRUCTION LTD. Moncton 007985 2020 01 08 NORTHERN GROUP LIMITED Tide Head 012360 2020 01 10 Bretech Inspection (NDT) Ltd. Saint John 034159 2019 12 27 GREEN SHORES ESTATES INC. Dieppe 059666 2020 01 13 JENNINGS POULTRY FARMS LTD. Bathurst 696943 2020 01 10 ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, notice of the discharge of a receiver or a receiver- un avis de libération d’un séquestre ou séquestre-gérant pour les manager of the following corporations has been received: sociétés suivantes a été reçu : Receiver or Reference Receiver-Manager Number Date Registered Office Séquestre ou Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Bureau enregistré séquestre-gérant référence année mois jour

RICHIBUCTO FURNITURE 2012 LTD. / Richibucto Powell Associates Ltd. 667263 2020 01 14 MEUBLES Saint John RICHIBUCTO 2012 LTÉE. ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of discontinuance has been issued to: un certificat de cessation a été émis à :

Date Jurisdiction of Continuance Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Compétence de prorogation Numéro de référence année mois jour

KLEINWORT BENSON INTERNATIONAL Guernesey / Guernsey 054262 2019 12 31 TRUSTEES LIMITED PALMER ATLANTIC RISK SERVICES LTD. Canada 509292 2019 12 27 K.B. Clarke Holdco N.B. Ltd. Nouvelle-Écosse / Nova Scotia 619791 2019 12 31 INTEC BILLING (HOLDING) CANADA Colombie-Britannique / 620948 2019 12 13 LIMITED British Columbia

INTEC BILLING CANADA LIMITED Colombie-Britannique / 621300 2019 12 13 British Columbia IMERYS MICA SUZORITE INC. Canada 634010 2019 12 20 Palmer Atlantic Insurance Ltd. Canada 642190 2019 12 27 The Royal Gazette — February 5, 2020 138 Gazette royale — 5 février 2020

Perten Instruments Inc. Ontario 676949 2019 12 30 Auction Owls Inc. Île-du-Prince-Édouard / 694696 2019 12 04 Prince Edward Island Luxottica of Canada Inc. Canada 700034 2019 12 31 ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of revival has been issued to: un certificat de reconstitution a été émis à :

Date Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

FANJOY’S TRANSPORT LTD. 006105 2019 12 31 502687 N.B. Inc. 502687 2019 12 23 AVENUE EVALUATIONS LTD. 504886 2020 01 14 MILLIGAN”S CYCLE WORKS INC. 513948 2020 01 08 ATLANTIC INJURY LAW GROUP INC. 515561 2020 01 08 McCue Wreaths Inc. 623206 2019 12 30 626038 NB Inc. 626038 2020 01 09 TMC of Canada, Inc. 647087 2019 12 23 CMS Consulting Inc. 648135 2020 01 13 Short Fuse Fireworks Inc. 657548 2020 01 13 Calder Bros. Ltd. 663657 2020 01 14 672514 N.B. Inc. 672514 2020 01 09 CloudNcode Inc. 673200 2020 01 14 Atlantic Roll Forming Inc. 674067 2019 12 23 678105 N.B. Inc. 678105 2019 12 31 Savarin Holdings Limited 680102 2020 01 07 P. N. B. SEAFOOD INC. 681776 2020 01 15

682982 N.B. INC. 682982 2019 12 30 BRYENTON FLOORING LTD. 687340 2020 01 13 695570 NB Inc. 695570 2019 12 31 Developmental Dynamics Human Services Inc 696082 2020 01 14 ______The Royal Gazette — February 5, 2020 139 Gazette royale — 5 février 2020

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of registration of extra-provincial corporation un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a été has been issued to: émis à : Reference Number Date Jurisdiction Agent and Address Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Compétence Représentant et adresse référence année mois jour

UNITED TOTE CANADA INC. Canada Deborah M. Power 714136 2019 12 23 Fredericton

MYCOR INSURANCE SOLUTIONS Ontario Stewart McKelvey Corporate 714265 2020 01 02 INC. /SOLUTIONS D”ASSURANCE Services (NB) Inc. MYCOR INC. Saint John

HAULOTTE CANADA INC. Colombie-Britannique / Stewart McKelvey Corporate 714285 2020 01 03 British Columbia Services (NB) Inc. Saint John Canusa Ventures Inc. Canada Michael J. Vandenberg 714307 2020 01 06 Moncton ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of registration of amalgamated corporation un certificat d’enregistrement d’une corporation extraprovinciale has been issued to the following extra-provincial corporations: issue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales sui- vantes : Reference Agent and Address Number Date Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Représentant et Numéro de Year Month Day Corporation issue de la fusion Corporations fusionnantes adresse référence année mois jour

MEDTRONIC CANADA ULC MEDTRONIC CANADA ULC Stewart McKelvey Corporate 714286 2020 01 03 COVIDIEN CANADA ULC Services (NB) Inc. Saint John

STANDARD AERO LIMITED STANDARD AERO LIMITED McInnes Cooper CSD 714370 2020 01 08 STANDAERO LIMITEE STANDAERO LIMITÉE Services Inc. Fredericton

Companies Act Loi sur les compagnies PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act, SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres letters patent have been granted to: patentes ont été émises à : Reference Number Date Head Office Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Siège social référence année mois jour

Harvey Regional Heritage and Historical Association Inc. Harvey 714087 2019 12 23 Comté deYork County Festival d’Automne de Kedgwick Inc. Kedgwick 714097 2019 12 23 ATV COUNTRY WHEELERS INC. Shediac 714126 2019 12 23 Atlantic Equity and Research Alliance Inc. Miramichi 714139 2019 12 23 Youth Ambitions Wellness Centre Inc. Moncton 714175 2019 12 30 Association des familles Daigle acadiennes Inc. Richibucto 714274 2020 01 02 The Royal Gazette — February 5, 2020 140 Gazette royale — 5 février 2020

Miramichi Whitecaps Inc. Miramichi 714360 2020 01 08 ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act, SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres supplementary letters patent have been granted to: patentes supplémentaires ont été émises à :

Date Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

Fundy Trail Development Authority Inc. 605726 2019 12 23 ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that the charter of the following SACHEZ que la charte de la compagnie suivante est reconstituée company is revived under subsection 35.1(1) of the Companies Act: en vertu du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les compagnies :

Date Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

MAIN STREET REDEVELOPMENT SACKVILLE INC. 023747 2019 12 31 TANTRAMAR ATV CLUB INC. 669249 2019 12 23

Loi sur l’enregistrement des Partnerships and Business Names sociétés en nom collectif et des Registration Act appellations commerciales PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en Business Names Registration Act, a certificate of business name has nom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appel- been registered: lation commerciale a été enregistré : Registrant of Address of Business Reference Certificate or Agent Number Date Enregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

Cyngot Educational Services Sara Cyngot Hampton 713919 2019 12 16 LA PTITE FRITURE ENRG. Wilbert Joseph Smith Miscou 714077 2019 12 23 Conscious Counselling and Wellness Sara Mackie Fredericton 714301 2020 01 06 SPARKLE NAILS SAINT JOHN Thi Hoang Phuong Cao Saint John 714309 2020 01 06 Medimar Clinic Diana Ramos Professional Corp. Woodstock 714326 2020 01 07 Enchanted Creations Trudy Whittaker Lincoln 714359 2020 01 08 Lifelong Foot Care Lindsey Erin Kelly Upper Kingsclear 714361 2020 01 08 Tom & Jo Transport Amilton Marques Ribeiro Moncton 714363 2020 01 08 A.D.O. Savoie Réno Lyne Savoie Kedgwick 714365 2020 01 08 The Royal Gazette — February 5, 2020 141 Gazette royale — 5 février 2020

Ordinary Trucking Company Coldwater Canadian Fredericton 714366 2020 01 08 Transportation LTD. Stowaway Storage The Marconato Group Ltd. Sussex 714368 2020 01 08 BIG BITE SNACKS Othman Chikhou Fredericton 714369 2020 01 08

WP Welding & Fabrication Wesley Pelletier Première nation malécite de 714371 2020 01 09 Madawaska / Madawaska Maliseet First Nation MIRAMICHI BAIT & TACKLE Mike Godin Miramichi 714374 2020 01 09 FIRST CITY BREW PUB LIQUOR DOME INC. Saint John 714377 2020 01 09 SKY-TEC SATELLITE SKYCO INC. Miramichi 714385 2020 01 09 Bryn Enterprises Brenda Nott Burton 714388 2020 01 10 West River Camping 714372 N.B. Ltd. Smiths Creek 714389 2020 01 10 Fundy Stargazer Glamping Jasvir Shukla Hopewell Cape 714391 2020 01 10 Home James Renos James Brittain Rothesay 714393 2020 01 10 A4DM Assistant for Digital Marketing Olena Chudnovets Dieppe 714394 2020 01 10 Willow Lea Boutique Lauren Trevots Miramichi 714396 2020 01 10 Adconic Tech Systems Wayne Normand Landry Caraquet 714398 2020 01 10 J.R. Welding & Fabricating Jody Rector Salisbury 714399 2020 01 10 Auto Recon 360 665332 NB Inc. Moncton 714407 2020 01 10 Kwey Beauty Paige Polches Fredericton 714408 2020 01 10

KWEY CUISINE Amy Pelletier Première nation malécite de 714415 2020 01 13 Madawaska / Madawaska Maliseet First Nation Honest to Goodness Bath and Body Wendy Mazerall Durham Bridge 714416 2020 01 13 HABITAT CONFORT PAR RH 9206-4880 QUÉBEC INC. Saint John 714417 2020 01 13 Carryon Custom Travel Amy Mayhew St. Stephen 714426 2020 01 13 Lincoln Inn AAA INN MOTEL INC. Fredericton 714434 2020 01 13 River Valley Renovations Corey Smith Lower Greenwich 714437 2020 01 14

Cambridge-Narrows Campground 613846 NB INC. Cambridge-Narrows 714439 2020 01 14 Sainte-Marie Harmonii Soins Marie Christine Marquis Sainte-Marie-de-Kent 714442 2020 01 14 Énergétique - Energy Healing 101 Electrical Drake Harris Tracyville 714446 2020 01 14 Riverborn Recordings Taylor Sheasgreen Miramichi 714452 2020 01 14 Garderie Rose des vents Linda Losier Sainte-Rose 714464 2020 01 14 TheFaceShop Avon Canada Inc. Saint John 714465 2020 01 15 Nature Collection Avon Canada Inc. Saint John 714467 2020 01 15 Fruits & Passion Avon Canada Inc. Saint John 714468 2020 01 15 Avon Canada Avon Canada Inc. Saint John 714470 2020 01 15 Sin Sheng Trading Sin Sheng Trading Inc. Moncton 714473 2020 01 15 ______The Royal Gazette — February 5, 2020 142 Gazette royale — 5 février 2020

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en Business Names Registration Act, a certificate of renewal of business nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re- name has been registered: nouvellement d’appellation commerciale a été enregistré : Registrant of Address of Business Reference Certificate or Agent Number Date Enregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

WAYMORE ENTERPRISES Wayne L. Cudmore Shediac 342894 2020 01 09 DEPOT CONTINU ACADIE VIE ACADIA LIFE Caraquet 347905 2020 01 13 PAYCHEQUE PROTECT ACADIE VIE ACADIA LIFE Caraquet 347907 2020 01 13 SECURIPAYE ACADIE VIE ACADIA LIFE Caraquet 347908 2020 01 13 SECURIPAIE ACADIE VIE ACADIA LIFE Caraquet 348448 2020 01 13 TELUS Financial Services TELUS COMMUNICATIONS Saint John 603851 2020 01 10 INC. MARIA’S HOUSE OF CRAFT AND Maria Landry Dalhousie 604368 2020 01 06 ALTERATIONS UNIQUE INTERIORS Lucie Robichaud Lower Coverdale 616557 2020 01 10 STEVENS CLEANING SERVICES Kevin Brent Stevens Moncton 616848 2020 01 06 SCM Insurance Services SCM INSURANCE SERVICES Saint John 641150 2020 01 15 INC. Jean-Louis Albert Bulldozing Jean-Louis Albert Saint-Léonard-Parent 641251 2020 01 03 Select Building and Lot Brent Reed Fredericton 641329 2020 01 03 Maintenance Claude Carrier Towing & Auto Centre Claude Carrier Belledune 642247 2020 01 14 ALife AVie Inc. Caraquet 642390 2020 01 10 T & P Enterprises Todd L Prosser Pine Glen 642431 2020 01 09 Invasion Group IT Solutions Mr. Dave Robichaud Memramcook 648034 2020 01 10 Hawk - Marketing Services 629856 N.B. Ltd. Moncton 648392 2020 01 10 Clinique Robichaud-Lévesque Clinic ATLAS-AXIS INC. Moncton 648696 2020 01 09 GROUPE OSTIGUY & GENDRON / COURTIERS D’ASSURANCES Saint John 648838 2020 01 09 OSTIGUI & GENDRON GROUP OSTIGUY & GENDRON INC. KLOOSTERBOER BAYSIDE WOODSTOCK COLD STORAGE Bayside 650173 2020 01 10 (1990) LTD. TKD Autobody Thomas F Crawford St Almo 678970 2020 01 06

Barckhill Lake Club Robert Bourgeois Galloway 679026 2019 11 27 Lucille LeBlanc Denise Surette Susan Jonah - Deliveries Susan Jonah Yoho 679151 2020 01 08 MAISON JC 678560 NB INC. Balmoral 679327 2020 01 09 Maritime Medical Massage Clinic Joshua Lutes Moncton 679462 2020 01 08 Martell Home Builders MARTELL DEVELOPMENT Moncton 679822 2020 01 15 GROUP INC. Martell Properties Pierre Martell Holdings Moncton 679823 2020 01 15 Inc. The Royal Gazette — February 5, 2020 143 Gazette royale — 5 février 2020

LES CHALETS DE LA PÉNINSULE Marc Cormier Shippagan 679838 2020 01 14 ACADIENNE Grandma Nan’s Wash Mason Ingersoll Grand Manan 679869 2020 01 14 Blue River Massage Therapy Julie Doiron Boiestown 679922 2020 01 15 Ferme Banville Ferme Bancourt Ltée Saint-Quentin 679981 2020 01 08 Forgeron Régis Haché Régis Haché Losier Settlement 680033 2020 01 10 Signature Pre-Owned Auto Gallery 045502 N. B. LTD. Saint John 680065 2020 01 13 Lemieux Ménard & Co. G. Lemieux & A. Ménard P.C. Inc. Saint-Antoine 680265 2020 01 09 PORT FREDERICTON 042675 N.B. INC. Lower St. Marys 680290 2020 01 14 FREDERICTON MARINA 042675 N.B. INC. Lower St. Marys 680291 2020 01 14 IDEA2PLAN Rhea Bowen Saint John 680385 2020 01 08 BBCG Claims Services ClaimsPro LP Saint John 680495 2020 01 14 ClaimsPro ClaimsPro LP Saint John 680496 2020 01 14 Pario Pario Engineering & Saint John 680498 2020 01 14 Environmental Sciences LP Xpera Xpera Risk Mitigation & Saint John 680504 2020 01 14 Investigation LP SCM SCM INSURANCE SERVICES Saint John 680512 2020 01 15 INC. ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en Business Names Registration Act, a certificate of cessation of busi- nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessa- ness or use of business name has been registered: tion de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation com- merciale a été enregistré : Reference Number Date Address / Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Adresse référence année mois jour

Stowaway Storage Springfield 620474 2020 01 08 Festival d’Automne de Kedgwick Kedgwick 706490 2019 12 23

Funke Hair Braiding Moncton 706805 2020 01 13 Maiz & Mixta Taqueria Moncton 708433 2020 01 14 ______The Royal Gazette — February 5, 2020 144 Gazette royale — 5 février 2020

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en Business Names Registration Act, a certificate of partnership has nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de so- been registered: ciété en nom collectif a été enregistré : Address of Business Reference or Agent Number Date Adresse du commerce Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Partners / Membres ou du représentant référence année mois jour

Nicholson & Beaumont CPA LLP Gregory Mercer Fredericton 714299 2020 01 06 Professional Corporation Jeffrey Beaumont Professional Corporation (2012) Ltd. ENL Properties Eric Norman Landry Dieppe 714466 2020 01 15 Louis Gibbs ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en Business Names Registration Act, a certificate of renewal of part- nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re- nership has been registered: nouvellement de société en nom collectif a été enregistré : Address of Business or Agent Reference Adresse du Number Date commerce ou Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Partners / Membres du représentant référence année mois jour

BEALEE BRACELET & COMPANY Line Marie Lutwick Woodstock 678953 2020 01 08 Peter Raymond Lutwick ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en Business Names Registration Act, a certificate of dissolution of part- nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de disso- nership has been registered: lution de société en nom collectif a été enregistré : Reference Number Date Address / Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Adresse référence année mois jour

SPARKLE NAILS SAINT JOHN Saint John 704053 2020 01 06

Limited Partnership Act Loi sur les sociétés en commandite

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une ship Act, a declaration of limited partnership has been filed by: déclaration de société en commandite a été déposée par : Principal place in Reference New Brunswick Number Date General Partners Principal établissement au Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Commandités Nouveau-Brunswick référence année mois jour

Tensor Capital LP Tensor Capital Ltd. Saint John 714234 2019 12 31 Derbyhaven Investments LP Derbyhaven Investments Saint John 714235 2019 12 31 GP LLC The Royal Gazette — February 5, 2020 145 Gazette royale — 5 février 2020

Glenfaba Investments LP Glenfaba Investments Saint John 714236 2019 12 31 GP LLC Glen Maye Investments LP Glen Maye Investments Saint John 714237 2019 12 31 GP LLC Maughold Investments LP Maughold Investments Saint John 714238 2019 12 31 GP LLC Garff Investments LP Garff Investments Saint John 714239 2019 12 31 GP LLC Foxdale Investments LP Foxdale Investments Saint John 714240 2019 12 31 GP LLC Cregneash Investments LP Cregneash Investments Saint John 714241 2019 12 31 GP LLC Ayre Investments LP Ayre Investments Saint John 714242 2019 12 31 GP LLC ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une ship Act, a declaration of extra-provincial limited partnership has déclaration de société en commandite extraprovinciale a été dépo- been filed: sée par : Principal place in Reference New Brunswick Agent and Address Number Date Principal établissement au Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Nouveau-Brunswick Compétence et adresse référence année mois jour

Gentek Building Products Moncton Ontario Deborah M. Power 646516 2020 01 07 Limited Partnership Fredericton

Notices Avis

COURT OF QUEEN’S BENCH OF NEW BRUNSWICK COUR DU BANC DE LA REINE DU NOUVEAU-BRUNSWICK TRIAL DIVISION DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE JUDICIAL DISTRICT OF BATHURST CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE BATHURST

CONSIDERING THE intention to apply for a title VU l’intention de solliciter une déclaration de titre de declaration on the part of Linda Robichaud of Inkerman, in the propriété de Linda Robichaud, d’Inkerman, comté de County of Gloucester and Province of New Brunswick; Gloucester, province du Nouveau-Brunswick; - and - - et - IN THE MATTER of a property located in Pokemouche, in the DANS L’AFFAIRE d’un bien-fonds situé à Pokemouche, Parish of Caraquet, in the County of Gloucester, and Province paroisse de Caraquet, comté de Gloucester et province du of New Brunswick, claimed by Linda Robichaud and Nouveau-Brunswick, revendiqué par Linda Robichaud et désigné designated as being PID 20072369. comme étant le NID 20072369.

(FORM 70A) (FORMULAIRE 70A) NOTICE OF INTENT TO APPLY FOR A AVIS D’INTENTION DE SOLLICITER UNE TITLE DECLARATION DÉCLARATION DE TITRE DE PROPRIÉTÉ

TO WHOM IT MAY CONCERN À QUI DE DROIT YOU ARE ADVISED THAT: SACHEZ QUE : Linda Robichaud, of Inkerman, in the County of Gloucester and Linda Robichaud, d’Inkerman, comté de Gloucester et province Province of New Brunswick, intends to apply for a title du Nouveau-Brunswick, entend solliciter une déclaration de declaration in relation to land located on Route 11, titre de propriété relativement au bien-fonds sis sur la route 11, The Royal Gazette — February 5, 2020 146 Gazette royale — 5 février 2020

Pokemouche, in the County of Gloucester and Province of New Pokemouche, comté de Gloucester et province du Nouveau- Brunswick; Brunswick; The title declaration sought is as follows: La déclaration de titre de propriété recherchée est ainsi établie : A certificate attesting that Linda Robichaud is the owner of Un certificat attestant que Linda Robichaud est la proprié- the land situate on Route 11 in Pokemouche, in the County taire d’un bien-fonds situé sur la route 11 à Pokemouche, of Gloucester and Province of New Brunswick, the legal de- comté de Gloucester et province du Nouveau-Brunswick et scription of which land is set out in Schedule “A” and ap- dont une description figure à l’Annexe A et est démontrée sur pears on the survey plan attached in Schedule “B.” le plan d’arpentage, qui est joint en Annexe B. The title declaration, if granted, will bind all persons. Si elle est accordée, la déclaration de titre de propriété liera toutes les personnes. If you dispute or question the proposed title declaration in any way, you Si vous contestez ou mettez en question de quelque façon que must, no later than the 28th day of February 2020, send a dispute ce soit la déclaration de titre de propriété proposée, vous devez, note to the person giving this notice at the address given below. Form au plus tard le 28 février 2020, envoyer un contredit à l’adresse 70B of the Rules of Court may be used for a dispute note. You indiquée ci-après à la personne qui donne le présent avis et y must indicate the reasons for the objection in your dispute note. énoncer les motifs de votre opposition. À cette fin, vous pouvez vous If you fail to send a dispute note by that date, a proceeding may servir de la formule 70B des Règles de procédure. En cas be commenced and a title declaration granted on the basis that d’omission d’envoyer le contredit au plus tard à cette date, une you do not oppose it. instance pourra être introduite et une déclaration de titre de propriété pourra être accordée sur le fondement de votre absence d’opposition. DATED at Shippagan, New Brunswick, this 20th day of January FAIT à Shippagan, au Nouveau-Brunswick, le 20 janvier 2020. 2020.

Bertin Thériault, Solicitor of Linda Robichaud Maître Bertin Thériault, Avocat de Linda Robichaud Name of person giving this notice: Nom de l’avocat de la personne qui donne le présent avis : Bertin Thériault Bertin Thériault Name of solicitor's firm: Bertin Thériault C.P. Inc. Raison sociale de l’avocat : Bertin Thériault C.P. Inc. Solicitor’s address: Adresse de l’avocat : 283 J.D. Gauthier Blvd., Shippagan, N.B. E8S 1N6 283, boul. J.-D.-Gauthier Shippagan (N.-B.) E8S 1N6

506- 336-4726, Ext. 1 506-336-4726, poste 1 Fax Number : Numéro de télécopieur : 506-336-1159 506-336-1159 2014-76 2014-76

SCHEDULE “A” PID 20072369 ANNEXE « A » NID 20072369 ALL THE LANDS and buildings situate, lying and being in TOUS LES TERRAINS et bâtiments situés à Pokemouche, Pokemouche, in the Parish of Caraquet, County of Gloucester, paroisse de Caraquet, comté de Gloucester, plus précisément more particularly bounded and described as follows: délimités et désignés comme suit : Beginning at survey marker No. 80 located on the eastern edge Commençant au jalon d’arpentage no 80 situé sur la limite est de of Route 11 in Village-Blanchard; la route 11 à Village-Blanchard; Thence, on a New Brunswick Grid North, and along the De là, selon le graticule nord du N.-B., en longeant le bien- property of Odilon Robichaud, 52o 16' 59", over a distance of fonds d’Odilon Robichaud, 52° 16' 59", sur une distance de 1,157.424 metres to survey marker No. 902; 1 157,424 mètres jusqu’au jalon d’arpentage no 902; Thence, 226o 06' 54", along the property of Jeannine Arseneau, De là, 226° 06' 54" en longeant le bien-fonds de Jeannine over a distance of 1,119.628 metres, to survey marker No. 55; Arseneau sur une distance de 1 119,682 mètres jusqu’au jalon d’arpentage no 55; Thence, +/- 314o 04' 09", along Route 11, over all the distance De là, +/- 314° 04' 09" longeant la route 11 sur toute la calculated between survey marker No. 55 and survey marker distance calculée entre le jalon d’arpentage no 55 et le jalon No. 80, to the point of beginning. d’arpentage no 80 jusqu’au point de départ. Being a property in the shape of a triangle. Étant un bien-fonds de forme triangulaire. BEING the same land as described in the Survey Plan of the ÉTANT le même bien-fonds comme décrit dans le Plan property requested by Linda Robichaud and prepared by d’arpentage de la propriété revendiquée par Linda Robichaud Philippe J. Breau of Jules J. Breau et Fils Ltée, dated et préparé par Philippe J. Breau de Jules J. Breau et Fils Ltée, November 26, 2019. en date du 26 novembre 2019. The Royal Gazette — February 5, 2020 147 Gazette royale — 5 février 2020

______

NOTICE TO ALL INTERESTED PERSONS OF A AVIS AUX INTÉRESSÉS D’UN JUGEMENT JUDGMENT IN THE MATTER OF KANSA GENERAL DANS L’AFFAIRE DE KANSA GENERAL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LTD. INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LTD. PURSUANT TO SECTION 161(4) OF THE WINDING-UP EN VERTU DE L’ARTICLE 161(4) DE LA LOI SUR AND RESTRUCTURING ACT, LES LIQUIDATIONS ET LES RESTRUCTURATIONS, R.S.C., 1985, C. W-11 L.R.C. (1985), CH. W-11

NOTICE IS HEREBY GIVEN that on January 13, 2020, the AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que le Honourable Mr. Justice Jean-Yves Lalonde, J.S.C., rendered a 13 janvier 2020, l’Honorable Jean-Yves Lalonde, j.c.s., a rendu judgment in the matter of the winding-up of Kansa General un jugement dans l’affaire de la liquidation de Kansa General International Insurance Company Ltd., formerly Kansa General International Insurance Company Ltd., auparavant Kansa Insurance Company, (hereinafter “Kansa”), in Canada, in the General Insurance Company, (ci-après « Kansa »), au Canada, Court file bearing number 500-05-002760-955: dans le dossier de Cour portant le numéro 500-05-002760-955 :

(a) approving the release of any balance of the assets of Kansa (a) approuvant la remise de tout reliquat de l’actif de Kansa au in Canada by Ferdinand Alfieri, CPA,CA, liquidator of Kansa in Canada par Ferdinand Alfieri, CPA,CA, liquidateur de Kansa Canada (hereinafter the “Liquidator”) to: au Canada (ci-après le « Liquidateur ») à :

Kansa General International Insurance Company Ltd. Kansa General International Insurance Company Ltd. Somerontie 14 Somerontie 14 00550 Helsinki 00550 Helsinki Finland Finlande The Royal Gazette — February 5, 2020 148 Gazette royale — 5 février 2020 in conformity with Section 161(4) of the Winding-up and en vertu de l’article 161(4) de la Loi sur les liquidations et les Restructuring Act, R.S.C., 1985, c. W-11 (version applicable to restructurations, L.R.C. (1985), ch. W-11 (version applicable à the winding-up of Kansa in Canada); la liquidation de Kansa au Canada); (b) approving that the Co-Trustees in the Bankruptcy Estate of (b) approuvant que les Co-Syndics de l’actif de la faillite de Kansa take into their custody and under their control any Kansa prennent en leur garde et sous leur contrôle tout reliquat balance of the assets of Kansa in Canada; de l’actif de Kansa au Canada; (c) declaring that the Liquidator is not liable to any person for (c) déclarant que le Liquidateur n’est pas responsable envers any claim; quiconque pour quelque réclamation; (d) discharging Ferdinand Alfieri as Liquidator and the (d) libérant Ferdinand Alfieri comme Liquidateur et les inspectors; and inspecteurs; et (e) ordering that no suit, action or other proceeding lies against (e) ordonnant qu’aucune poursuite, action ou autre procédure Ferdinand Alfieri, personally or in his capacity as Liquidator, ne puisse être instituée contre Ferdinand Alfieri, and the inspectors, unless they acted in bad faith or committed personnellement ou en sa qualité de Liquidateur, et les an intentional or gross fault. inspecteurs, à moins qu’ils n’aient agi de mauvaise foi ou n’aient commis une faute lourde ou intentionnelle.

Montreal, January 13, 2020 Montréal, le 13 janvier 2020

FERDINAND ALFIERI, CPA,CA FERDINAND ALFIERI, CPA,CA

NB Energy and Commission de l’énergie Utilities Board et des services publics du N.-B.

FORM MC-103 FORMULE MC-103

NB ENERGY AND COMMISSION DE L’ÉNERGIE UTILITIES BOARD ET DES SERVICES PUBLICS DU N.-B. NOTICE OF APPLICATION AVIS DE DEMANDE DE PERMIS FOR A MOTOR CARRIER LICENSE DE TRANSPORTEUR ROUTIER Take notice that the NB Energy and Utilities Board shall on the Prenez avis que la Commission de l’énergie et des services pu- 3rd day of March, 2020 (hereafter referred to as the “Review blics du Nouveau-Brunswick révisera la demande faite par Date”) review an application filed by

Taxi Cormier Ltée Taxi Cormier Ltée 16 Napoleon Road, Caraquet, NB, E1W 1A3 16, chemin Napoléon, Caraquet (N.-B.), E1W 1A3

a licence to operate a public motor bus as follows: le 3ième jour de mars 2020 (ci-après appelée la « date de révision » ) pour un permis d’exploiter un autocar public comme suit :

CHARTER LICENSE: PERMIS NOLISÉ : For the carriage of passengers and their baggage on chartered Pour le transport de passagers et de leurs bagages en voyages trips only, between all points and over all routes in the Prov- nolisés seulement, sur toute les routes et entre tous les points ince of New Brunswick with the privilege of extending into de la province du Nouveau-Brunswick avec droit de prolon- other jurisdictions authorized thereby and the reverse gement(s) aller-retour autorisé(s) de d’autre juridiction(s). thereof.

SCHEDULED LICENSE: PERMIS REGULIER : For the carriage of passengers and their baggage as a sched- Pour le transport de passagers et de leurs bagages comme uled operation between residential communities in the coun- service régulier entre les communautés résidentielles dans ties of Gloucester, Restigouche, Victoria and Madawaska up les comtés de Gloucester, Restigouche, Victoria et Ma- to the Quebec border and return, with the right to extend into dawaska jusqu’à la frontière du Québec et retour, avec droit other jurisdictions, authorized thereby and the reverse de prolongement(s) aller-retour autorisé(s) dans d’autres ju- thereof, and with the right to pick up and to drop off passen- ridictions, avec droit d’y prendre et d’y descendre des passa- gers at all points on Routes 11, 17, 1, 2 and 180 in New gers en cours de route au Nouveau-Brunswick, sur les Brunswick. Routes 11, 17, 1, 2 et 180. The Royal Gazette — February 5, 2020 149 Gazette royale — 5 février 2020

Any person wishing to object to the granting of this application Toute personne qui désire s’opposer à l’accord de la présente shall: demande devra : 1. File with the Board: 1. Déposer auprès de la Commission

(a) notice of objection to the application at least 7 days prior a) un avis d’opposition à la demande au moins 7 jours avant to the “Review Date”. In the notice, indicate your contact la date de révision. Dans l’avis, indiquer vos coordonnées information and your choice of language, and et votre choix de langue, et (b) one day prior to the “Review Date” a written statement b) une opposition par écrit au moins un jour avant la date setting out in full the reasons why the application should de révision, énonçant tous les motifs pour lesquels la de- be denied together with any relevant documentary evi- mande devrait être refusée, accompagnée de toute dence. preuve documentaire pertinente.

2. Serve a copy of the notice of objection upon the applicant 2. Signifier au requérant une copie de l’avis d’opposition by:

(a) personal service at least 7 days prior to the “Review a) par signification à personne au moins 7 jours avant la Date”, or date de révision, ou

(b) prepaid registered mail at the address below, posted at b) à l’adresse ci-dessous, par courrier recommandé affran- least 10 days prior to the “Review Date”. chi, mis à la poste au moins 10 jours avant la date de révi- sion.

ADDRESSES FOR SERVICE: ADRESSES AUX FINS DE SIGNIFICATION : Applicant: Requérant :

Annie Annette Landry NB Energy and Utilities Board Annie Annette Landry Commission de l’énergie et des services Taxi Cormier Ltée 15 Market Square, Suite 1400 Taxi Cormier Ltée publics du Nouveau-Brunswick 16 Napoleon Road P.O. Box 5001 16, chemin Napoléon 15, Market Square, Bureau 1400 Caraquet, NB Saint John, N.B. Caraquet (N.-B.) C.P. 5001 E1W 1A3 E2L 4Y9 E1W 1A3 Saint John (N.-B.) E2L 4Y9

Notices of Sale Avis de vente

ESTATE OF RAYMOND LEVESQUE, of 216 Tobique DESTINATAIRES : LA SUCCESSION DE RAYMOND Road, Grand Falls, in the County of Victoria and Province of LEVESQUE, du 216, chemin Tobique, à Grand-Sault, comté New Brunswick, mortgagor and owner of the equity of de Victoria, province du Nouveau-Brunswick, débitrice redemption, FAIRSTONE FINANCIAL INC., holder of the hypothécaire et propriétaire du droit de rachat; FINANCIÈRE first Mortgage and to ALL OTHER WHOM IT MAY FAIRSTONE INC., titulaire de la première hypothèque; et CONCERN TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.

Freehold premises situate, lying and being at 216 Tobique Lieux en tenure libre situés au 216, chemin Tobique, à Grand- Road, Grand Falls, in the Victoria County and Province of New Sault, comté de Victoria, province du Nouveau-Brunswick, et Brunswick, known as PIDs 65103731 & 65009797. dont les NID sont 65103731 et 65009797.

Notice of sale is given by the holder of the said first Mortgage. Avis de vente donné par la titulaire de ladite première hypothèque.

Sale to be held on February 27th, 2020, at 11:00 a.m., at the La vente aura lieu le 27 février 2020, à 11 h, à l’hôtel de ville Town Hall located at 131 Pleasant Street, in Grand Falls, in the de Grand-Sault, au 131, rue Pleasant, à Grand-Sault, comté de Victoria County and Province of New Brunswick. Victoria, province du Nouveau-Brunswick.

See advertisement in the newspaper Victoria Star, editions of Voir l’annonce publiée dans les éditions du 29 janvier et du 5 January 29th, 2020 and February 5th, 2020. février 2020 du Victoria Star. The Royal Gazette — February 5, 2020 150 Gazette royale — 5 février 2020

Dated at Edmundston, New Brunswick, this 16th day of Fait à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, le 16 janvier 2020. January, 2020.

GARY J. McLAUGHLIN, Q.C. GARY J. McLAUGHLIN, c.r. McLaughlin Law Offices Cabinet juridique McLaughlin Solicitors and agents for Fairstone Avocats et représentants de Financière Fairstone Inc. Financial Inc.

______

PROVINCE OF NEW BRUNSWICK PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK COUNTY OF GLOUCESTER COMTÉ DE GLOUCESTER

TO: Joseph Gilles Gautreau (Gilles Gautreau) par son DESTINATAIRES : Joseph Gilles Gautreau (Gilles syndic, Grant Thornton Limited, and Marie Avilda Gautreau), par son syndic, Grant Thornton Limited et Thibodeau (Avilda Thibodeau), par son syndic, Grant Marie Avilda Thibodeau (Avilda Thibodeau), par son Thornton Limited, mortgagees syndic, Grant Thornton Limited, débiteurs hypothécaires

ET À : TOUTES AUTRES PERSONNES INTÉRESSÉES

AND TO: ALL OTHER WHOM IT MAY CONCERN ET À : TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL

Freehold property situate at 3665 Luce Street, in Tracadie, in Bien en tenure libre situé au 3665, rue Luce, à Tracadie, dans the Parish of Saumarez, in the County of Gloucester and the la paroisse de Saumarez, dans le comté de Gloucester et la Province of New Brunswick, said property having PID province du Nouveau-Brunswick, ladite propriété ayant le NID 20363495. 20363495.

Sale conducted under the Power of Sale in the mortgage and Vente effectuée en vertu du pouvoir de vente contenu dans under the Property Act. l’acte d’hypothèque et de la Loi sur les biens.

Notice of sale given by Caisse populaire acadienne ltée, Avis de vente donné par Caisse populaire acadienne ltée, mortgagee. créancière hypothécaire.

Sale will be held on February 24th, 2020, at 1:30 o’clock p. m., La vente aura lieu le 24 février 2020, à 13 h 30 heure locale, à, at the Town Hall of the Municipalité régionale de Tracadie, l’entrée principale de l’Édifice municipal de la municipalité located at 3267 Main Street, in Tracadie, in the County of régionale de Tracadie, au 3267, rue Principale, à Tracadie, dans Gloucester and the Province of New Brunswick. See le comté de Gloucester et la province du Nouveau-Brunswick. advertisement in L’Acadie Nouvelle. Voir l’annonce publiée dans L’Acadie Nouvelle.

José Duguay José Duguay

DUGUAY PAULIN LÉGER DUGUAY PAULIN LÉGER 3623 Principale Street 3623, rue Principale Tracadie Sheila, N.B. Tracadie-Sheila, N.-B. ElX 1C9 E1X 1C9 Solicitors for Caisse populaire acadienne ltée Avocats de Caisse populaire acadienne ltée The Royal Gazette — February 5, 2020 151 Gazette royale — 5 février 2020

Notice to Advertisers Avis aux annonceurs

The Royal Gazette is published every Wednesday under the La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformé- authority of the Official Notices Publication Act. Documents ment à la Loi sur la publication des avis officiels. Les docu- must be received by the Royal Gazette coordinator, Legisla- ments à publier doivent parvenir à le coordonnateur de la tive Services, no later than noon, at least seven days prior to Gazette royale, aux Services législatifs, à midi, au moins sept Wednesday’s publication. Each document must be separate jours avant le mercredi de publication. Chaque avis doit être from the covering letter. Signatures on documents must be im- séparé de la lettre d’envoi. Les noms des signataires doivent mediately followed by the printed name. The Royal Gazette suivre immédiatement la signature. Le coordonnateur de la coordinator may refuse to publish a document if any part of it Gazette royale peut refuser de publier un avis dont une partie is illegible, and may delay publication of any document for ad- est illisible et retarder la publication d’un avis pour des raisons ministrative reasons. administratives. Prepayment is required for the publication of all documents. Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis. Standard documents have the following set fees: Voici les tarifs pour les avis courants :

Notices Fee Avis Droit

Notice of the intention to apply for the enactment of a $ 20 Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loi 20 $ private bill d’intérêt privé Originating process $ 25 Acte introductif d’instance 25 $ Order of a court $ 25 Ordonnance rendue par une cour 25 $ Notice under the General Rules under the Law Society Act, $ 20 Avis de radiation ou de suspension ou de demande de 20 $ 1996, of disbarment or suspension or of application for réintégration ou de réadmission, que prévoient les Règles reinstatement or readmission générales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur le Barreau Notice of examination under the Licensed Practical Nurses $ 25 Avis d’examen qu’exige la Loi sur les infirmières et infirmiers 25 $ Act auxiliaires autorisés Notice under the Motor Carrier Act $ 30 Avis qu’exige la Loi sur les transports routiers 30 $ Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9 $ 20 Avis aux créanciers prévu par le Règlement du Nouveau- 20 $ under the Probate Court Act Brunswick 84-9 pris en vertu de la Loi sur la Cour des successions Notice under Rule 70 of the Rules of Court $120 Avis qu’exige la Règle 70 des Règles de procédure 120 $ Note: Survey Maps cannot exceed 8.5 x 14 Nota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 po sur 14 po Notice of sale of property under an Act, if the notice is 1/2 page $ 20 Avis de vente d’un bien que prévoit une loi, si l’avis mesure 20 $ or less une demi-page ou moins Notice of sale of property under an Act, if the notice is greater $ 75 Avis de vente d’un bien que prévoit une loi, si l’avis est de 75 $ than 1/2 page plus une demi-page Any document under the Winding-up and Restructuring Act $ 20 Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur les 20 $ (Canada) liquidations et les restructurations (Canada) Notice of a correction fee is Avis de correction les droits sont the same as les mêmes que for publishing ceux exigés the original pour la document publication du document original

Any other document $3.50 for each Tout autre document 3,50 $ pour ch- cm (rounded aque cm up to the (arrondi au cm nearest cm) supérieur)

Payments can be made by cheque or money order (payable to Les paiements peuvent être faits par chèque ou mandat (à the Minister of Finance). No refunds will be issued for cancel- l’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement ne lations. sera effectué en cas d’annulation.

The official version of The Royal Gazette is available free La version officielle de la Gazette royale est disponible gra- on-line each Wednesday. tuitement en ligne chaque mercredi. The Royal Gazette — February 5, 2020 152 Gazette royale — 5 février 2020

Our new address as of Notre nouvelle adresse à partir du January 1st, 2020, is as follows: 1er janvier 2020 :

The Royal Gazette Gazette royale Service New Brunswick Services Nouveau-Brunswick Brookside Place Place Brookside 435 Brookside Drive, Suite 30 435, promenade Brookside, bureau 30 P.O. Box 6000 C.P. 6000 Fredericton, NB E3B 5H1 Fredericton (N.-B.) E3B 5H1

Tel: 506-453-3864 Tél. : 506-453-3864 E-mail: [email protected] Courriel : [email protected]

Note: Deliveries are to be addressed to The Royal Gazette and Note : Toute livraison étant adressée à la Gazette royale doit left at the reception. être remise à la réception.

SERVICE NEW BRUNSWICK © SERVICES NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved / Tous droits réservés