The Royal Gazette Gazette royale

Fredericton Fredericton Nouveau-Brunswick

ISSN 1714-9428

Vol. 176 Wednesday, April 18, 2018 / Le mercredi 18 avril 2018 545 Notice to Readers Avis aux lecteurs

The Royal Gazette is officially published on-line. La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne. Except for formatting, documents are published in The Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans Royal Gazette as submitted. la Gazette royale comme soumis. Material submitted for publication must be received by Les documents à publier doivent parvenir au coordonna- the Royal Gazette coordinator no later than noon, at least teur de la Gazette royale, à midi, au moins 7 jours ou- 7 working days prior to Wednesday’s publication. vrables avant le mercredi de publication. En cas de jour However, when there is a public holiday, please contact férié, veuillez communiquer avec le coordonnateur. the coordinator.

Orders in Council Décrets en conseil

MARCH 14, 2018 LE 14 MARS 2018 2018-84 2018-84 1. Under section 2.1 of the Intimate Partner Violence Inter- 1. En vertu de l’article 2.1 de la Loi sur l’intervention en matière vention Act and subsection 5(2) of the Interpretation Act, the de violence entre partenaires intimes et du paragraphe 5(2) de la Lieutenant-Governor in Council designates, as a category of Loi d’interprétation, le lieutenant-gouverneur en conseil désigne, persons, Emergency Adjudicative Officers appointed under the comme catégorie de personnes, les agents décisionnaires en inter- Judicature Act, as a designated authority for the purposes of the vention d’urgence nommés en vertu de la Loi sur l’organisation Intimate Partner Violence Intervention Act, to hear, and make judiciaire, à titre d’autorité désignée aux fins d’application de la determinations on, applications for emergency intervention or- Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires in- ders. times, pour qu’ils entendent et tranchent des requêtes en vue de l’obtention d’ordonnances d’intervention d’urgence. 2. Under subsections 18(1) and 18(3) of the Small Claims 2. En vertu des paragraphes 18(1) et 18(3) de la Loi sur les pe- Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints Tammy tites créances, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme Moore, Saint John, New Brunswick, as an Adjudicator, for a Tammy Moore, de Saint John (Nouveau-Brunswick), à titre term of ten years, effective April 30, 2018. d’adjudicatrice, pour un mandat de dix ans, à compter du 30 avril 2018. The Royal Gazette — April 18, 2018 546 Gazette royale — 18 avril 2018

3. Under subsections 56.5(1) and 56.5(5) of the Judicature 3. En vertu des paragraphes 56.5(1) et 56.5(5) de la Loi sur Act, the Lieutenant-Governor in Council, on the recommenda- l’organisation judiciaire, le lieutenant-gouverneur en conseil, tion of the Minister of Justice and Public Safety, appoints sur la recommandation du ministre de la Justice et de la Sécurité Tammy Moore, Saint John, New Brunswick, as an Emergency publique, nomme Tammy Moore, de Saint John (Nouveau- Adjudicative Officer, for a term of ten years, effective April 30, Brunswick), à titre d’agente décisionnaire en intervention d’ur- 2018. gence, pour un mandat de dix ans, à compter du 30 avril 2018. 4. Under subsections 56.1(1) and 56.1(5) of the Judicature 4. En vertu des paragraphes 56.1(1) et 56.1(5) de la Loi sur l’or- Act, the Lieutenant-Governor in Council, on the recommenda- ganisation judiciaire, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la tion of the Minister of Justice and Public Safety, appoints recommandation du ministre de la Justice et de la Sécurité pu- Tammy Moore, Saint John, New Brunswick, as a Case Manage- blique, nomme Tammy Moore, de Saint John (Nouveau- ment Master, for a term of three years, effective April 30, 2018. Brunswick), à titre de conseillère-maître chargée de la gestion des causes, pour un mandat de trois ans, à compter du 30 avril 2018. 5. Under subsections 18(1) and 18(3) of the Small Claims 5. En vertu des paragraphes 18(1) et 18(3) de la Loi sur les pe- Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints Brian tites créances, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme Maude, Saint John, New Brunswick, as an Adjudicator, for a Brian Maude, de Saint John (Nouveau-Brunswick), à titre d’ad- term of ten years, effective April 9, 2018. judicateur, pour un mandat de dix ans, à compter du 9 avril 2018. 6. Under subsections 56.5(1) and 56.5(5) of the Judicature 6. En vertu des paragraphes 56.5(1) et 56.5(5) de la Loi sur Act, the Lieutenant-Governor in Council, on the recommenda- l’organisation judiciaire, le lieutenant-gouverneur en conseil, tion of the Minister of Justice and Public Safety, appoints Brian sur la recommandation du ministre de la Justice et de la Sécurité Maude, Saint John, New Brunswick, as an Emergency Adjudi- publique, nomme Brian Maude, de Saint John (Nouveau- cative Officer, for a term of ten years, effective April 9, 2018. Brunswick), à titre d’agent décisionnaire en intervention d’ur- gence, pour un mandat de dix ans, à compter du 9 avril 2018. 7. Under subsections 56.1(1) and 56.1(5) of the Judicature 7. En vertu des paragraphes 56.1(1) et 56.1(5) de la Loi sur Act, the Lieutenant-Governor in Council, on the recommenda- l’organisation judiciaire, le lieutenant-gouverneur en conseil, tion of the Minister of Justice and Public Safety, appoints Brian sur la recommandation du ministre de la Justice et de la Sécurité Maude, Saint John, New Brunswick, as a Case Management publique, nomme Brian Maude, de Saint John (Nouveau- Master, for a term of three years, effective April 9, 2018. Brunswick), à titre de conseiller-maître chargé de la gestion des causes, pour un mandat de trois ans, à compter du 9 avril 2018. 8. Under subsections 18(1) and 18(3) of the Small Claims 8. En vertu des paragraphes 18(1) et 18(3) de la Loi sur les pe- Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints Diane De- tites créances, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme schênes, Moncton, New Brunswick, as an Adjudicator, for a Diane Deschênes, de Moncton (Nouveau-Brunswick), à titre term of ten years, effective April 9, 2018. d’adjudicatrice, pour un mandat de dix ans, à compter du 9 avril 2018. 9. Under subsections 56.5(1) and 56.5(5) of the Judicature 9. En vertu des paragraphes 56.5(1) et 56.5(5) de la Loi sur Act, the Lieutenant-Governor in Council, on the recommenda- l’organisation judiciaire, le lieutenant-gouverneur en conseil, tion of the Minister of Justice and Public Safety, appoints Diane sur la recommandation du ministre de la Justice et de la Sécurité Deschênes, Moncton, New Brunswick, as an Emergency Adju- publique, nomme Diane Deschênes, de Moncton (Nouveau- dicative Officer, for a term of ten years, effective April 9, 2018. Brunswick), à titre d’agente décisionnaire en intervention d’ur- gence, pour un mandat de dix ans, à compter du 9 avril 2018. 10. Under subsections 56.1(1) and 56.1(5) of the Judicature 10. En vertu des paragraphes 56.1(1) et 56.1(5) de la Loi sur Act, the Lieutenant-Governor in Council, on the recommenda- l’organisation judiciaire, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur tion of the Minister of Justice and Public Safety, appoints Diane la recommandation du ministre de la Justice et de la Sécurité pu- Deschênes, Moncton, New Brunswick, as a Case Management blique, nomme Diane Deschênes, de Moncton (Nouveau- Master, for a term of three years, effective April 9, 2018. Brunswick), à titre de conseillère-maître chargée de la gestion des causes, pour un mandat de trois ans, à compter du 9 avril 2018. 11. Under subsections 18(1) and 18(3) of the Small Claims 11. En vertu des paragraphes 18(1) et 18(3) de la Loi sur les Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints Donald Bou- petites créances, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme dreau, Bathurst, New Brunswick, as an Adjudicator, for a term Donald Boudreau, de Bathurst (Nouveau-Brunswick), à titre of ten years, effective April 9, 2018. d’adjudicateur, pour un mandat de dix ans, à compter du 9 avril 2018. 12. Under subsections 56.5(1) and 56.5(5) of the Judicature 12. En vertu des paragraphes 56.5(1) et 56.5(5) de la Loi sur Act, the Lieutenant-Governor in Council, on the recommenda- l’organisation judiciaire, le lieutenant-gouverneur en conseil, tion of the Minister of Justice and Public Safety, appoints Don- sur la recommandation du ministre de la Justice et de la Sécurité ald Boudreau, Bathurst, New Brunswick, as an Emergency Ad- publique, nomme Donald Boudreau, de Bathurst (Nouveau- judicative Officer, for a term of ten years, effective April 9, Brunswick), à titre d’agent décisionnaire en intervention d’ur- 2018. gence, pour un mandat de dix ans, à compter du 9 avril 2018. 13. Under subsections 56.9(1) and 56.9(2) of the Judicature 13. En vertu des paragraphes 56.9(1) et 56.9(2) de la Loi sur Act, the Lieutenant-Governor in Council designates Donald l’organisation judiciaire, le lieutenant-gouverneur en conseil Boudreau, Bathurst, New Brunswick, as Chief Hearing Officer, désigne Donald Boudreau, de Bathurst (Nouveau-Brunswick), for a term of ten years, effective April 9, 2018. à titre d’agent en chef des audiences, pour un mandat de dix ans, à compter du 9 avril 2018. The Royal Gazette — April 18, 2018 547 Gazette royale — 18 avril 2018

14. Under subsections 56.5(1) and 56.5(5) of the Judicature 14. En vertu des paragraphes 56.5(1) et 56.5(5) de la Loi sur Act, the Lieutenant-Governor in Council, on the recommenda- l’organisation judiciaire, le lieutenant-gouverneur en conseil, tion of the Minister of Justice and Public Safety, appoints Anne sur la recommandation du ministre de la Justice et de la Sécurité Richard, Moncton, New Brunswick, as an Emergency Adjudi- publique, nomme Anne Richard, de Moncton (Nouveau- cative Officer, for a term of ten years, effective April 9, 2018. Brunswick), à titre d’agente décisionnaire en intervention d’ur- gence, pour un mandat de dix ans, à compter du 9 avril 2018. 15. Under subsections 56.1(1) and 56.1(5) of the Judicature 15. En vertu des paragraphes 56.1(1) et 56.1(5) de la Loi sur Act, the Lieutenant-Governor in Council, on the recommenda- l’organisation judiciaire, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur tion of the Minister of Justice and Public Safety, appoints Anne la recommandation du ministre de la Justice et de la Sécurité pu- Richard, Moncton, New Brunswick, as a Case Management blique, nomme Anne Richard, de Moncton (Nouveau- Master, for a term of three years, effective April 9, 2018. Brunswick), à titre de conseillère-maître chargée de la gestion des causes, pour un mandat de trois ans, à compter du 9 avril 2018 16. Under subsections 56.5(1) and 56.5(5) of the Judicature 16. En vertu des paragraphes 56.5(1) et 56.5(5) de la Loi sur Act, the Lieutenant-Governor in Council, on the recommenda- l’organisation judiciaire, le lieutenant-gouverneur en conseil, tion of the Minister of Justice and Public Safety, appoints Mat- sur la recommandation du ministre de la Justice et de la Sécurité thew Cripps, Miramichi, New Brunswick, as an Emergency Ad- publique, nomme Matthew Cripps, de Miramichi (Nouveau- judicative Officer, for a term of ten years, effective April 9, Brunswick), à titre d’agent décisionnaire en intervention d’ur- 2018. gence, pour un mandat de dix ans, à compter du 9 avril 2018. 17. Under section 61 and subsections 68(1) and 68(2) of the 17. En vertu de l’article 61 et des paragraphes 68(1) et 68(2) Judicature Act, subsection 12(1) of the Probate Court Act, and de la Loi sur l’organisation judiciaire, du paragraphe 12(1) de la section 26 of the Interpretation Act, the Lieutenant-Governor in Loi sur la Cour des successions et de l’article 26 de la Loi d’in- Council revokes: terprétation, le lieutenant-gouverneur en conseil révoque : (a) Order in Council 2014-46 dated February 20, 2014; a) le décret en conseil 2014-46 pris le 20 février 2014; (b) Order in Council 96-316 dated March 21, 1996; and b) le décret en conseil 96-316 pris le 21 mars 1996; et (c) Order in Council 2000-184 dated April 20, 2000. c) le décret en conseil 2000-184 pris le 20 avril 2000. 18. Under subsections 56.1(1) and 56.1(5) of the Judicature 18. En vertu des paragraphes 56.1(1) et 56.1(5) de la Loi sur Act, and section 26 of the Interpretation Act, the Lieutenant- l’organisation judiciaire et de l’article 26 de la Loi d’interpréta- Governor in Council revokes Order in Council 2015-255 dated tion, le lieutenant-gouverneur en conseil révoque le décret en October 28, 2015. conseil 2015-255 pris le 28 octobre 2015.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

______

MARCH 14, 2018 LE 14 MARS 2018 2018-93 2018-93 Under subsection 26(1) of The Residential Tenancies Act and En vertu du paragraphe 26(1) de la Loi sur la location de locaux paragraph 21(1)(a) of the Interpretation Act, the Lieutenant- d’habitation et de l’alinéa 21(1)a) de la Loi d’interprétation, le Governor in Council revokes section 5 of Order in Council lieutenant-gouverneur en conseil révoque l’article 5 du décret 2018-19, dated January 10, 2018. en conseil 2018-19 pris le 10 janvier 2018.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

______

MARCH 21, 2018 LE 21 MARS 2018 2018-95 2018-95 1. Under paragraph 4(1)(c) and subsections 4(2) and 4(3) of 1. En vertu de l’alinéa 4(1)c) et des paragraphes 4(2) et 4(3) the New Brunswick Housing Act, the Lieutenant-Governor in de la Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick, le lieutenant- Council appoints Amélie Deschênes, Fredericton, New Bruns- gouverneur en conseil nomme Amélie Deschênes, de wick, as a Director of the New Brunswick Housing Corpora- Fredericton (Nouveau-Brunswick), administratrice de la So- tion, for a term of three years, effective April 1, 2018. ciété d’habitation du Nouveau-Brunswick, pour un mandat de trois ans, à compter du 1er avril 2018. 2. Under paragraph 4(1)(c) and subsections 4(2) and 4(3) of 2. En vertu de l’alinéa 4(1)c) et des paragraphes 4(2) et 4(3) the New Brunswick Housing Act, the Lieutenant-Governor in de la Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick, le lieutenant- Council appoints Scott Green, Woodstock, New Brunswick, as gouverneur en conseil nomme Scott Green, de Woodstock a Director of the New Brunswick Housing Corporation, for a (Nouveau-Brunswick), administrateur de la Société d’habita- term of three years, effective April 1, 2018. tion du Nouveau-Brunswick, pour un mandat de trois ans, à compter du 1er avril 2018. The Royal Gazette — April 18, 2018 548 Gazette royale — 18 avril 2018

3. Under paragraph 4(1)(c) and subsections 4(2) and 4(3) of 3. En vertu de l’alinéa 4(1)c) et des paragraphes 4(2) et 4(3) the New Brunswick Housing Act, the Lieutenant-Governor in de la Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick, le lieutenant- Council appoints Yvonne Samson, Fredericton, New Bruns- gouverneur en conseil nomme Yvonne Samson, de Fredericton wick, as a Director of the New Brunswick Housing Corpora- (Nouveau-Brunswick), administratrice de la Société d’habita- tion, for a term of three years, effective April 1, 2018. tion du Nouveau-Brunswick, pour un mandat de trois ans, à compter du 1er avril 2018. 4. Under paragraph 4(1)(c) and subsections 4(2) and 4(3) of 4. En vertu de l’alinéa 4(1)c) et des paragraphes 4(2) et 4(3) the New Brunswick Housing Act, the Lieutenant-Governor in de la Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick, le lieutenant- Council appoints Tom MacFarlane, Nashwaak Bridge, New gouverneur en conseil nomme Tom MacFarlane, de Brunswick, as a Director of the New Brunswick Housing Cor- Nashwaak Bridge (Nouveau-Brunswick), administrateur de la poration, for a term of three years, effective April 1, 2018. Société d’habitation du Nouveau-Brunswick, pour un mandat de trois ans, à compter du 1er avril 2018. 5. Under paragraph 4(1)(c) and subsections 4(2) and 4(3) of 5. En vertu de l’alinéa 4(1)c) et des paragraphes 4(2) et 4(3) the New Brunswick Housing Act, the Lieutenant-Governor in de la Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick, le lieutenant- Council appoints Carol Desrosiers, Beresford, New Brunswick, gouverneur en conseil nomme Carol Desrosiers, de Beresford as a Director of the New Brunswick Housing Corporation, for a (Nouveau-Brunswick), administratrice de la Société d’habita- term of three years, effective April 1, 2018. tion du Nouveau-Brunswick, pour un mandat de trois ans, à compter du 1er avril 2018. 6. Under paragraph 4(1)(c) and subsections 4(2) and 4(3) of 6. En vertu de l’alinéa 4(1)c) et des paragraphes 4(2) et 4(3) the New Brunswick Housing Act, the Lieutenant-Governor in de la Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick, le lieutenant- Council appoints Lynn Ouellette Sauvageau, Grand Falls, New gouverneur en conseil nomme Lynn Ouellette Sauvageau, de Brunswick, as a Director of the New Brunswick Housing Cor- Grand-Sault (Nouveau-Brunswick), administratrice de la So- poration, for a term of three years, effective April 1, 2018. ciété d’habitation du Nouveau-Brunswick, pour un mandat de trois ans, à compter du 1er avril 2018. 7. Under paragraph 4(1)(c) and subsections 4(2) and 4(3) of 7. En vertu de l’alinéa 4(1)c) et des paragraphes 4(2) et 4(3) the New Brunswick Housing Act, the Lieutenant-Governor in de la Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick, le lieutenant- Council appoints Carla Gregan-Burns, Miramichi, New Bruns- gouverneur en conseil nomme Carla Gregan-Burns, de wick, as a Director of the New Brunswick Housing Corpora- Miramichi (Nouveau-Brunswick), administratrice de la Société tion, for a term of three years, effective April 1, 2018. d’habitation du Nouveau-Brunswick, pour un mandat de trois ans, à compter du 1er avril 2018. 8. Under paragraph 4(1)(c) and subsections 4(2) and 4(3) of 8. En vertu de l’alinéa 4(1)c) et des paragraphes 4(2) et 4(3) de the New Brunswick Housing Act, the Lieutenant-Governor in la Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick, le lieutenant- Council reappoints Dominic Aubé, North Tetagouche, New gouverneur en conseil nomme pour un nouveau mandat Brunswick, as a Director of the New Brunswick Housing Cor- Dominic Aubé, de North Tetagouche (Nouveau-Brunswick), ad- poration, for a term of three years, effective April 1, 2018. ministrateur de la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick, pour un mandat de trois ans, à compter du 1er avril 2018. 9. Under paragraph 4(1)(b) and subsection 4(2) of the New 9. En vertu de l’alinéa 4(1)b) et du paragraphe 4(2) de la Loi Brunswick Housing Act, the Lieutenant-Governor in Council sur l’habitation au Nouveau-Brunswick, le lieutenant- appoints Eric Beaulieu, Deputy Minister of Social Develop- gouverneur en conseil nomme Éric Beaulieu, sous-ministre du ment, as President of the New Brunswick Housing Corporation, Développement social, président du conseil d’administration de effective March 21, 2018. la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick, à compter du 21 mars 2018.

Bradley V. Green, Administrator L’administrateur, Bradley V. Green

______

MARCH 21, 2018 LE 21 MARS 2018 2018-101 2018-101 Under subsection 4(1) of the New Brunswick Municipal Fi- En vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur la Corporation de finan- nance Corporation Act, the Lieutenant-Governor in Council ap- cement des municipalités du Nouveau-Brunswick, le lieutenant- points Cathy Graham, Saint John, New Brunswick, as a director gouverneur en conseil nomme Cathy Graham, de Saint John of the New Brunswick Municipal Finance Corporation, for a (Nouveau-Brunswick), administratrice de la Corporation de fi- term of two years, effective June 16, 2018. nancement des municipalités du Nouveau-Brunswick, pour un mandat de deux ans, à compter du 16 juin 2018.

Bradley V. Green, Administrator L’administrateur, Bradley V. Green

______The Royal Gazette — April 18, 2018 549 Gazette royale — 18 avril 2018

MARCH 21, 2018 LE 21 MARS 2018 2018-103 2018-103 Under section 2 of the Control of Municipalities Act, the Lieu- En vertu de l’article 2 de la Loi sur le contrôle des municipalités, tenant-Governor in Council appoints Kelli Simmonds as Com- le lieutenant-gouverneur en conseil nomme Kelli Simmonds à missioner of Municipal Affairs, effective March 21, 2018. titre de commissaire aux affaires municipales, à compter du 21 mars 2018.

Bradley V. Green, Administrator L’administrateur, Bradley V. Green

______

MARCH 21, 2018 LE 21 MARS 2018 2018-104 2018-104 Under section 3 of the Regional Development Corporation Act, En vertu de l’article 3 de la Loi sur la Société de développement the Lieutenant-Governor in Council amends section 5 of Order régional, le lieutenant-gouverneur en conseil modifie l’article 5 in Council 2017-304 dated November 22, 2017 by striking out du décret en conseil 2017-304, pris le 22 novembre 2017, par la “effective May 1, 2018” and substituting therefor “effective suppression de « à compter du 1er mai 2018 » et son remplace- April 1, 2018”. ment par « à compter du 1er avril 2018 ».

Bradley V. Green, Administrator L’administrateur, Bradley V. Green

______

MARCH 28, 2018 LE 28 MARS 2018 2018-107 2018-107 1. Under section 19.2 and subsection 19.21(1) of the Insur- 1. En vertu de l’article 19.2 et du paragraphe 19.21(1) de la ance Act, the Lieutenant-Governor in Council reappoints Fran- Loi sur les assurances, le lieutenant-gouverneur en conseil cine Kanhai, Saint André, New Brunswick, as a member of the nomme pour un nouveau mandat Francine Kanhai, de New Brunswick Insurance Board, for a term of three years, ef- Saint-André (Nouveau-Brunswick), membre de la Commission fective May 7, 2018. des assurances du Nouveau-Brunswick, pour un mandat de trois ans, à compter du 7 mai 2018. 2. Under section 19.2 and subsection 19.21(1) of the Insur- 2. En vertu de l’article 19.2 et du paragraphe 19.21(1) de la ance Act, the Lieutenant-Governor in Council reappoints Kath- Loi sur les assurances, le lieutenant-gouverneur en conseil erine Munro, Saint John, New Brunswick, as a member of the nomme pour un nouveau mandat Katherine Munro, de Saint New Brunswick Insurance Board, for a term of three years, ef- John (Nouveau-Brunswick), membre de la Commission des as- fective August 8, 2018. surances du Nouveau-Brunswick, pour un mandat de trois ans, à compter du 8 août 2018.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

Elections Élections New Brunswick Nouveau-Brunswick 04-11 04-12 Pursuant to subsection 9(4) of the Elections Act, chapter E-3, Conformément au paragraphe 9(4) de la Loi électorale, Province of New Brunswick, the following is a list of the chapitre E-3, province du Nouveau-Brunswick, ce qui suit est une names, addresses and occupations of the returning officers for liste des noms, adresses et professions des directeurs et directrices the following electoral district in the Province : du scrutin des circonscriptions électorales suivantes de la province : ______Electoral District Name Address Occupation Circonscription électorale Nom Adresse Profession

______26 SUSSEX-FUNDY-ST. MARTINS / Denis Pinet 52 ch Cougle Rd Retired Teacher / SUSSEX-FUNDY-ST. MARTINS Sussex Corner, NB E4E 2S6 Enseignant retraité The Royal Gazette — April 18, 2018 550 Gazette royale — 18 avril 2018

32 SAINT JOHN HARBOUR / Patrick McCaffrey 66 rue Leinster St Retired / SAINT JOHN HARBOUR Saint John, NB E2L 1J1 Retraité

39 NEW MARYLAND-SUNBURY / Camille Malenfant 496 ch Bryson Rd Retired / NEW MARYLAND-SUNBURY Nasonworth, NB E3B 8E9 Retraité

41 FREDERICTON NORTH / Judi Sloat 201-101 rue Northumberland St Retired / FREDERICTON-NORD Fredericton, NB E3B 3J1 Retraitée

______

SUPERVISOR OF POLITICAL FINANCING CONTRÔLEUR DU FINANCEMENT POLITIQUE In accordance with section 36 of the Political Process Financ- Selon l’article 36 de la Loi sur le financement de l’activité poli- ing Act, the annual allowance paid to each of the registered po- tique, l’allocation annuelle versée à chaque parti politique enregis- litical parties for the fiscal year 2017-2018 was as follows: tré pendant l’année financière 2017-2018 étaient comme suit :

• New Brunswick Liberal Association $282,940 • Association libérale du Nouveau-Brunswick 282 940 $ • Progressive Conservative Party of • Parti progressiste-conservateur du New Brunswick $230,300 Nouveau-Brunswick 230 300 $ • New Brunswick • Nouveau Parti démocratique du New Democratic Party $86,198 Nouveau-Brunswick 86 198 $ • Parti Vert N.B. Green Party $44,086 • Parti Vert N.B. Green Party 44 086 $ • People’s Alliance of New Brunswick $14,476 • Alliance des gens du Nouveau-Brunswick 14 476 $ • KISS N. B. Political Party $0 • KISS N. B. Political Party 0 $

Total $658,000 Total 658 000 $

In accordance with section 32.01 of the Political Process Financ- Selon l’article 32.01 de la Loi sur le financement de l’activité po- ing Act, the annual allowance that is payable to each of the regis- litique, l’allocation annuelle payable à chaque parti politique en- tered political parties for the fiscal year 2018-2019 is as follows: registré pendant l’année financière 2018-2019 est comme suit :

• New Brunswick Liberal Association $269,180 • Association libérale du Nouveau-Brunswick 269 180 $ • Progressive Conservative Party of • Parti progressiste-conservateur du New Brunswick $219,100 Nouveau-Brunswick 219 100 $ • New Brunswick • Nouveau Parti démocratique du New Democratic Party $82,006 Nouveau-Brunswick 82 006 $ • Parti Vert N.B. Green Party $41,942 • Parti Vert N.B. Green Party 41 942 $ • People’s Alliance of New Brunswick $13,772 • Alliance des gens du Nouveau-Brunswick 13 772 $ • KISS N. B. Political Party $0 • KISS N. B. Political Party 0 $

Total $626,000 Total 626 000 $

DATED at Fredericton this 3rd day of April 2018. FAIT à Fredericton le 3 avril 2018.

Kimberly Poffenroth, Supervisor of Political Financing Kimberly Poffenroth, contrôleur du financement politique The Royal Gazette — April 18, 2018 551 Gazette royale — 18 avril 2018

Business Corporations Act Loi sur les corporations commerciales

Notice of a decision to dissolve provincial corporations and to Avis d’une décision de dissoudre les corporations provinciales cancel the registration of extra-provincial corporations et d’annuler l’enregistrement des corporations extraprovin- ciales Notice of decision to dissolve provincial corporations Avis d’une décision de dissoudre les corporations provinciales Take notice that the Director under the Business Corporations Act has Sachez que le directeur, en application de la Loi sur les corporations made a decision to dissolve the following corporations pursuant to commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations sui- paragraph 139(1)(c) of the Act, as the said corporations have been in vantes en vertu de l’alinéa 139(1)c) de la Loi, puisque lesdites corpo- default in sending to the Director fees, notices, and/or documents re- rations ont fait défaut de faire parvenir au directeur les droits, avis et/ quired by the Act. Please note that 60 days after the date of publication ou documents requis par la Loi. Soyez avisé que 60 jours après la date of this Notice in The Royal Gazette, the Director may dissolve the de la publication du présent avis dans la Gazette royale, le directeur corporations. pourra dissoudre lesdites corporations.

030431 030431 (N.B.) LTD. 676332 676332 N.B. INC. 035405 ALTITUDE CONSTRUCTION CO. 041981 041981 N. B. LTD. 676614 676614 N.B. Inc. LTD/ALTITUDE CONSTRUCTION 042024 042024 N.B. INC. 676667 676667 NB Ltd. CIE LTEE 047333 047333 N.B. Ltd. 676688 676688 N.B. Ltd. 689399 Amplify Electric Ltd. 049800 049800 N.B. LTEE 676713 676713 NB LTD. 676763 Anki Ltd. 054059 054059 N.B. LTD. 682446 682446 NB Inc. 689186 Annuaire NMS Directory Inc. 059893 059893 N.-B. LTEE 682518 682518 NB INC. 052085 ANTONIO DESJARDINS TREE 502299 502299 N.-B. INC. 682535 682535 N.B. LTD. TRIMMING INC. 506956 506956 N.B. LTD. 682564 682564 NB Ltée 689721 ARC Motels Inc. 509275 509275 N. B. Ltd. 682581 682581 N.B. Inc. 689181 Asi Architectural Metals Inc. 509300 509300 N.B. Ltd. 682583 682583 NB Inc. 631572 Attention To Detail Ltd 512039 512039 N.B. LTD. 682599 682599 N.B. Ltd. 670281 AU ROCHER BOISÉ INC. 514483 514483 N.B. LTD. 682634 682634 N.B. LTD. 619245 Ava’s Ice Cream Shoppe Inc. 601338 601338 N.B. Ltd. 682665 682665 NB INC. 049754 B & B ENVIRONMENTAL SERVICES 612679 612679 NB LTD./LTÉE 682693 682693 NB Ltd. LTD. 618722 618722 N.B. Ltd. 682818 682818 N.B. Ltd. 512017 B & B INVESTMENTS LTD. 619026 619026 N.B. Ltd. 682911 682911 NB Inc. 612371 B & D Manchester Properties Ltd. 625485 625485 NB Inc. 682959 682959 N.B. Inc. 001309 B & M FISHERIES LTD. 625487 625487 NB LTD. 682967 682967 N.B. INC. 606958 B.E.J. Enterprises Ltd. 625646 625646 NB Ltd. 689245 689245 N.B. Ltd. 047461 B.L.E.N.N.D. CONSTRUCTION LTEE./ 625736 625736 N.B. Inc. 689252 689252 N.B. LTD. LTD. 631661 631661 NB Ltd. 689253 689253 N.B. Corp. 663748 BALADEC TRADING LTD. 631757 631757 NB Ltd. 689277 689277 NB LTD. 509492 BARNETT ESTATES LTD. 631763 631763 N.B. LTD. 689297 689297 NB LTD. 670700 BELLEISLE DISTILLERIES INC. 632102 632102 N.B. INC. 689388 689388 NB INC. 689248 Bent Spokes Bicycle Shop Ltd. 632153 632153 N.B. INC. 689417 689417 N.B. Ltd. 689698 BIG BANG CONSTRUCTION INC. 638124 638124 N.B. Ltd. 689423 689423 NB Inc. 683056 BIJOUX VANZIE JEWELRY LTEE/ 638197 638197 N.B. Inc. 689437 689437 N.B. Inc. LTD. 638297 638297 N.B. Ltd. 689482 689482 N.B. Inc. 625691 Bison Investments Inc. 638571 638571 N.B. LTD. 689491 689491 New Brunswick Inc. 689491 511877 BLAJ HOSPITALITY INC. 644741 644741 N.B. INC. Nouveau-Brunswick Inc. 664014 BLOCK-MONOLIT DEVELOPMENT 644932 644932 N.-B. Inc. 689504 689504 NB Ltd. LTD. 650957 650957 NB Ltd. 689555 689555 NB Ltd. 670743 Blogdata Enterprises Inc. 651018 651018 NB INC. 689558 689558 N.B. Inc. 606942 BlueGreen Information Technologies Inc. 651071 651071 N.B. Ltd. 689596 689596 NB Inc. 631978 BO Shipping Company Limited 651196 651196 NB Inc. 689597 689597 NB INC. 689367 Bowman Pharmacy Inc. 651240 651240 N.B. LTD. 689629 689629 N.B. LTD. 638556 BREAU ASPHALT INC. 651270 651270 N.B. Ltd. 689633 689633 N.B. Inc. 663830 Brian Lewis Mattress Ltd. 657443 657443 NB Inc. 689636 689636 NB LTD. 663936 Buur Fashion Canada Ltd. 657602 657602 N.B. Inc. 689652 689652 N.B. INC. 002691 C & M DISTRIBUTORS LTD. 657667 657667 N.B. Inc. 689699 689699 N.B. Inc. 047515 C. & R. HOME BUILDERS LTD. 663700 663700 N.B. Inc. 601476 877 Coverdale Road Limited 057176 C. HALL HEAVY EQUIPMENT 663943 663943 N.B. Ltd. 689206 A AND J BUCKLEY INVESTMENTS REPAIR LTD. 663963 663963 N.B. Inc. LTD. 663941 C.W.C. SALES & MARKETING 664024 664024 NB INC. 625457 A-Line Properties Inc. CONSULTING INC. 664062 664062 N.B. Ltd. 031960 A.C. TAN M.D. PROFESSIONAL 631791 CAL-SHAR & SON TRANSPORT LTD. 670265 670265 N.B. Ltd. CORPORATION 689505 Canco Logistics Inc. 670427 670427 N.-B. Ltée 000164 ABLE LEASING LTD. 689484 CANUCK SEAFOOD IMPORT & 670488 670488 NB INC. 638095 ACSiS EHR (Electronic Health Record) EXPORT (2016) LTD. 670493 670493 NB Inc. Inc. 657758 Cape Light Institute Inc. 670558 670558 N.B. LTD. 682986 Advantage Direct Cruise and Travel 676839 Castaway Golf Technologies Inc. 670565 670565 NB INC. Centre Inc. 676712 Central & Eastern Transport Corp. 670621 670621 N.B. Ltd. 619039 AJS MANAGEMENT SERVICES INC. 601084 Centre plein air d’Inkerman Ltée 670678 670678 NB LTD. 000443 ALLEN’S SERVICE STATION LTD. 631865 CHALETS MPM COTTAGES INC. 670683 670683 N.B. Ltd. 663824 Alpha-Collab Associates Inc. 657575 Chalets Tracadie Beach Inc. 670718 670718 N.B. Ltd. 682543 CHALEUR COLLEGE INC. The Royal Gazette — April 18, 2018 552 Gazette royale — 18 avril 2018

051776 CHEZ LA GUITARE INC. 054163 FUNDY BUSINESS SERVICES LTD. 054327 LEROY’S AUTO SUPPLIES LTD. 657670 Chim chimney sweeps Ltd. 504780 G & L ELECTRIC LTD. 035546 LES ENTREPRISES CENTRE-VILLE 057331 CLASSIC HEATING & AIR 670501 G. Inman Consulting Inc. LTEE CONDITIONING SERVICES LTD. 601131 G.A. Technologies Ltée/Ltd. 049771 LES GESTIONS ETTENNA INC. 619099 Climate Control Technical Services Inc. 663575 Gagnon & Gagnon Holdings Inc. 601331 Les Propriétés B.L.B. Properties Ltée/Ltd. 676730 Climbing School New Brunswick Ltd. 676695 Gagnon Plomberie Inc. 664090 Lirubem Management Services Ltd. 631802 CNB BUILDERS INC. 006922 GANONG BROS., LIMITED 650902 Little River Nursery Ltd 625305 Coates Developments Ltd. 682940 GARAGE 134 INC. 035394 LITTLE ROCK TRUCKING LTD. 689515 COCAGNE AQUACULTURE INC. 670563 GARDERIE DU DOMAINE INC. 651127 LLW CONSULTING INC. 670675 Concept Staffing Inc. 511849 Gaudet Electric Motor Repairs Inc. 638427 Lynnreed Ltd. 606902 Corazza Inc. 507018 GCP LOGEMENTS INC. 631824 MACMILLAN PROJECT 060050 CORPORATION 1906 INC. 689645 Gem Hunter Acquisitions Inc. MANAGEMENT LTD. 511884 Crawford Ironworks Inc. 663625 GEOMEDIATIX INNOVATIONS INC. 664224 MAGDD DENTURE SERVICES INC. 682642 CRC Forestry Inc. 035500 GEORGE MURRAY & SON LTD. 689366 Maillet Lawn Care Inc. 512053 CRIPPS CONSTRUCTION LTD. 689560 Germain Street Optometry Inc. 689517 MAISON EXCELLENCE 500160 CRIPPS PLUMBING & HEATING LTD. 676430 Gestion Atlantique K.B. Inc. MADAWASKA INC. 689646 Crown Point Outfitters Inc. 625531 GESTION JCH INC. 638546 Maison Tait House Inc. 514603 CRS Chemical Corp. 682449 GESTION PMC CLAIR INC. 632108 Mann Laine Investments Inc. 689471 Crusadia Marketing Inc. 007190 GLENWOOD LUMBER & 663763 Marché Denis Poitras Inc. 664110 CSR Pallets Inc. CONSTRUCTION COMPANY 689267 MATRON DEVELOPMENTS INC. 689570 Cub’s Pizza & Donair Inc. LIMITED 011717 MATTHEW MACKAY & SON LTD. 047430 CUPE (LOCAL 1190) HOLDINGS LTD. 051934 GLIDDEN SERVICE CENTER LTD. 657592 Matthew R Tingley Consulting, Ltd. 004660 D & J ROOFING LTD. 504819 GOLDEN IMAGE CENTER LTD. 512083 Matthews Seafoods Ltd. 670513 D. K. Morse Investments Inc. 689235 Golden Sunrise Services Ltd. 631947 MC2 Marketing Inc. 004684 D. P. GRAPHIK LTEE 689455 Greg Mac Realty Inc. 011245 MCEWEN’S MACHINING LTD. 657782 D.G.L. Investments Inc. 618705 Griffin Atlantic Inc. 607066 MECCO ENTERPRISES INC. 670201 DANBAR Communications Inc. 683050 GRIZZLY BEAR HOLDINGS INC. 676547 MEDCO SUPPLIES LTD. 619117 Danielle Pelletier, Speech-Language 514531 Grondin Ventilation Inc. 644493 MGM Contracteurs Inc. Pathologist Corp. 014099 H.W. McLEAN & SONS PAVING, INC. 689512 Moe’s Mini Excavating Inc. 606843 DAVIS VENTURES LTD. 007724 HAMMER HOLDINGS LTD. 689551 Mon Loup Trucking Inc. 663749 DCA MAISONS TRADITION HOMES 632109 Harding Health and Wellness Clinic Inc. 663861 MOUSSE NCL PEAT MOSS LTD. LTD. 041738 HARDWICKE VARIETY STORE LTD. 670329 MPL Home Builders Inc. 670704 DDG Inspection Services Ltd. 514600 Hart To Hart Builders Inc. 502330 MPM CONSTRUCTION INC. 644625 DEAN REDDIN LAWN & GARDEN 689301 HBDO FISHERIES LTD. 612717 Musique Guivio Music Ltee. CARE INC. 657857 HMSC Canada, Inc. 663873 MVK Canada Corp. 004895 DEMERCHANT TRUCKING LTD. 650823 Hogie’s Coffee House & Eatery Inc. 638573 N.F. Consulting Atlantic Inc 689230 DevCur Holdings Ltd. 689400 HOST Event Management Inc. 670369 Nano Technologies Inc. 676517 DF Contracting Inc. 037295 HOVEY’S CONSTRUCTION LTD. 657717 NATIONAL BASKETBALL LEAGUE 689638 Dicio Comfort Inc. 670676 ICIDICI COMMUNICATIONS OF CANADA INC. / LIGUE 511993 Dieppe Decor Inc./Décor Dieppe Inc. INCORPORATED NATIONALE DE BASKETBALL DU 676773 Dixon Valleyview Farms Inc. 631833 ILJC Enterprise Inc. CANADA INC. 650863 DLN Investments Inc. 682788 IMAGO DEVELOPMENT & DESIGN 689478 Nationsblue Retail Store Inc. 657708 Do-Mai Restaurants Inc. INC. 664114 NBG eotech & Contracting Services Inc. 689409 Dobbelsteyn Consulting Group 670324 Imprimerie A.L. Cyr Printing (2013) Inc. 663863 NCL HOLDING INC. International Inc. 676551 Industrial Packaging Line Ltd. 650852 Nettoyeur St-Coeur Dry Cleaners Inc. 625656 Douglastown Foods Inc. 670297 International Oil Sands and Shale 689351 Network Cargo Management Canada Inc. 625503 DR. DAVID CHAUT KHUON C.P. INC. Technology Limited 502359 NEW BRUNSWICK INTERNATIONAL 664154 DR. GABRIEL GIROUARD C.P. INC. 509327 INVESTISSEMENTS JMAD INC. SPEEDWAY LTD. 676576 Dr. Houssein Sabeh Osman C.P. Inc. 047584 J. Levandier Sales Inc. 511974 Newcastle Creek Convenience Ltd. 632065 Dr. James D. Leach Professional 663953 J.C. Laforest Ltd. 625374 No Rust Treasures Inc. Corporation 008705 JACKSON BROS., LTD. 606960 Noels Sprinkler Service Inc. 504825 DR. MARY C. MCCREA PROF. CORP. 612839 JAYSEE LTD. 020043 NOR-DAN VENTURES LTD. 664064 Dr. Paul D. Page Professional Corporation 689224 JCM Fisheries Ltd. 507030 NORMAND DOIRON ET FILS LTEE 670194 DRD Trucking Inc. 689628 Jeff Floyd’s Carpentry Ltd. 638600 North East Fab Inc. 625784 Dre Liette Poitras C.P. Inc. 514448 Jensen Exotic Plants Moncton Ltd. 509332 NORTH STAR SALMON LTD. 682562 Duke Holdings Inc. 632077 JEXFOUR INC. 504724 NORTHERN CARLETON TIRE LTD. 683035 DynaKor Consulting INC. 651279 JIM-CAN CONSULTING INC. 016169 Northern Gas Tech. Inc. 509281 Eagle Rock Enterprize Inc. 657846 Jin & Mi Enterprises Inc. 012416 NORTHWEST BUILDERS LTD. 049736 EASTERN PROPANE AND SUPPLIES 689371 JLAW Electric Ltd. 612591 Norton International Pharmaceutical Inc. LTD. 037468 JOMACO HOLDING INC. 676790 Ô Bon Coup d’Pouce Inc. 631898 EBNT Holdings Limited 638157 K & S Trucking Ltd. 670487 On-Site Fire Equipment Inc. 606778 ECONO ANSWERING SERVICE INC. 601400 KAILEM HOLDINGS INC. 020075 ONE HOUR PHOTO CENTRE OF N.B. 676545 EJ Excavation Ltd. 688487 Kinfolk Executive Auto Sales LIMITED 601372 EMPIRE SCREEN PRINT INC. Incorporated 663684 Orientation Santé DB Inc. 682816 ENLIGHT ELECTRICAL INC. 601090 Kings County Courier Inc. 039472 P. & R. BOUCHER CONSTRUCTION 689233 ENVISION CONSULTING LTD. 682690 Kip’s Electric Inc. LTD. 514633 ERNIE’S MARINE SALES & SERVICE 035448 KOH-I-NOR ENTERPRISES LTD. 012750 PAGE FARMS LTD. LTD. 682506 La Boîte à Fleurs (2015) Ltée 504675 PALETTES ELM CAISSIE INC. 009602 ESCORP LTD. 689530 LA P’TITE BOUCHERIE DES ILES 682992 Papy Pierre Transport Inc. 033841 FIRST REALTY COMPANY OF NEW LTEE 054285 PATRICE ENTERPRISES LTD. BRUNSWICK LTD. 682530 LANCASTER COMPUTER & 504687 PEAT MOSS HOLDINGS LTD./LES 689307 Folkins Enterprises Ltd. CELLPHONE Ltd. GESTIONS DE TOURBIERE LTEE 512091 Forensic Reconstruction Specialists Inc. 670709 LANGILLE PLUMBING & HEATING 511963 PECHERIES J.A.S. LTEE 650794 Forgotten Farm Property Management LTD. 689318 Peppercreek Pizza Company Ltd. Ltd. 512004 LARSEN’S TRUCKING LTD. 670658 PERSONALIZED CONSTRUCTION 682605 Forster Homes Inc. 689531 LE JARDIN D’ÉDEN D’ACADIE INC. MANAGEMENT INC. 509283 Foyer Martin Ltée 044851 LEBANESE PLUS INC. 657403 PIERRE LANDRY CONSULTANT INC. 664013 FRANCO PLUMBING & HEATING 625647 LEGER ROOFING AND CARPENTRY 670438 Pink Fitness for Women Inc. INC. INC. 651150 PLOMBERIE DH PLUMBING INC. The Royal Gazette — April 18, 2018 553 Gazette royale — 18 avril 2018

631680 PRECISION EXCAVATION & 514635 ROYAL MOUNTAIN NATURAL 644485 T.V. Insulators Inc. LANDSCAPING SERVICES LTD. SPRING WATER INC. 509473 TBC Consulting Group Inc. 625873 PRECISION PLUS BUILDERS LTD. 619200 RUSSELL FISHERIES LTD. 682907 Team Howard Inc. 676429 PRESTO STITCH 2014 INC. 689671 Russell Marine Brokerage Inc. 047389 TERE-FLO LIMITED 670582 Pro Bumper Moncton Inc. 631606 RYACON VENTURES INC. 670302 The Goalie Barn Ltd. 670726 Pro-Jet Maintenance Inc. 509346 SALAMANCA LANDING LTD. 007900 THE HEAD MASTERS LTD. 676439 Productions Dayo inc. 682732 Sanford Magnetics Inc. 042008 THE SEAMAN HOUSE INC. 013427 PROPERTY MAINTENANCE LTD. 682486 Savoie Plumbing & Heating Inc. 509324 THOMAS PROPERTIES LTD. 689614 Punch Branding Inc. 601171 Savoie-Doucet Bleuetières et Fermes 689432 Three D Marine Inc. 651094 Q1W Canada, Inc. Incorporée 670521 TOBIQUE AUTO LTD. 606664 R & R TUCKER HOLDINGS LTD. 625590 SAVOY & ASSOCIATES INC. 689322 TOITURES GLOUCESTER INC. 612359 R P H Homes Inc. 664057 Scott’s Special Care Home Inc. 033723 TOP TRADESMEN BUILDERS LTD. 044970 R.D.N.S. Investments Inc. 689501 SCOTTISH SKILLS CARPENTRY INC. 689278 TPO LANDSCAPING INC. 638088 R.L. Goguen Quality Home Builders Inc. 638567 SERENA PROPERTIES INC. 689523 Transition Mechanical Enterprises Inc. 676399 RALPH JUNIOR WELDING LTD. 689511 Serene Physique Inc. 651086 True Builders Ltd. 689553 Rambus Canada Inc. 031894 SERRES THERIAULT LTEE 612516 TWEEDIE & ASSOCIATES 500030 RANLYN SPECIAL ENTERPRISES 676829 Shaw Insurance Group Inc. CONSULTING ENGINEERS LTD. INC. 618827 Shikatehawk Maple Products Ltd. 676414 Two Rivers Forestry Ltd. 625738 Ravencroft Inc. 512064 SHIP TO SHORE RESTAURANT LTD. 057126 UNIVERSAL SERVICES LIMITED 606644 Ray’s Equipment Services Ltd. 689199 Signature Ventures Inc. 657300 Upwardly Mobile Marketing Inc. 676510 Red Rock Adventure Inc. 601465 SILVA TRADING INC. 682795 Utopia Ventures Ltd. 689691 Reel Shrimp Incorporated 606777 SIMONDS TAXI INC. 689481 V. MARTIN DESIGN BUILD 511941 REFLECTIONS PHOTOGRAPHY INC. 682651 SLB Entreprise Inc. COMPANY INC. 033678 REGENT ELECTRIC LTD. 676381 Smart Pan Accessories Inc. 689240 Vhernier CAN Ltd. 657310 Reidpath International Inc. 507070 SMET CONSTRUCTION LTD. 502354 VILLAGE CAPITAL CORPORATION 042023 RENE ROBICHAUD CONSTRUCTION 689452 SMOKEY AND THE FRENCHMAN 035441 W & J CRAIG HOLDINGS LTD. LTD. FOOD TRUCK INC. / LA BONNE 030375 W & R MCLELLAN LTD. 618839 Résidence Haché Inc. FRANQUETTE CAMION 500029 WELCH SURVEYS LTD. 601467 Resto Park Ltd NOURRITURE INC. 625413 WILDWOOD VENTURES LTD. 682656 Resto-Pub chez Réjean Ltée 682981 SOTGAR ENTERPRISE INC. 682769 Wilson Driveway Sealing And Snow 651198 RFR Holding Co. Ltd. 507046 South West Forest Management Inc. Removal Ltd. 607014 Richard Caron Inc. 049814 SOUTHEAST NURSERY LTD. 682596 Windy Marsh Painting & Taping Inc. 651318 RICHARD’S SEAMLESS GUTTER 689493 SOUTHERN MARINE (2016) LTD. 663724 Wingrove Hill Management Corp. INC. 502489 SOUWEST ENTERPRISES INC. 657290 WISHART POINT LODGE INC. 657521 RLI RESEARCH LOGISTICS INC. 035497 SPRINGHILL HOMES LTD. 044922 WOBO INDUSTRIES LTD. 504882 ROBERT B. JACKSON 015516 STANDARD MACHINERY AND 021286 WOODLAND ACRES LTD. PROFESSIONAL CORPORATION EQUIPMENT COMPANY, LIMITED 650798 World Net Global Switching Inc. 511886 Robert Parent Transport Ltée 606870 STORAGE CITY INC. 682978 Yanev Building Solutions Inc. 514497 Robichaud LawnCare Inc. 015675 STUDENT ACTIVITY VAN LTD. 663880 YOUR CHOICE HOME INSPECTION 676500 Robin & Grace Retail Ltd. 689309 SUE’S UPTOWN AUTO LTD. SERVICES INC. 049789 ROLAND KENNY SERVICE CENTRE 670394 Sunbury Limousine Ltd. 039517 ZARIKO BAR TERRASSE INC. LTD. 601380 SUSSEX TRUCK SALES & SERVICES 689655 Zeel Networks Canada Inc. 650615 Room for Change Inc. LTD. 638402 ZIG ZAG HOLDINGS Ltd/Ltée 612767 ROSE GARDEN ESTATES INC. 638214 T.A.C.E. Technical Services Ltd.

______

Notice of decision Avis d’une décision to cancel the registration of extra-provincial corporations d’annuler l’enregistrement des corporations extraprovinciales Take notice that the Director under the Business Corporations Act has Sachez que le directeur, en application de la Loi sur les corporations made a decision to cancel the registration of the following extra- commerciales, a pris la décision d’annuler l’enregistrement des corpo- provincial corporations pursuant to paragraph 201(1)(a) of the Act, as rations extraprovinciales suivantes en vertu de l’alinéa 201(1)a) de la the said corporations have been in default in sending to the Director Loi, puisque lesdites corporations ont fait défaut de faire parvenir au fees, notices, and/or documents required by the Act. Please note that directeur les droits, avis et/ou documents requis par la Loi. Soyez avisé 60 days after the publication of this Notice in The Royal Gazette, the que 60 jours après la date de la publication du présent avis dans la Director may cancel the registration. Gazette royale, le directeur pourra annuler l’enregistrement desdites corporations extraprovinciales.

074228 2837803 CANADA LTEE 632206 Crawford Educational Consulting Ltd. 676673 POWERTEL UTILITIES 651292 7532709 CANADA INC. 631622 energeia inc. CONTRACTORS LIMITED 650282 805855 B.C. LTD. 625729 eSolutionsGroup Limited 651194 RAIN FOR RENT CANADA ULC 682641 9260-3927 QUÉBEC INC. 076343 FERMILI INC. 689402 RELIANCE GLASS INC. 676424 9293-5261 QUÉBEC INC. 689719 GEOSOLARWIND CONSULTING INC. 676699 SERVICES DE COURTAGE 074980 ABHE & SVOBODA, INC. 657678 Grande National Leasing Inc. NATIONAL S.C.N. INC / NATIONAL 676593 All Group Financial Services Inc. 682689 GRAY AQUA GROUP LTD. BROKERAGE SERVICES S.C.N. INC. 625824 Arctic Rose Inc. 689536 GREY ROCK FOOD COURT INC. 657744 Shremshock Engineering, Inc. 670399 Ashland Canada Corp./Corporation 682971 Hackmatack Trail Racing Inc. 689447 SILVER CROSS AUTOMOTIVE INC. Ashland Canada 606820 HILLSIDE PRINT SOFTWARES LTD. 075395 SUTTER SALMON CLUB LTD. 624654 Beaudry & Cadrin Inc. 689421 Houseco Holdings Inc. 018755 SUZY SHIER (CANADA) LIMITED 638217 Bingham Group Services Corp. 663982 J.D. BOIS INC. 612835 TeleCheck Services Canada, Inc. 638522 CARQUEST CANADA LTD. 670545 Kindle Capital Management Inc. 070111 THE DIEBOLD COMPANY OF CARQUEST CANADA LTEE 663853 MAURICE SPORTING GOODS, INC. CANADA LIMITED 670178 Centinel Services Ltd. 601344 Novitex Enterprise Solutions Canada, Inc / 689392 VIRTUAL BROKERS WEALTH 657587 COMMERCIAL INSURANCE Solutions d’Entreprise Novitex Canada, MANAGEMENT INC. BROKERS INC. Inc. 682716 WGI Service Plan Division Inc. 644627 COTSYN CANADA INC. 676393 OLOFSFORS INC. The Royal Gazette — April 18, 2018 554 Gazette royale — 18 avril 2018

Companies Act Loi sur les compagnies

Notice of decision to dissolve provincial companies Avis d’une décision de dissoudre les compagnies provinciales Take notice that the Director under the Companies Act has made a de- Soyez avisé que le directeur, en application de la Loi sur les compa- cision to dissolve the following companies pursuant to paragraph gnies, a pris la décision de dissoudre les compagnies suivantes en vertu 35(1)(c) of the Act, as the said companies have been in default in send- de l’alinéa 35(1)c) de la Loi, puisque lesdites compagnies ont fait dé- ing to the Director fees, notices, and/or documents required by the Act. faut de faire parvenir au directeur les droits, avis et/ou documents re- Please note that 60 days after the date of publication of this Notice in quis par la Loi. Soyez avisé que 60 jours après la date de la publication The Royal Gazette, the Director may dissolve the companies. du présent avis dans la Gazette royale, le directeur pourra dissoudre lesdites compagnies.

663715 Amicale Scouts Guides District 606992 DIVINE MERCY CATHOLIC SCHOOL 670747 New Brunswick Continuing Care Safety Edmundston Inc. INC. Association Inc. / Association de 024741 ASSOCIATES OF THE PROVINCIAL 006029 EXPOSITION REGIONALE DU sécurité des soins continus du Nouveau- ARCHIVES OF NEW BRUNSWICK MADAWASKA INC. Brunswick Inc. INC. 644801 Fédération des motos hors route du 022906 NEWCASTLE HOUSING 025124 ASSOCIATION DES ANCIENS-NES ET Nouveau-Brunswick Inc. / New CORPORATION INC. AMIS-ES DE LA POLYVALENTE Brunswick Off Road Motorcycle 638147 Northwest Off Road Club Inc. THOMAS-ALBERT INC. Federation Inc. 023756 OAKHILL PARK HOLDINGS INC. 601100 Association des universités du troisième 025300 FEDERATION OF DANCE CLUBS OF 682800 Petites éponges sur roues Inc. âge du Nouveau-Brunswick inc. NEW BRUNSWICK INC. 025457 PLEASANT VALLEY CEMETERY 650738 Association Étudiante des Arts du Centre 006508 Fredericton Apartment Owners PRESERVATION SOCIETY, INC. Universitaire de Moncton Inc. Association Inc. 013384 PRODUCTION DE L’ETOILE INC. 021596 Association of Consulting Engineering 023222 GRAND FALLS POTATO FESTIVAL 025607 Project Management Institute New Companies of New Brunswick Inc. / INC. Brunswick Chapter Inc. Association des firmes d’ingénieurs- 000878 L’ASSOCIATION DES SCOUTS DU 022632 QUEENS COUNTY HERITAGE conseils du Nouveau-Brunswick inc. CANADA - DISTRICT DE INCORPORATED 689410 Atlantic Emergency Services Games Ltd. MONCTON INC. 022153 RESTIGOUCHE COUNTY 023479 BOISJOLIS OWNERS ASSOCIATION 635582 L’Association du Handball Olympique du VOLUNTEER ACTION INC. / L’ASSOCIATION DES Nouveau-Brunswick Inc. ASSOCIATION INC. PROPRIETAIRES DE BOISJOLIS 015331 LA SOCIETE HISTORIQUE DE 632185 ROTHESAY LANDINGS ESTATES INC. GRANDE-DIGUE INC. INC. 024194 CAMPBELLTON FIRE BRIGADE INC. 021591 LES ARCHERS D’EDMUNDSTON 024746 RURAL EMERGENCY RESPONSE 689575 CANADIAN CONCUSSION INC. GROUP INC. INSTITUTE INC. 618826 LILY LAKE PAVILION INC. 689390 SAINT JOHN TALLSHIPS 2017 INC. 682435 CENTRE COMMUNAUTAIRE 631268 Living Faith Center Inc. 025743 Salle de l’Évangile de Shédiac Inc./ ISLAMIQUE D’EDMUNDSTON INC. 657815 LOCAL 362 - BREWERY & SOFT Shédiac Gospel Hall Inc. / ISLAMIC COMMUNITY CENTER DRINK WORKERS INC. 014536 ST. ANDREWS BURIAL VAULT OF EDMUNDSTON INC. 024757 LONGVIEW PARK HOMEOWNERS COMPANY INC. 689414 Centre d’activité La Source Ltée. INC. 014684 ST. MARK’S LODGE F. & A. M. N.O. 5 022904 Centre de Réadaptation Cardiaque René 010112 LUDLOW AND PORTER COVE 014696 ST. PATRICK’S FAMILY CENTRE INC. Boucher Inc. RECREATION ASSOCIATION INC. 644171 Sussex Committee for the Prevention of 023753 CLUB DE L’AGE D’OR CHAL BAIE 023747 MAIN STREET REDEVELOPMENT Family Violence Inc. (Beresford) Inc. SACKVILLE INC. 021858 SUSSEX LIONS VILLA INC. 024902 CLUB DES TOUT-TERRAIN DE 021882 MIRAMICHI SALMON MUSEUM INC. 021885 THE COMMUNITY LIVING BOARD - KEDGWICK INC. 682760 Miramichi Triathlon Club Inc. FUNDY REGION INC. 023421 COLES ISLAND SENIOR CITIZENS 601392 New Brunswick Breast and Women’s 025282 The Endowment Fund of the United Way CLUB INC. Cancer Partnership Inc. / Le partenariat of Central N.B. Inc. / Fonds de Dotation 689415 Comité de gestion de l’Auditorium du cancer du sein et des cancers de la Centraide - Region du Centre du N- Richelieu Inc. féminins du Nouveau-Brunswick inc. B, Inc. 689537 Comité organisateur de la 38e Finale des 022907 NEW BRUNSWICK CHORAL 025299 THE SAINT JOHN NATURALISTS Jeux de l’Acadie 2017 Inc. FEDERATION/LA FÉDÉRATION CLUB INC. 632140 COMITE ORGANISATION DES CHORALES DU NOUVEAU- 023173 THE SHOGOMOC HISTORICAL AND RECREATIONEL PAROISSIAL LTEE BRUNSWICK INC. MODEL RAILROAD CLUB INC. 022368 CRESCENT HOLDINGS INC. 689210 West Region Soccer Association Inc. The Royal Gazette — April 18, 2018 555 Gazette royale — 18 avril 2018

Partnerships and Business Loi sur l’enregistrement des Names Registration Act sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

TAKE NOTICE that, pursuant to sections 12.3 and 12.31 of the Part- SACHEZ QUE, conformément aux articles 12.3 et 12.31 de la Loi sur nerships and Business Names Registration Act R.S.N.B., 1973, c. P-5, l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations com- the Registrar under the said Act intends to cancel the registration of the merciales, L.R.N.-B. de 1973, ch. P-5, le registraire a l’intention, en certificates of partnership of the firms set forth in Schedule “A” an- vertu de ladite loi, d’annuler l’enregistrement des certificats de sociétés nexed hereto and the certificates of business names of the businesses en nom collectif indiquées à l’annexe « A » ci-jointe et des certificats set forth in Schedule “B” annexed hereto by reason of the fact the said d’appellations commerciales des commerces indiqués à l’annexe « B » firms and businesses have failed to register certificates of renewal in ci-jointe, en raison du fait que ces firmes ou commerces ont négligé de accordance with paragraph 3(1)(b) or (c) or subsection 3.1(2) or 9(7), faire enregistrer des certificats de renouvellement conformément à as the case may be applicable, of the said Act. l’alinéa 3(1)b) ou c) ou au paragraphe 3.1(2) ou 9(7) de ladite loi, selon le cas.

FURTHER TAKE NOTICE that at any time after the expiration date of SACHEZ AUSSI qu’en tout temps après la date d’expiration de trente thirty (30) days from the date of publication of this Notice, the Regis- (30) jours à partir de la date de publication du présent avis, le registraire trar may cancel the registration of the said certificates of partnerships peut annuler l’enregistrement desdits certificats de sociétés en nom and certificates of business names. collectif et certificats d’appellations commerciales.

Schedule “A” / Annexe « A » Certificates of Partnerships / Certificats de sociétés en nom collectif

669531 Acre End Partnership 669223 Gait-Way Kennels 669304 HILLSAPLENTY FARMS 669439 Bingham Law / Bingham Droit 600609 Gould’s Gardens & Design 669231 La Petite Pause Bed & Breakfast 669094 Bubbalous Buy & Trade 669072 GROVE LOUNGE 669082 RatingBay

Schedule “B” / Annexe « B » Certificates of Business Names / Certificats d’appellations commerciales

669010 720 LEADERSHIP INSTITUTE 631463 Big Pond Carpentry 631430 CLARKE CAPITAL MANAGEMENT 669158 A & A Immigration Solutions 631085 BILL’S HOME MAINTENANCE 631518 Clinique Dentaire Chaleur 341570 ACTIVE LOCKSMITHING 669344 Billings Drywall 669433 Clinique Massanie 669144 Adorkable Couture 669318 Bistro 140 631142 Community Phsychology Resource 331063 ADRIEN’S HAIR STYLING 637269 Blanchet Consultation Center 631072 Advantage Ads 669407 BLUE CEDARS 669587 CRISTI SHOES 668833 Agence Wade 669480 Bonedigger Animation Studio 669405 Crooked Brook Farm 669129 ALA Marketing 631498 Bookworm Preschool 669438 Crossfit Xclusive 669221 ALL ABOARD CONVENIENCE 669128 BPS Clearing 669123 Custom Embroidery Plus 631058 All Season Sunrooms 631575 BRASSERIE La Hutte Enrg. 631030 D. Perry Motors 669131 ALO Marketing 631285 Bridal Vision 668997 D.C.’S MOWING 669431 Alpha Nerds Media 669066 Brunswick Removal Service 669108 Daisyfield Card Creations 669285 Alyssa Martin Photography 668983 Bug Box Weddings & Events 669469 Dalhousie Lighthouse bistro 669327 Analysis to Action Strategic Consulting 669178 CALDERS PLUMBING 669570 Davey’s Outdoor Emporium 669524 ANAO ENTRETIEN DE GAZON 631527 CANARIBBEAN 631284 DAY’S MASONARY 668992 Annand Accounting Services TELECOMMUNICATIONS 669591 Delightfully Delicious Sushi 631384 Armurerie Bruno Cyr Gunsmith CONSULTING 669122 DENTS BE GONE 669563 AT-TRAVELERS 668936 Capital City Computer and Media 625229 Dépanneur Val D’Amour 669250 ATELIER DUKA Solutions 669247 Dependable Drywall 2013 669199 Atlantic Business Immigrant Network - 669586 CARA SHOES 669581 Division mondiale de l’approvisonnement Réseau d’Immigrants en Affaires 669145 Carnelia Stones & Crystals 669137 DKM Clearing Atlantique 669220 Carolina Dorrington Hills Hunt Club 669212 DogWatch Maritimes 669484 Atlantic Holistic Directory 669001 CEDAR VALLEY SPRINGS 669092 Dretech Renovation 631287 ATLANTIC ROOF TRUSS 669274 CG Group 669507 DRUNK POET RESTAURANT 631286 ATLANTIC TRUSS 669343 Chaleur Personal Shoppers 669608 DUNLAP’S TRUCKING 631060 Aubes Restaurant Maintenance & Repair 668986 CHANDIA IMEX ENTERPRISES 630642 Dunnet’s Cleaning 669519 B & H Auto Body & Sales 669523 CHASE’S LANDSCAPING 631113 Eagle’s Nest Gifts 669366 Baby Love Birth Services 669455 CHEEKY NAIL STUDIO 669457 Earthlings Child Care Centre 669225 Bailey’s Winter Services 669154 Chickadee Larder Gourmet Condiments 600602 Eastern Chinese Superstore 669552 Bang-On Photography 669317 Chris Odd Crew 669316 ECO506 Enterprise / Entreprise ECO506 669420 BATMO Enterprises 668372 Chris Tingley’s Auto Parts and Recycling 631204 Ecoability 606345 BAYER CROPSCIENCE 341633 CHRIS’ HAIR CARE 669600 Elsipogtog One Stop Pawn Shop 606351 BAYER CROPSCIENCE CANADA 669018 Christian Boucher Mechanical 669606 EMC PUBLICATIONS AND MEDIA 351546 BERNARD’S SECURITY ACCESS 669065 Cinnamon Soul Café and Bakery 669609 Energy Hour Productions The Royal Gazette — April 18, 2018 556 Gazette royale — 18 avril 2018

669277 EPICERIE THERIAULT GROCERIES 631395 MAPLE VALLEY CONSTRUCTION 669594 Riverview Stepping Stones Wee College 669049 Euler Hermes Canada 669494 Maritime Mortgage Solutions Too 669254 Fair Play Hockey 669074 Marr Property Investments 669597 Riverview Stepping Stones Youth Center 669319 FARNSWORTH EXTERIORS 631439 MasterTracks 669544 RLS (REAL ESTATE LISTING 669423 Fine Finish Fredericton 631133 ME by Bonnie SERVICES) 669541 FLS (FREDERICTON LISTING 669130 MHB Clearing 668985 Rob’s Mobile Diagnostics & Repairs SERVICES) 669605 Milestone Condominiums 338614 ROTHESAY AVENUE PLAZA 669125 FOUNDATION FOOTCARE 600571 Mitch Stephens INT’L 631183 ROYAL LEPAGE METRO 668987 FOYER CHEZ LINE MORRISON 669124 MITCHELL MARTIN PLUMBING 669214 RSK Concrete Finishing 669542 FREB (FREDERICTON REAL ESTATE 669281 Motilal Diesel Fuel Injection Systems 600191 Saint John RV Show N’Sale BULLETIN) 669474 MRP Pro Steam Pressure Wash 669422 Salon J.Ade 669332 Frequent Seas Productions 669226 MUTTS ABOUT MONCTON DOG 631160 SAM THE JUICE MAN 669216 FUSION CLEARING TRAINING SERVICES 669217 SANCTITY CLEARING 669449 G & T Decorators 669330 MY PET CENTER (CODIAC) 669106 Sapper Consulting 669421 GARDERIE LES PETITS RAYONS DE 669367 MYPCsupport.ca 669492 Sea Shell Restaurant SOLEIL 669312 NATASHA’S DJ SERVICES 669545 SEARCH ATLANTIC.COM 669033 GCP Strategies 637323 NATIONAL BANK 631470 SERMAX BATHURST ENRG. 669132 GDS Clearing CORRESPONDENT NETWORK 669146 Shades of Beauty Aesthetics 631302 GLENN’S FAMILY RESTAURANT 343876 NEATE COMPUTER SERVICES 669546 Shediac Psychological Service / Services 631267 GOOD FORTUNE CHINESE FOOD 669381 Night Hawk Towin psychologiques de Shediac TAKE-OUT 669358 Ninety Five Degrees Café & Gifts 631239 Shipley’s Landscaping 669164 Gorham Apiary 343758 NORTH EAST HOLDINGS 669352 Signed Tania / Signé Tania 669139 GPC Division 669050 Northern Kings Tire 669257 Simple Liberty Mobile Hearing Care 669279 Greer’s Electrical 631521 Ô PUB 631255 Smart Accounting Service 669180 HAMPTON PAWS 631020 Oak Lawn Images 669537 SMB Security 669287 HANSCOM’S AUTO BODY 669368 One Hundred Acre Homestead 600652 Smooth as Silk 669557 Hazy Daisy Doodles & Poodles Kennel 669363 Operational Detachment Atlantic Airsoft 669445 SOUND OFF ALARM SYSTEMS 669462 Healthy Home Cleaning 624433 Oromocto Day Care Center 669361 Start Communications 669282 Healthy Smiles Mobile Dental Hygiene 669611 Orthophonie Chaleur Speech-Language 631545 Stellart consultant Web Services Pathology 669309 Sylvette Shine Services 669183 HIGH-TECH WINDSHIELD REPAIR 669540 Oscar’s Firewood 669043 T. Cook’s Brakes & Service 669126 Highway 55 Events 351648 P.C. OYSTERS ENR 351552 TAZ TIMBER 669520 HIRE A PRO 631348 Paladin Bailiff Services 669100 Ten Resto 669359 Inspir3D Printing 669323 Panache & Profits Sales Consultant 637582 Teratekk Technologies 669476 INSTREAK CONSULTING 351584 PAPA’S WORKSHOP 669383 Terrific Treats & Catering 668999 INSULCAN 638025 PATTISON FINANCIAL GROUP 636963 The Palate Restaurant 611792 INTER-AG - A DIVISION OF BAYER 669218 Paul Davis Systems of Southern New 668940 THE VILLAGERS CHORUS CROPSCIENCE Brunswick 669300 TILED TREASURES 669079 Intimate Sensations 669362 PAWS Above The Rest 637395 Tim Mittons Home Improvements 669134 IPC Finance 631238 Pawzazz Pet Grooming 351420 TINA’S TOTS DAYCARE 600394 J. L. Racing 669580 Pfizer Global Supply 669002 TK-QC Technical Services 631540 J.Cormier Taping & Plastering 669258 PJC Mechanical 669278 Top Chicken & Bar 669478 J.L. Owens Ventilation & Renovation 663303 PlanSmart Building 669454 Top of the Hill Motors 669162 James Towing 631460 PLOURDE BODY SHOP 669483 Topsail Canvas 631190 Jardin de la coiffure LeClair 669543 PLS (PROVINCIAL LISTING 669078 Traduction Paulin Translation 669372 Jason & Ashley GraphX SERVICES) 669324 TRIPLE C TRANSPORT 606068 Jim & Jenn Connollys Firewood 631254 Polished to Perfection 669558 UM SERVICE 669256 Jireh Media 631440 poppy press 669598 VanWart Insurance Financial Service 669120 JL JOHNSON VENTURES 669404 Powered By An Extra Chromosome 631337 Verico Cormier & Cormier Consultants 669518 JLD McIsaac Enterprises Promotions 669266 Vicent Immigration Consulting Services 669034 KBCO Management Gestion 669133 PPD Marketing 669456 VIDEOBAND 669102 KELLY’S PERFECTLY POLISHED 669528 PRESTIGE LIGHTING 669099 View of the Bay Dining Room TIPS N TOES 669346 Productions Portamento 669192 Walker Farms, Millstream, N.B. 669461 KIF BAYSIDE 669599 Puroclean Services of Moncton 600900 Wall Construction Services 669320 Kitchen Boss & Custom Wood Working 669601 Rainbows & Dreams Daycare 631114 Weathered Ways 669246 Lakeville Village Convenience 669328 RAINFOREST CURES 669596 Wee College Connection 669063 Laluna Yoga 637220 Real Living Fellowship 631353 WEL-BUILT 669491 LANDMARK ON DOUGLAS 669087 REDOWL CONSULTING 631516 Westfield Road Auto Repair 669136 LAO Finance 669083 Rental Hunter Atlantic 669430 WILSHAW CONSTRUCTION 631520 LE VIEUX POÊLE STEAKHOUSE 631181 RESTIGOUCHE CHALEUR 669138 WIN Clearing 669029 Léo Goguen Architecture HATCHERY/PISCICULTURE 669417 WISDOM OF OIL 344274 LES PRODUITS HORTICOLES LAMIS RESTIGOUCHE CHALEUR 669140 WJ Clearing ENRG. 669406 Resto Grec Royal 669230 Wood in Motion 669554 Little Rascals Daycare 668027 Richard Property Maintenance Services 669272 World Washer Toss Championship 669141 LM Clearing 669005 Rick Dean Trucking 669512 Wudi Ventures 669127 LMS Clearing 600190 RIEDEL’S WOODWORKING 669135 WWA Finance 668834 Locations 3DM Rentals 669157 River Valley Garden Equipment 631040 Youngevity 631141 M&M Workshops 669369 Riverstone Day Spa 669487 Your Corporate VA 669121 MANCHESTER CONSTRUCTION 669595 Riverview Stepping Stone Wee College 669373 Your Life Alight Studio 668984 Mandy’s Apparel & More The Royal Gazette — April 18, 2018 557 Gazette royale — 18 avril 2018

Loi sur les corporations Business Corporations Act commerciales PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commer- tions Act, a certificate of incorporation has been issued to: ciales, un certificat de constitution en corporation a été émis à : Reference Number Date Registered Office Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

Marc Losier Wood Harvesting Ltd. Tracadie-Sheila 701628 2018 03 23 Swipe This Way Apps Inc. Fredericton 701635 2018 03 22 Pike Family Corporation Fredericton 701636 2018 03 22 MAXI Pizzeria Mobile Inc. Cocagne 701637 2018 03 22 ADVANCED FIRE CONSULTING INC. Codys 701642 2018 03 23

Marwood International Ltd. Fredericton 701643 2018 03 23 PIERRE REGACHE TRUCKING INC. Dieppe 701644 2018 03 23 701645 NB Inc. Fredericton 701645 2018 03 23 701647 NB INC. Piercemont 701647 2018 03 23 River City Real Estate Ltd. Moncton 701649 2018 03 23 McAdam Hot Glass Inc. Fredericton 701653 2018 03 23 Jost Consulting Ltd. Midgic 701654 2018 03 23 Ladio Real Estate Inc. Moncton 701656 2018 03 23 Shire Foods Inc. New Horton 701657 2018 03 23 Dr. Hafeez Awan Professional Corporation Saint John 701658 2018 03 23 Elm City Mechanical Inc. Fredericton 701659 2018 03 23 SONNY SQ HOLDINGS INC. Lutes Mountain 701660 2018 03 23 Lotus QPP Services Ltd. Dieppe 701661 2018 03 23 Acronym Canada Inc. Saint John 701662 2018 03 23 701664 NB Inc. Moncton 701664 2018 03 23 Elegance Bridal Design Yannie Inc. Shediac Cape 701665 2018 03 24 ROGUE Grappling Industries Inc. Saint John 701667 2018 03 24 701668 NB Corp. Balmoral 701668 2018 03 24 La Ferme Nikkal Inc. Pokemouche 701673 2018 03 25 PLOURDE & SONS FORESTRY LTD. McAdam 701680 2018 03 26 Henk’s Quality Produce and Feeds Ltd. Drummond 701681 2018 03 26

Northside Tree Services Limited Fredericton 701685 2018 03 26 DLP Installateur de Toiture de Métal Ltée Bas-Caraquet 701687 2018 03 26 701688 N.B. Ltd. Quispamsis 701688 2018 03 26 The Royal Gazette — April 18, 2018 558 Gazette royale — 18 avril 2018

CSJV PanCan Industrial LP, Inc. Saint John 701689 2018 03 26 CSJV PanCan Industrial GP, Inc. Saint John 701690 2018 03 26 Stéphane & Jeannine Holdings Inc. Dieppe 701691 2018 03 26 G. D. M. TRANSPORT (2018) LTD. Néguac 701701 2018 03 26 701702 N.B. Ltd. Saint John 701702 2018 03 26 Dr. Ariadna Grigoriu Medicine Professional Corporation Moncton 701703 2018 03 26 701704 N.B. Inc. Moncton 701704 2018 03 26 Sharp Stables Inc. Roachville 701705 2018 03 26 WIREDSCORE CANADA LTD. Fredericton 701707 2018 03 26 TWL Buildings & Construction Ltd. Charlo 701708 2018 03 26 HANNAGE DEVELOPEMENT LTD. Titusville 701711 2018 03 27 AMJ Professional Tax & Accounting Services Corp. Moncton 701716 2018 03 27

701725 N.-B. Inc. Edmundston 701725 2018 03 28 701734 N.B. LTD. Canterbury 701734 2018 03 28 ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpo- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, rations Act, a certificate of continuance has been issued to: un certificat de prorogation a été émis à : Previous Reference Jurisdiction Number Date Registered Office Compétence Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Bureau enregistré antérieure référence année mois jour

3191034 NOVA SCOTIA LIMITED Port Elgin Nouvelle-Écosse / 701683 2018 03 26 Nova Scotia ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of amendment has been issued to: un certificat de modification a été émis à :

Date Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

C.T.R. TIRE (N.B.) LTD. 042295 2018 03 27 CRAIN FARMS LTD. 044664 2018 03 23 AB SEAFOOD SPECIALISTS INC. 619340 2018 03 27 DAY & NIGHT HOLDINGS LTD. 624010 2018 03 23 Wyndham Hotels & Resorts Canada, Inc. 624976 2018 03 28

MIRRER HALL INVESTMENTS INC. 678011 2018 03 27 693386 NB INC. 693386 2018 03 27 C.K. Art & Design Ltd. 698331 2018 03 26 699303 N.B. Inc. 699303 2018 03 23 The Royal Gazette — April 18, 2018 559 Gazette royale — 18 avril 2018

Somers Enterprises Inc. 700514 2018 03 28 701361 N.B. Inc. 701361 2018 03 28

NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUM Business Corporations Act / Loi sur les corporations commerciales

In relation to a certificate of amendment issued on July 31, 2014, under the name of “Dr. Lance MW Schaefer and Dr. M. Dicks Professional Corporation”, being corporation #677823, notice is given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of amend- ment correcting the corporation number on the Certificate and Articles of Amendment.

Sachez que, relativement au certificat de modification délivré le 31 juillet 2014 à « Dr. Lance MW Schaefer and Dr. M. Dicks Professional Cor- poration », dont le numéro de corporation est 677823, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat corrigé de modifi- cation corrigeant le numéro de corporation sur le Certificat et les Statuts de modification. ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of amendment which includes a change in un certificat de modification contenant un changement de raison name has been issued to: sociale a été émis à :

Date Previous name Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Ancienne raison sociale Numéro de référence année mois jour

049780 NB INC. G. D. M. TRANSPORT LTD. 049780 2018 03 27 ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of dissolution has been issued to: un certificat de dissolution a été émis à : Reference Number Date Registered Office Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

LAMEQUE READY-MIX LIMITEE Lamèque 039980 2018 03 22 DAIGLE’S APPRAISAL INC. Edmundston 050429 2018 03 26 Terence Wall Trucking Inc. Riverview 655294 2018 03 28 Cloudlinx Hosted Services Inc. Fredericton 661515 2018 03 27 RDP Ventures Ltd. Quispamsis 667900 2018 03 26 670082 NEW BRUNSWICK INC. Saint John 670082 2018 03 23 EQNet Communications Inc. Fredericton 680903 2018 03 22 Cleaning 2 Perfection Services Ltd. Valley Road 687310 2018 03 22

NOTICE / AVIS Business Corporations Act / Loi sur les corporations commerciales

The Certificate of Dissolution respecting STEFF TRUCKING INC. (Corporation # 690122) issued on July 12, 2017, is hereby declared invalid and void ab initio pursuant to an Order of The Court of Queen’s Bench of New Brunswick dated November 6, 2017, Cause # BM/36/17.

Sachez que le certificat de dissolution relatif à « STEFF TRUCKING INC. » (corporation no 690122) délivré le 12 juillet 2017 a été frappé de nullité ab initio par une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en date du 6 novembre 2017 dans l’affaire no BM/36/17. ______

The Certificate of Dissolution respecting Carboni Bistrot Inc. (Corporation # 677981) issued on November 18, 2016, is hereby declared invalid and void ab initio pursuant to an Order of The Court of Queen’s Bench of New Brunswick dated February 27, 2017, Cause # MM/25/2017. The Royal Gazette — April 18, 2018 560 Gazette royale — 18 avril 2018

Sachez que le certificat de dissolution relatif à « Carboni Bistrot Inc. » (corporation no 677981) délivré le 18 novembre 2016 a été frappé de nullité ab initio par une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en date du 27 février 2017 dans l’affaire no MM/25/2017. ______

The Certificate of Dissolution respecting JOHN’S ELECTRIC LTD. (Corporation # 008838) issued on October 18, 2011, is hereby declared invalid and void ab initio pursuant to an Order of The Court of Queen’s Bench of New Brunswick dated October 1, 2017, Cause # EM/14/17.

Sachez que le certificat de dissolution relatif à « JOHN’S ELECTRIC LTD. » (corporation no 008838) délivré le 18 octobre 2011 a été frappé de nullité ab initio par une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en date du 1er octobre 2017 dans l’affaire no EM/14/17. ______

The Certificate of Dissolution respecting Natasha Theresia De Sousa Professional Corporation (Corporation # 653795) issued on January 29, 2018, is hereby declared invalid and void ab initio pursuant to an Order of The Court of Queen’s Bench of New Brunswick dated March 19, 2018, Cause # SJM/18/2018.

Sachez que le certificat de dissolution relatif à « Natasha Theresia De Sousa Professional Corporation » (corporation no 653795) délivré le 29 jan- vier 2018 a été frappé de nullité ab initio par une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en date du 19 mars 2018 dans l’affaire no SJM/18/2018. ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of revival has been issued to: un certificat de reconstitution a été émis à :

Date Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

DR. W. E. PICKETT PROFESSIONAL CORPORATION 501623 2018 03 22 VisscherHolland Canada Inc. 663320 2018 03 22 Oromocto Town Taxi Ltd. 669265 2018 03 26 679886 N.B. Inc. 679886 2018 03 23 21st Century Natural Approach Ltd. 681527 2018 03 22 ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of registration of extra-provincial corporation un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a été has been issued to: émis à : Reference Number Date Jurisdiction Agent and Address Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Compétence Représentant et adresse référence année mois jour

1076505 B.C. LTD. Colombie-Britannique / R. Scott Wilson 700902 2018 03 28 British Columbia Saint John FINAMARK GROUP INC. Nouvelle-Écosse / Jude Cormier 701524 2018 03 26 Nova Scotia Aulac PNEUMATIC HEALTHCARE Canada Louis Poirier 701531 2018 03 19 SOLUTIONS INC. Caraquet CRE-O-PACK ATLANTIC INC. Canada Louis LeBlanc 701553 2018 03 20 Moncton

Canada RealTech Fluid Control Canada Xuemin Zhao 701583 2018 03 21 Equipment Corporation Fredericton PT ENTERPRISES INC. Île-du-Prince-Édouard / Stewart McKelvey Corporate 701594 2018 03 21 Prince Edward Island Services (NB) Inc. Saint John The Royal Gazette — April 18, 2018 561 Gazette royale — 18 avril 2018

THE FOLDING CHAIR GROUP Canada McInnes Cooper CSD 701602 2018 03 21 LIMITED Services Inc. Fredericton

DAEDONG CANADA INC. Colombie-Britannique / Stewart McKelvey Corporate 701614 2018 03 22 British Columbia Services (NB) Inc. Saint John FOUR DOGS BREWING COMPANY Alberta Stewart McKelvey Corporate 701617 2018 03 22 LTD. Services (NB) Inc. Saint John Markers Financial Inc. Canada Stewart McKelvey Corporate 701618 2018 03 22 Services (NB) Inc. Saint John Lgc4 Investissements Inc. Canada Martin Dugas 701624 2018 03 22 Caraquet BP LUBRICANTS USA INC. Delaware Deborah M. Power 701629 2018 03 22 Fredericton OCEANIC PROPERTIES INC. Canada McInnes Cooper CSD 701632 2018 03 22 Services Inc. Fredericton SnapSuite Inc. Canada McInnes Cooper CSD 701633 2018 03 22 Services Inc. Fredericton

HYDROPLUMB MECHANICAL LTD. Canada Cox & Palmer Corporate 701640 2018 03 23 Services NB Inc. Saint John DSB CLAIMS SOLUTIONS INC. Ontario Acadian Complete Corporate 701648 2018 03 23 Care Inc. Fredericton MCCASLIN HORNE INSURANCE Ontario Arthur Doyle 701695 2018 03 26 BROKERS INC. Saint John 10499757 Canada Ltd. Canada Arthur Doyle 701696 2018 03 26 Saint John FIRST REPUBLIC CAPITAL Ontario McInnes Cooper CSD 701706 2018 03 26 CORPORATION Services Inc. Fredericton

NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUM Business Corporations Act / Loi sur les corporations commerciales

In relation to a certificate of registration issued March 17, 2017, under the name of “FALCON SHUTTLE RAIL INC.”, being corporation #694901, notice is given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of registration, correcting the directors on the Statement of Registration. Sachez que, relativement au certificat d’enregistrement délivré le 17 mars 2017 à « FALCON SHUTTLE RAIL INC. » dont le numéro de corpo- ration est 694901, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat corrigé corrigeant les administrateurs sur la Déclaration d’enregistrement. ______The Royal Gazette — April 18, 2018 562 Gazette royale — 18 avril 2018

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of amendment of registration of extra- un certificat de modification de l’enregistrement de corporation provincial corporation has been issued to: extraprovinciale a été émis à : Reference Number Date Previous name Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Ancienne raison sociale référence année mois jour

Bervin Wealth and Insurance Solutions Inc. Bervin Capital Management Inc. 681156 2018 03 22 Bervin solutions d’assurance et de gestion du Gestion du capital Bervin Inc. patrimoine Inc. DWF CLAIMS (CANADA) LIMITED TRITON GLOBAL CANADA LTD. 681987 2018 03 20

______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, tions Act, a certificate of registration of amalgamated corporation un certificat d’enregistrement d’une corporation extraprovinciale has been issued to the following extra-provincial corporations: issue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales sui- vantes : Reference Agent and Address Number Date Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Représentant et Numéro de Year Month Day Corporation issue de la fusion Corporations fusionnantes adresse référence année mois jour

SERVICE CORPORATION SERVICE CORPORATION Stewart McKelvey Corporate 701534 2018 03 19 INTERNATIONAL INTERNATIONAL Services (NB) Inc. (CANADA) ULC (CANADA) ULC Saint John UNIVINS ET SPIRITUEUX TANDEM WINES ATLANTIC INC. Stewart McKelvey Corporate 701551 2018 03 20 (CANADA) VINS TANDEM ATLANTIQUE Services (NB) Inc. INC. UNIVINS AND SPIRITS INC. Moncton (CANADA) INC. FLSMIDTH LTD. FLSMIDTH LTD. Stewart McKelvey Corporate 701692 2018 03 26 Services (NB) Inc. Saint John GLOBAL FUELS INC. Global Fuels Inc. Stewart McKelvey Corporate 701693 2018 03 26 Services (NB) Inc. Fredericton

Companies Act Loi sur les compagnies PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act, SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres letters patent have been granted to: patentes ont été émises à : Reference Number Date Head Office Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Siège social référence année mois jour

WORSHIP IMPACT Group inc. Moncton 701699 2018 03 26 ______The Royal Gazette — April 18, 2018 563 Gazette royale — 18 avril 2018

PUBLIC NOTICE is hereby given that the charter of the following SACHEZ que la charte de la compagnie suivante est reconstituée company is revived under subsection 35.1(1) of the Companies Act: en vertu du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les compagnies :

Date Reference Number Year Month Day Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

THE GREATER MONCTON SUNRISE ROTARY CLUB INC. / 665982 2018 03 26 CLUB ROTARY SUNRISE DU GRAND MONCTON INC. ______

Loi sur l’enregistrement des Partnerships and Business Names sociétés en nom collectif et des Registration Act appellations commerciales PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en Business Names Registration Act, a certificate of business name has nom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appel- been registered: lation commerciale a été enregistré : Registrant of Address of Business Reference Certificate or Agent Number Date Enregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

Painting & Reno by D & D (2018) Deborah Riley Dieppe 701323 2018 03 07 True Gents Barbershop Kurtis Morris Saint John 701392 2018 03 12 Love Four Paws Canine Elana Goldberg Hanwell 701472 2018 03 15 Rehabilitation Therapy Confetti Jouets et Antiquités Gilles Sauvé Campbellton 701504 2018 03 19 R & B Dobson Homes R & B Dobson Holdings Ltd. Sackville 701506 2018 03 23 11.11 REALTY GROUP Partnership Saint John Saint John 701552 2018 03 20 Selecting Inc Fundy Coast Maintenance 698441 NB Ltd. Gardner Creek 701554 2018 03 20 WellNurtureMD WellNurture Custom Moncton 701558 2018 03 20 Health Inc. Arborvitae Tree of Tammy Firlotte Johnville 701567 2018 03 20 Life & Wellness DataNomia Consulting / Consultance Bernard Thiry Moncton 701574 2018 03 21 14 1/2 Café & Bar CONNECTIONS BISTRO INC. Saint John 701585 2018 03 21 Griffin’s Journey Heather Lister Rusagonis 701589 2018 03 21 Psychological Services GC MARINE Gerald Robichaud Saint-Louis 701591 2018 03 21 Docu Guard Docu Guard Ltd. Saint John 701592 2018 03 21 Shred Guard Docu Guard Ltd. Saint John 701593 2018 03 21

GIBSON DENTAL CLINIC Dr. Andrea Duncan Prof. Corp. Fredericton 701607 2018 03 21 Kioti Tractor DAEDONG CANADA INC. Saint John 701615 2018 03 22 Kioti DAEDONG CANADA INC. Saint John 701616 2018 03 22 The Royal Gazette — April 18, 2018 564 Gazette royale — 18 avril 2018

Sea Salt Media Paul Robertson Quispamsis 701631 2018 03 22 Ez Eco Shop Shawna Berthe Moncton 701634 2018 03 22 Danika Vautour Art and Decor Danika Vautour Saint John 701638 2018 03 22 Shear Talent Hairstyling SARA MARINO Saint John 701639 2018 03 23 MAXIMUM FORCE CLEANING 700300 N.B. INC. Miramichi 701641 2018 03 23 Authentic You Discovery and Jennifer Carpenter-Gleim Fredericton 701646 2018 03 23 Healing Off The Ground Imaging Adam Lee Bubartown 701651 2018 03 23 LADY A CRAFTS & SUPPLIES AMELIA WARD Rothesay 701652 2018 03 23 Elements of Balance Wellness Angela Russell Saint John 701655 2018 03 23 OCEAN BREEZE RESTAURANT Sally Mazerolle Bathurst 701666 2018 03 24 Choix multiple & réparation bijoux / Gaston Savoie Bathurst 701669 2018 03 24 Multiple Choice & Jewelry Repair Jess Neary Feng Shui Jessica Neary Passekeag 701670 2018 03 24 Zetti Stones Don Merzetti Saint John 701671 2018 03 24 Breathing Serenity Holistics Denise Bouchard Fredericton 701674 2018 03 26 Westlund & Friends Dayhome Julia Sloane MacDonald Rusagonis 701679 2018 03 26 Black mac pressure seal Rebecca Turgeon Saint-Leonard-Parent 701686 2018 03 26 Omni Health Deborah M. Hansen Fredericton 701694 2018 03 26 Infiniti Tattoos & Piercing Studio Natalie Breau Moncton 701700 2018 03 26 BIXAM & VEDIS CONSULTING Xavier Mues Saint-Jacques 701709 2018 03 26 TIMBER & STEEL FURNITURE JOHN MOORE Saint John 701712 2018 03 27 OUTFITTERS Savage Cinema Nathan Savage Kingston 701713 2018 03 27 AUTHENTIC BAY OF FUNDY PAT DUNN St Martins 701719 2018 03 27 TOURS Boletus Gourmet Stephanie Rheault Scoudouc 701720 2018 03 27 ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en Business Names Registration Act, a certificate of renewal of business nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re- name has been registered: nouvellement d’appellation commerciale a été enregistré : Registrant of Address of Business Reference Certificate or Agent Number Date Enregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

ALL SECURE DANNY S DOUCETTE Long Reach 334651 2018 03 26

ONE STOP T & T REPAIR ABRAM PLANT Irishtown 340900 2018 03 26 Brunswick News Brunswick News Inc. Saint John 344683 2018 03 26 Nouvelles Brunswick Inc. Salon R.J. Savoie SERVICE CORPORATION Saint John 345301 2018 03 19 INTERNATIONAL (CANADA) ULC The Royal Gazette — April 18, 2018 565 Gazette royale — 18 avril 2018

MAHER’S FUNERAL HOMES SERVICE CORPORATION Saint John 350593 2018 03 19 INTERNATIONAL (CANADA) ULC

SALON FUNERAIRES MAHER SERVICE CORPORATION Saint John 350594 2018 03 19 INTERNATIONAL (CANADA) ULC Custom Canopy and Tents Larry Keirstead Lower Coverdale 351282 2018 03 22 SALONS FUNERAIRES MAHER SERVICE CORPORATION Saint John 353165 2018 03 19 INTERNATIONAL (CANADA) ULC FIDUCIE CONSEIL AVANTAGE BMO Trust Company Fredericton 604329 2018 03 20 ADVISOR’S ADVANTAGE TRUST BMO Trust Company Fredericton 604330 2018 03 20 RESCUE BUILDING CLEANERS Gabrielle LeBlanc Shediac 606504 2018 03 21 Salons funéraires Maher’s Funeral SERVICE CORPORATION Saint John 611510 2018 03 19 Home INTERNATIONAL (CANADA) ULC

CHEZ-VOUS ENTREPÔT Marcel Marquis Saint-Hilaire 630456 2018 03 25 Moncton RV Centre 602495 N.B. Inc. Moncton 630798 2018 03 21 WTP ASSIST WORLD TRAVEL PROTECTION Fredericton 637769 2018 03 27 CANADA INC./PROTECTION MONDIALE DE VOYAGE CANADA INC. Maher’s Crematorium SERVICE CORPORATION Saint John 655639 2018 03 19 INTERNATIONAL (CANADA) ULC CGM Denture Clinic Clarence Gregory Marks Fredericton 656475 2018 03 20 TILE YOUR WORLD FLOORING Murray Robert Sawler Lakeville 667884 2018 03 25 Rubix Technologies Éric Bélanger Edmundston 668344 2018 03 26

Virginia’s General Store Carrie Dedam Première nation de Burnt 668380 2018 03 23 Church / Burnt Church First Nation Full Circle Academy Indoor Sports Management Moncton 668598 2018 03 26 Group Ltd. Down Right Scrappers Cyril McLellan Riverview 668715 2018 03 28 Simply Fabulous Hair Salon Lisa Paulin South Tetagouche 668750 2018 03 20 Linda’s Perfect Ten Nail Salon Linda Allain Riverview 668757 2018 03 23 DSC’s Kitchen Donald Carroll Shediac 668830 2018 03 24 LE UP’N DOWN RESTO-BAR ENTREPRISE KIMO INC. Pokemouche 668910 2018 03 23 Developpement et Loisir De Roland Gauvin Petite-Lamèque 669089 2018 03 26 Petique-Lameque Glonia Gauvin Nadia Gionet Garderie La P’Tite Luciole Suzie Althot Savoie Campbellton 669625 2018 03 20

EFI Global Cunningham Lindsey Canada Saint John 669748 2018 03 26 Claims Services Ltd. Forensic Advisory Services Cunningham Lindsey Canada Saint John 669750 2018 03 26 Claims Services Ltd. The Royal Gazette — April 18, 2018 566 Gazette royale — 18 avril 2018

EWJ Crafts Erma Jones Rusagonis 670061 2018 03 26 SAVOUR IN THE GARDEN NEPI ENTERPRISES LIMITED St Andrews 670431 2018 03 26 KASAKAYAK FRANCE BEAULIEU St-Joseph-de-Madawaska 670680 2018 03 26 GREATER MONCTON CHINESE Mingkun Gu Moncton 672386 2018 03 22 CULTURAL ASSOCIATION Xuesong Guo Yukun Zhou Ziwei Wang Yan Xu Univins et Spiritueux UNIVINS ET SPIRITUEUX Moncton 694743 2018 03 20 (CANADA) INC. UNIVINS AND SPIRITS (CANADA) INC. Univins and Spirits UNIVINS ET SPIRITUEUX Moncton 694744 2018 03 20 (CANADA) INC. UNIVINS AND SPIRITS (CANADA) INC. ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en Business Names Registration Act, a certificate of cessation of busi- nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessa- ness or use of business name has been registered: tion de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation com- merciale a été enregistré : Reference Number Date Address / Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Adresse référence année mois jour

R & B Dobson Homes Sackville 649589 2018 03 23 SABMILLER CANADA Saint John 669399 2018 03 27 Plourde Logging McAdam 689239 2018 03 27 Gibson Street Dental Clinic Fredericton 699320 2018 03 21 Petitmor Family Alpacas Harcourt 700326 2018 03 21 Shred Guard Saint John 701443 2018 03 21 Docu Guard Saint John 701444 2018 03 21 ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en Business Names Registration Act, a certificate of change of agent for nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de chan- service has been registered: gement d’un représentant pour fin de signification a été déposé :

Reference Number Date Agent and Address / Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Représentant et adresse référence année mois jour

Tri-State Motor Transit Deborah M. Power 606627 2018 03 22 Fredericton

______The Royal Gazette — April 18, 2018 567 Gazette royale — 18 avril 2018

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en Business Names Registration Act, a certificate of partnership has nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de so- been registered: ciété en nom collectif a été enregistré : Address of Business Reference or Agent Number Date Adresse du commerce Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Partners / Membres ou du représentant référence année mois jour

Petitmor Family Alpacas Barton Charles Petley Harcourt 701584 2018 03 21 Janet Leigh Plume-Petley Ferme Vert L’Éveil Pascal Landry Black Rock 701590 2018 03 21 Sandra Arseneault ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en Business Names Registration Act, a certificate of renewal of part- nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re- nership has been registered: nouvellement de société en nom collectif a été enregistré : Address of Business or Agent Reference Adresse du Number Date commerce ou Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Partners / Membres du représentant référence année mois jour

DHS Investment Duc Luong’s Holdings Inc. Dieppe 661747 2018 03 27 AIM Holdings Inc. NPT Holdings Inc. Pivotal Input MATHIS SOLUTIONS LTD. Fredericton 663998 2018 03 28 Pivotal Assets Ltd. ______

Limited Partnership Act Loi sur les sociétés en commandite

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une ship Act, a declaration of limited partnership has been filed by: déclaration de société en commandite a été déposée par :

Principal place in Reference New Brunswick Number Date General Partners Principal établissement au Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Commandités Nouveau-Brunswick référence année mois jour

Midtown Capital Limited Partnership Highline Investments Ltd. Saint John 701555 2018 03 20 ______

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner- SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une ship Act, a declaration of withdrawal of extra-provincial limited déclaration de retrait de société en commandite extraprovinciale a partnership has been filed: été déposée par : Reference Agent and Address Number Date Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month Day Name / Raison sociale Compétence et adresse référence année mois jour

Keystone Communities II Limited Manitoba Allison J. McCarthy 637370 2018 03 20 Partnership Fredericton ______The Royal Gazette — April 18, 2018 568 Gazette royale — 18 avril 2018

Notices of Sale Avis de vente

Sale of Lands Publication Act, Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces R.S.N.B. 1973, c. S-2, s. 1(2) L.R.N.-B. 1973, chap. S-2, paragr. 1(2) To David James Button and Laura Anne Button, original Mort- Destinataires : David James Button et Laura Anne Button, dé- gagors, and to all others whom it may concern. Sale pursuant to biteurs hypothécaires originaires; et tout autre intéressé éven- terms of the Mortgage and the Property Act R.S.N.B., 1973, tuel. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypo- c.P-19 and Acts in amendment thereof. Freehold property being thèque et de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, chap. P-19, situated at 68 Falcon Crescent, Saint John, New Brunswick, the avec ses modifications successives. Biens en tenure libre situés same lot conveyed to David James Button and Laura Anne But- au 68, croissant Falcon, à Saint John, au Nouveau-Brunswick, ton by Transfer registered in the Land Titles Office on July 30, et correspondant au même lot ayant été transféré à David 2013, as number 32942188. James Button et Laura Anne Button par l’acte de transfert enre- gistré au bureau de l’enregistrement foncier le 30 juillet 2013, sous le numéro 32942188. Notice of Sale given by The Bank of Nova Scotia. Sale to be Avis de vente donné par la Banque de Nouvelle-Écosse. La held at Saint John Court House, located at 10 Peel Plaza, Saint vente aura lieu le 3 mai 2018 à 11 h, heure locale, au palais de John, New Brunswick, on the 3rd day of May, 2018, at the hour justice de Saint John, 10, place Peel, Saint John (Nouveau- of 11:00 a.m., local time. See advertisement of Notice of Sale in Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions du 5, 12, the Telegraph-Journal dated April 5, 12, 19 and 26, 2018. 19 et 26 avril 2018 du Telegraph-Journal.

McInnes Cooper, Solicitors for The Bank of Nova Scotia, Kathryn Stratton, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Per: Kathryn Stratton, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Banque de Nouvelle-Écosse, Centre de la Croix Bleue, 644, rue Suite S400, P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C Main, bureau S400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) 8T6. Telephone: 506-857-8970. Facsimile: 506-857-4095. E1C 8T6. Téléphone : 506-857-8970. Télécopieur : 506-857-4095

______

TO: MARIE GISÈLE DUGUAY, of Tracadie-Sheila, County DESTINATAIRES : MARIE GISÈLE DUGUAY, de Tracadie- of Gloucester and Province of New Brunswick; Sheila, comté de Gloucester et province du Nouveau-Brunswick; “Mortgagor” « Débiteur hypothécaire » AND ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN. ET TOUTES PERSONNES INTÉRESSÉES. Freehold property situate at Tracadie, in the County of Glouces- Biens en tenure libre situés à Tracadie, dans le comté de ter and Province of New Brunswick. Notice of sale given by La Gloucester et la province du Nouveau-Brunswick. Avis de vente Caisse Populaire Acadienne Ltée, formerly known as the Caisse est donné par Caisse populaire acadienne ltée, (anciennement Populaire de Sheila Ltée, Mortgagee. Sale in the lobby of the connue sous le nom de Caisse populaire de Sheila ltée), créancière main entrance of the Tracadie Town Hall, located at 3267 Prin- hypothécaire. La vente aura lieu au vestibule de l’entrée principale cipale Street, Tracadie, in the County of Gloucester and Prov- de l’hôtel de ville de Tracadie, situé au 3267, rue Principale, ince of New Brunswick, on Wednesday, May 2, 2018, at 10:00 Tracadie, comté de Gloucester, province du Nouveau-Brunswick, a.m., local time. See advertisement in L’Acadie Nouvelle. le mercredi, 2 mai 2018, à 10 h, heure locale. Voir l’annonce pu- bliée dans le journal L’Acadie Nouvelle.

MARCO ROBICHAUD C.P. INC. MARCO ROBICHAUD C.P. INC. 8 Du Voilier Street, Caraquet, N.B. E1W 1A4. Telephone: 506- 8, rue du Voilier, Caraquet (N.-B.) E1W 1A4 727-5555. Fax: 506-727-2783. Solicitor for the Mortgagee Téléphone : 506-727-5555. Télécopieur : 506-727-2783. Avocat de la créancière hypothécaire The Royal Gazette — April 18, 2018 569 Gazette royale — 18 avril 2018

Notice to Advertisers Avis aux annonceurs

The Royal Gazette is published every Wednesday under the La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformé- authority of the Queen’s Printer Act. Documents must be re- ment à la Loi sur l’Imprimeur de la Reine. Les documents à ceived by the Royal Gazette coordinator, Legislative Services, publier doivent parvenir au coordonnateur de la Gazette no later than noon, at least seven days prior to Wednesday’s royale, aux Services législatifs, à midi, au moins sept jours publication. Each document must be separate from the cover- avant le mercredi de publication. Chaque avis doit être séparé ing letter. Signatures on documents must be immediately fol- de la lettre d’envoi. Les noms des signataires doivent suivre lowed by the printed name. The Royal Gazette coordinator immédiatement la signature. Le coordonnateur de la Gazette may refuse to publish a document if any part of it is illegible, royale peut refuser de publier un avis dont une partie est illi- and may delay publication of any document for administrative sible et retarder la publication d’un avis pour des raisons ad- reasons. ministratives. Prepayment is required for the publication of all documents. Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis. Standard documents have the following set fees: Voici les tarifs pour les avis courants :

Cost per Coût par Notices Insertion Avis parution

Notice of the intention to apply for the enactment of a $20 Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loi 20 $ private bill d’intérêt privé Originating process $ 25 Acte introductif d’instance 25 $ Order of a court $ 25 Ordonnance rendue par une cour 25 $ Notice under the Absconding Debtors Act $20 Avis exigé par la Loi sur les débiteurs en fuite 20 $ Notice under the General Rules under the Law Society Act, $20 Avis de radiation ou de suspension ou de demande de 20 $ 1996, of disbarment or suspension or of application for réintégration ou de réadmission, exigé par les Règles reinstatement or readmission générales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur le Barreau Notice of examination under the Licensed Practical Nurses $25 Avis d’examen exigé par la Loi sur les infirmières et 25 $ Act infirmiers auxiliaires autorisés Notice under the Motor Carrier Act $30 Avis exigé par la Loi sur les transports routiers 30 $ Any document under the Political Process Financing Act $20 Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur le 20 $ financement de l’activité politique Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9 $20 Avis aux créanciers exigé par le Règlement du Nouveau- 20 $ under the Probate Court Act Brunswick 84-9 établi en vertu de la Loi sur la Cour des successions Notice under Rule 70 of the Rules of Court $120 Avis exigé par la Règle 70 des Règles de procédure 120 $ Note: Survey Maps cannot exceed 8.5″ x 14″ Nota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 po sur 14 po Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is $20 Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voie 20 $ 1/2 page in length or less d’annonces, si l’avis est d’une demi-page ou moins en longueur Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is $75 Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voie 75 $ greater than 1/2 page in length d’annonces, si l’avis est de plus d’une demi-page en longueur Any document under the Winding-up and Restructuring Act $20 Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur les 20 $ (Canada) liquidations et les restructurations (Canada) Notice of a correction charge is Avis d’une correction les frais sont the same as les mêmes que for publishing ceux imposés the original pour la document publication du document original Any other document $3.50 for each Tout autre document 3,50 $ pour cm or less chaque cm ou moins

Payments can be made by cash, MasterCard, VISA, cheque or Les paiements peuvent être faits en espèces, par carte de money order (payable to the Minister of Finance). No refunds crédit MasterCard ou VISA, ou par chèque ou mandat (à will be issued for cancellations. l’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation.

The official version of The Royal Gazette is available free La version officielle de la Gazette royale est disponible gra- on-line each Wednesday. This free on-line service replaces the tuitement en ligne chaque mercredi. Ce service gratuit en printed annual subscription service. The Royal Gazette can be ligne remplace le service d’abonnement annuel. Vous trouve- accessed on-line at: rez la Gazette royale à l’adresse suivante : The Royal Gazette — April 18, 2018 570 Gazette royale — 18 avril 2018

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/ attorney_general/royal_gazette.html procureur_general/gazette_royale.html

Print-on-demand copies of The Royal Gazette are available, at Nous offrons sur demande des exemplaires de la Gazette the following address, at $4.00 per copy plus 5% tax, plus royale à l’adresse suivante pour la somme de 4 $ l’exemplaire, shipping and handling where applicable. plus la taxe de 5 % ainsi que les frais applicables de port et de manutention.

Notice: The telephone number for The Royal Gazette has Avis : Le numéro de téléphone de la Gazette royale a changé. changed. Please see below. Prière de voir ci-dessous.

Legislative Publishing Publications législatives Office of the Attorney General Cabinet du procureur général Chancery Place Place-Chancery 675 King Street 675, rue King P.O. Box 6000 C.P. 6000 Fredericton, NB E3B 5H1 Fredericton (N.-B.) E3B 5H1

Tel: 506-453-2520 Tél. : 506-453-2520 E-mail: [email protected] Courriel : [email protected]

Note: Deliveries are to be addressed to The Royal Gazette and Note : Toute livraison étant adressée à la Gazette royale doit left with the commissionaire. être remise au commissionnaire.

Statutory Orders and Ordonnances statutaires et Regulations Part II Règlements Partie II The Royal Gazette — April 18, 2018 571 Gazette royale — 18 avril 2018

NEW BRUNSWICK RÈGLEMENT DU REGULATION 2018-26 NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-26

under the pris en vertu de la

PROTECTED NATURAL AREAS ACT LOI SUR LES ZONES NATURELLES (O.C. 2018-92) PROTÉGÉES (D.C. 2018-92)

Filed March 28, 2018 Déposé le 28 mars 2018

1 Schedule II of New Brunswick Regulation 2003-8 1 L’annexe II du Règlement du Nouveau- under the Protected Natural Areas Act is amended by Brunswick 2003-8 pris en vertu de la Loi sur les zones repealing Schedule II-28.1 and substituting the at- naturelles protégées est modifiée par l’abrogation de tached Schedule II-28.1. l’annexe II-28.1 et son remplacement par l’an- nexe II-28.1 ci-jointe. The Royal Gazette — April 18, 2018 572 Gazette royale — 18 avril 2018

SCHEDULE II-28.1 / ANNEXE II-28.1

QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés